CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03114683 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
- Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Hitachi Vantara Limited Sefton Park SL2 4HD Stoke Poges Buckinghamshire United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CAMBRIDGE MANAGEMENT CONSULTING HOLDINGS LIMITED | 10 giu 1998 | 10 giu 1998 |
PETER CHADWICK HOLDINGS LIMITED | 19 ott 1995 | 19 ott 1995 |
PCH INVESTMENTS LIMITED | 11 ott 1995 | 11 ott 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
legacy | 82 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 2 pagine | GUARANTEE2 | ||
Cessazione della carica di Elena Gifon come amministratore in data 31 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2021 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Cessazione di Celerant Consulting Acquisitions Limited come persona con controllo significativo il 10 mag 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||
Notifica di Hitachi Consulting Uk Limited come persona con controllo significativo il 10 mag 2021 | 2 pagine | PSC02 | ||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata C/O Hitachi Vantara Limited Sefton Park Stoke Poges Buckinghamshire SL2 4HD | 1 pagine | AD04 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Fifth Floor, Forum, St. Paul's Gutter Lane London EC2V 8AS England a C/O Hitachi Vantara Limited Sefton Park Stoke Poges Buckinghamshire SL2 4HD in data 05 lug 2021 | 1 pagine | AD01 | ||
Nomina di Darryl Hector Coulter come amministratore in data 01 gen 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di David John Brindle come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 25 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Elena Gifon come amministratore in data 22 set 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Peter Lynn come amministratore in data 22 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio modificato redatto al 31 mar 2019 | 25 pagine | AAMD | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 25 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 ago 2019
| 8 pagine | SH01 | ||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||
Stato del capitale al 02 set 2019
| 5 pagine | SH19 | ||
Chi sono gli amministratori di CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODMAN, Steven | Segretario | Sefton Park SL2 4HD Stoke Poges C/O Hitachi Vantara Limited Buckinghamshire United Kingdom | 189986880001 | |||||||
COULTER, Darryl Hector | Amministratore | Sefton Park SL2 4HD Stoke Poges C/O Hitachi Vantara Limited Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 277026640001 | ||||
GLYN, Malcolm Adam | Segretario | 1 Pagoda Avenue TW9 2HQ Richmond Surrey | British | 20411250003 | ||||||
ROBINSON, Ronald Anthony | Segretario | 29 Birchdale Road Forest Gate E7 8AS London | British | 38680820001 | ||||||
VON KUNITZKI, Nathalie | Segretario | 5 Rue De La Tombe Issoire FOREIGN Paris 75014 France | British | 121943950001 | ||||||
BAER, Quentin James Frank | Amministratore | Malverley East End RG20 0AA Newbury | British | Company Director | 80273970001 | |||||
BRINDLE, David John | Amministratore | St. Paul's Gutter Lane EC2V 8AS London Fifth Floor, Forum, England | England | British | Senior Vice President | 91289800003 | ||||
CLARKSON, Ian Peter | Amministratore | Dartmouth Place W4 2RH London Dartmouth House | United Kingdom | British | Company Director | 10472070003 | ||||
COLLETT, Brian | Amministratore | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | Company Director | 32267100002 | |||||
DOHMEN, Gabriel Gerardus | Amministratore | De Ginckellaan 6 1272 Rm Huizen Holland | Dutch | Company Director | 37983150001 | |||||
DUNNABACK, John Russell | Amministratore | Queen Anne Drive West Bloomfield Michigan 7043 48322 Usa | United States Of America | United States | Cao And Cfo | 139131830001 | ||||
ELLISON, Martin Edward | Amministratore | Avalon House 72 Lower Mortlake Road TW9 2JY Richmond | England | British | Chief Financial Officer | 97753620001 | ||||
FOSTER, Ronald Charles | Amministratore | 1530 Hillview Drive Los Altos California 94024 Usa | Us | Director | 79114080001 | |||||
FOUNTAIN, Ian Richard | Amministratore | Avalon House 72 Lower Mortlake Road TW9 2JY Richmond | United Kingdom | British | Alternate Director | 161205860001 | ||||
FRIEDMAN, Alan | Amministratore | 4 Butterfield Lane Westford Ma 01886 | American | Executive | 77216890001 | |||||
GAVIN JR, John J | Amministratore | 62 Countryside Dr Cumberland Rhode Island 02864 Us | United States | Sr Vice Pres | 72695020001 | |||||
GIFON, Elena | Amministratore | Sefton Park SL2 4HD Stoke Poges C/O Hitachi Vantara Limited Buckinghamshire United Kingdom | Switzerland | German | Finance Controller | 279458510001 | ||||
GLYN, Malcolm Adam | Amministratore | 1 Pagoda Avenue TW9 2HQ Richmond Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 20411250003 | ||||
HERRICK, Kathryn Louise | Amministratore | 94 Broom Road TW11 9PF Teddington Middlesex | United Kingdom | British | Cfo | 76110680001 | ||||
LASALA JR, Joseph A | Amministratore | 27 Robin Road Weston Massachusetts 02493 Us | United States | Sr Vice President | 72694680002 | |||||
LINSALATA, Ralph | Amministratore | 20 Surrey Lane Weston Massachusetts 02493 Us | United States | Exec Vice President | 72694580001 | |||||
LYNN, Andrew Peter | Amministratore | St. Paul's Gutter Lane EC2V 8AS London Fifth Floor, Forum, England | United Kingdom | British | Accountant | 179769880001 | ||||
MEAD, Tim | Amministratore | 33 Allen Road Wellesley Massachusetts 02181 Us | United States | Sr Vice Pres | 72694850001 | |||||
MESSMAN, Jack Leroy | Amministratore | 100 Westcliff Road Weston Ma 02493 Usa | American | Executive | 67280100002 | |||||
O'BRIEN, John Michael, Mr. | Amministratore | 13-15 Bouverie Street EC4Y 8DP London Harmsworth House England | England | British | Management Consultant | 141719710001 | ||||
SHAHEEN, Issam Allen | Amministratore | 8 Cambridge Centre Cambridge Ma 02142 Usa | Usa | Consultant | 61115490003 | |||||
SIMS, James K | Amministratore | 304 Vassar Street Cambridge Ma 02139 Usa | Usa | Ceo & President | 61115470001 | |||||
SJOSTEDT, Anders Patrik | Amministratore | 2 More London Riverside SE1 2AP London Hitachi Consulting Uk Limited England | Sweden | Swedish | Management Consultant | 172770320001 | ||||
TIBBETTS, Joseph Simeon Jr | Amministratore | 116 Farm Street MA02030 Dover Massachusetts | Usa | Cfo | 89449530001 | |||||
TOSCANINI, Arthur | Amministratore | 100 Westcliff Road Westondge Ma 02493 Usa | Usa | Ceo | 61115540002 | |||||
VAN D'HUYNSLAGER, Danny | Amministratore | Winkelputstraat 7 Merendree 9850 Belgium | Belgian | President | 128837740001 | |||||
WATSON, Alexander Ernest | Amministratore | 72 Lower Mortlake Road TW9 2JY Richmond Avalon House Surrey United Kingdom | England | British | Chairman | 18239870002 | ||||
WATSON, Alexander Ernest | Amministratore | Mullion Cottage Deadhearn Lane HP8 4HG Chalfont-St-Giles Buckinghamshire | England | British | Advisor | 18239870002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi Consulting Uk Limited | 10 mag 2021 | Sefton Park SL2 4HD SL2 4HD Stoke Poges C/O Hitachi Vantara Limited Buckinghamshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Celerant Consulting Acquisitions Limited | 06 apr 2016 | Hitachi Consulting SE1 2AP London 2 More London Riverside England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CELERANT CONSULTING HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A pledge agreement | Creato il 18 ago 2011 Consegnato il 27 ago 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each security provider to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Right, title and interest in and to the pledged stock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 mag 2006 Consegnato il 01 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each security provider to the finance parties, or any of them, on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0