CARDCAST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARDCAST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03119366
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARDCAST LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CARDCAST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARDCAST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARDCAST PLC04 apr 199604 apr 1996
    CARDCAST INFORMATION SYSTEMS LIMITED22 feb 199622 feb 1996
    SHELFCO (NO.1144) LIMITED27 ott 199527 ott 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARDCAST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per CARDCAST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 pagineLIQ MISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 lug 2017

    8 pagineLIQ03

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    14 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    17 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 lug 2016

    7 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 lug 2015

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Red House Brookwood Woking Surrey GU24 0BL a 7 More London Riverside London SE1 2RT in data 21 lug 2015

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 27 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 gen 2015

    Stato del capitale al 03 gen 2015

    • Capitale: GBP .4
    SH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 set 2014

    • Capitale: GBP 2,498,467
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Cessazione della carica di Neshia Batchasingh come segretario in data 11 set 2014

    2 pagineTM02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 18 set 2014

    • Capitale: GBP 0.40
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account and cancellation of capital redemption reserve 18/09/2014
    RES13

    Cessazione della carica di Neshia Michelle Batchasingh come amministratore in data 12 ago 2014

    2 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Ricardo Caupers come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2013

    Stato del capitale al 25 nov 2013

    • Capitale: GBP 647,802
    SH01

    Chi sono gli amministratori di CARDCAST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAUPERS, Ricardo
    King Street
    SW1Y 6RT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    King Street
    SW1Y 6RT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomPortuguese188764420001
    GIUSEPPETTI, Fabio Massimo
    15 Crick Road
    OX2 6QL Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    15 Crick Road
    OX2 6QL Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomItalian115927050001
    AINSWORTH-MORRIS, Richard
    21 Sarek Park
    NN4 9YA Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    21 Sarek Park
    NN4 9YA Northampton
    Northamptonshire
    British80972840001
    AMOS, Richard John
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    British67950460002
    BATCHASINGH, Neshia
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    Segretario
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    169879280001
    COOKE, Oliver Charles
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    Segretario
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    British3643340001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    British45345090004
    GOOD, Thomas William
    Kyndling
    39a Cobbetts Walk
    GU24 9DU Bisley
    Surrey
    Segretario
    Kyndling
    39a Cobbetts Walk
    GU24 9DU Bisley
    Surrey
    British21310620003
    HAYES, Kevin Andrew
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    Segretario
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    British29737760001
    MARCHANT, Elizabeth Jane
    10 Harelands Close
    Horsell
    GU21 4NX Woking
    Surrey
    Segretario
    10 Harelands Close
    Horsell
    GU21 4NX Woking
    Surrey
    British62140800001
    POOLEY, Graham Neil
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    Segretario
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    British38288020001
    WIGHTMAN, Iain Charles
    65 Marefield
    Lower Earley
    RG6 3DZ Reading
    Berkshire
    Segretario
    65 Marefield
    Lower Earley
    RG6 3DZ Reading
    Berkshire
    British81324370001
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Segretario nominato
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    AMOS, Richard John
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish67950460002
    BATCHASINGH, Neshia Michelle
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    Amministratore
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    United KingdomBritish150222160001
    CALLAHAN, Stephen James
    The White House
    Charney Bassett
    OX12 0EU Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    The White House
    Charney Bassett
    OX12 0EU Wantage
    Oxfordshire
    British59241360001
    CAUNTER, Nicholas John
    Appletrees 7 Lashmere
    Copthorne
    RH10 3RR Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    Appletrees 7 Lashmere
    Copthorne
    RH10 3RR Crawley
    West Sussex
    British100149070001
    CLUMP, Carlyle Cyril
    Block 11
    Portomaso
    PTM 01 St Julians
    Apartment 1112
    Malta
    Amministratore
    Block 11
    Portomaso
    PTM 01 St Julians
    Apartment 1112
    Malta
    MaltaBritish61613210002
    COOKE, Oliver Charles
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    Amministratore
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    United KingdomBritish3643340001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish45345090004
    GOOD, Thomas William
    5 Burnet Close
    GU24 9PB West End
    Surrey
    Amministratore
    5 Burnet Close
    GU24 9PB West End
    Surrey
    British21310620004
    NEVILLE, Roger Drummond
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritish35529130001
    PARSONS, Robert Michael Featherstonehaugh
    Three Hills House
    Epwell
    OX15 6LG Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Three Hills House
    Epwell
    OX15 6LG Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish51846740001
    POOLEY, Graham Neil
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    Amministratore
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    British38288020001
    POULTON, Christopher
    Wildbarn 1a Brookside
    Orwell
    SG8 5TQ Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Wildbarn 1a Brookside
    Orwell
    SG8 5TQ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish65823790001
    RAVEN, Brian Kenneth
    Foxwood 10 Badgers Hill
    GU25 4SB Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Foxwood 10 Badgers Hill
    GU25 4SB Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish156746380001
    RICHARDSON, Ernest Arthur
    19 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    19 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish5161170001
    TURNER, Matthew Charles
    Springfield Hall
    Star Lane Knowl Hill
    RG10 9UR Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Springfield Hall
    Star Lane Knowl Hill
    RG10 9UR Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish115927000001
    WHITTAKER, Nigel
    176 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 3BU London
    Amministratore
    176 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 3BU London
    British65180900001
    WHITTAKER, Nigel
    176 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 3BU London
    Amministratore
    176 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 3BU London
    British65180900001
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Amministratore delegato nominato
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    CARDCAST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    New jersey law pledge agreement
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 26 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A first security interest in the collateral see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 set 2012
    Consegnato il 22 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An accession deed
    Creato il 23 feb 2007
    Consegnato il 15 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all real property by way of first fixed charge all shares all dividends interest sand other monies and each of its accounts by way of assignment the proceeds of any claim under any insurance policy and all related rights and all rights and claims in relation to any assigned account by way of floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Stock pledge agreement
    Creato il 11 gen 2000
    Consegnato il 28 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any and all present and future sums obligations and liabilities of retail decisions PLC (the parent) and any other group company nominated as an additional borrower by the parent if any to the chargee under or in connection with the credit agreement or any of the other financing documents and all liabilities of the pledgor (the company) under the pledge
    Brevi particolari
    The pledged collateral which means 100 shares of common stock no par value in transaction billing resources inc and all cash securities dividends proceeds and other property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture made between the company and national westminster bank PLC (the security trustee)
    Creato il 11 gen 2000
    Consegnato il 17 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whether present and future, actual or contingent due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 19 feb 1998
    Consegnato il 20 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilites whether present or future actual or contingent which may at the date of the debenture or at any time thereafter be or become owing or incurred by the company to the chargee as security trustee,issuing bank and the banks under or pursuant to any of a credit agreement dated 23RD january 1998,a fees letter,and any guarantees and any debenture executed as security for any of the obligations and liabilities of the company and the other companies within the same group under any of the foregoing documents (together the "financing documents") (the "secured obligations")
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CARDCAST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 lug 2015Inizio della liquidazione
    13 dic 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0