CARDCAST LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CARDCAST LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03119366 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARDCAST LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CARDCAST LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 7 More London Riverside SE1 2RT London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARDCAST LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CARDCAST PLC | 04 apr 1996 | 04 apr 1996 |
| CARDCAST INFORMATION SYSTEMS LIMITED | 22 feb 1996 | 22 feb 1996 |
| SHELFCO (NO.1144) LIMITED | 27 ott 1995 | 27 ott 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARDCAST LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Quali sono le ultime deposizioni per CARDCAST LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Domanda di insolvenza Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl | 4 pagine | LIQ MISC | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 lug 2017 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 14 pagine | 600 | ||||||||||
Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale | 17 pagine | LIQ10 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 lug 2016 | 7 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Red House Brookwood Woking Surrey GU24 0BL a 7 More London Riverside London SE1 2RT in data 21 lug 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 set 2014
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Neshia Batchasingh come segretario in data 11 set 2014 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 18 set 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Neshia Michelle Batchasingh come amministratore in data 12 ago 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Ricardo Caupers come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CARDCAST LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUPERS, Ricardo | Amministratore | King Street SW1Y 6RT London 33 United Kingdom | United Kingdom | Portuguese | 188764420001 | |||||
| GIUSEPPETTI, Fabio Massimo | Amministratore | 15 Crick Road OX2 6QL Oxford Oxfordshire | United Kingdom | Italian | 115927050001 | |||||
| AINSWORTH-MORRIS, Richard | Segretario | 21 Sarek Park NN4 9YA Northampton Northamptonshire | British | 80972840001 | ||||||
| AMOS, Richard John | Segretario | 22 Collens Road AL5 2AJ Harpenden Hertfordshire | British | 67950460002 | ||||||
| BATCHASINGH, Neshia | Segretario | Red House Brookwood GU24 0BL Woking Surrey | 169879280001 | |||||||
| COOKE, Oliver Charles | Segretario | Solelands Farm RH20 2LG West Chiltington | British | 3643340001 | ||||||
| DRYSDALE, Clive Douglas | Segretario | The Hollies Bath Road SL6 4LH Maidenhead Berkshire | British | 45345090004 | ||||||
| GOOD, Thomas William | Segretario | Kyndling 39a Cobbetts Walk GU24 9DU Bisley Surrey | British | 21310620003 | ||||||
| HAYES, Kevin Andrew | Segretario | 4 Elm Road SO22 5AG Winchester Hampshire | British | 29737760001 | ||||||
| MARCHANT, Elizabeth Jane | Segretario | 10 Harelands Close Horsell GU21 4NX Woking Surrey | British | 62140800001 | ||||||
| POOLEY, Graham Neil | Segretario | Orakau 12 Willow Walk GU28 0EY Petworth West Sussex | British | 38288020001 | ||||||
| WIGHTMAN, Iain Charles | Segretario | 65 Marefield Lower Earley RG6 3DZ Reading Berkshire | British | 81324370001 | ||||||
| E P S SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 50 Stratton Street W1X 6NX London | 900004930001 | |||||||
| AMOS, Richard John | Amministratore | 22 Collens Road AL5 2AJ Harpenden Hertfordshire | England | British | 67950460002 | |||||
| BATCHASINGH, Neshia Michelle | Amministratore | Red House Brookwood GU24 0BL Woking Surrey | United Kingdom | British | 150222160001 | |||||
| CALLAHAN, Stephen James | Amministratore | The White House Charney Bassett OX12 0EU Wantage Oxfordshire | British | 59241360001 | ||||||
| CAUNTER, Nicholas John | Amministratore | Appletrees 7 Lashmere Copthorne RH10 3RR Crawley West Sussex | British | 100149070001 | ||||||
| CLUMP, Carlyle Cyril | Amministratore | Block 11 Portomaso PTM 01 St Julians Apartment 1112 Malta | Malta | British | 61613210002 | |||||
| COOKE, Oliver Charles | Amministratore | Solelands Farm RH20 2LG West Chiltington | United Kingdom | British | 3643340001 | |||||
| DRYSDALE, Clive Douglas | Amministratore | The Hollies Bath Road SL6 4LH Maidenhead Berkshire | England | British | 45345090004 | |||||
| GOOD, Thomas William | Amministratore | 5 Burnet Close GU24 9PB West End Surrey | British | 21310620004 | ||||||
| NEVILLE, Roger Drummond | Amministratore | 97 Rous Road IG9 6BU Buckhurst Hill Essex | England | British | 35529130001 | |||||
| PARSONS, Robert Michael Featherstonehaugh | Amministratore | Three Hills House Epwell OX15 6LG Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 51846740001 | |||||
| POOLEY, Graham Neil | Amministratore | Orakau 12 Willow Walk GU28 0EY Petworth West Sussex | British | 38288020001 | ||||||
| POULTON, Christopher | Amministratore | Wildbarn 1a Brookside Orwell SG8 5TQ Royston Hertfordshire | England | British | 65823790001 | |||||
| RAVEN, Brian Kenneth | Amministratore | Foxwood 10 Badgers Hill GU25 4SB Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 156746380001 | |||||
| RICHARDSON, Ernest Arthur | Amministratore | 19 Claygate Avenue AL5 2HE Harpenden Hertfordshire | England | British | 5161170001 | |||||
| TURNER, Matthew Charles | Amministratore | Springfield Hall Star Lane Knowl Hill RG10 9UR Reading Berkshire | United Kingdom | British | 115927000001 | |||||
| WHITTAKER, Nigel | Amministratore | 176 Bickenhall Mansions Bickenhall Street W1U 3BU London | British | 65180900001 | ||||||
| WHITTAKER, Nigel | Amministratore | 176 Bickenhall Mansions Bickenhall Street W1U 3BU London | British | 65180900001 | ||||||
| MIKJON LIMITED | Amministratore delegato nominato | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 900004920001 |
CARDCAST LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| New jersey law pledge agreement | Creato il 22 nov 2012 Consegnato il 26 nov 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A first security interest in the collateral see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 set 2012 Consegnato il 22 set 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An accession deed | Creato il 23 feb 2007 Consegnato il 15 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all real property by way of first fixed charge all shares all dividends interest sand other monies and each of its accounts by way of assignment the proceeds of any claim under any insurance policy and all related rights and all rights and claims in relation to any assigned account by way of floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Stock pledge agreement | Creato il 11 gen 2000 Consegnato il 28 gen 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Any and all present and future sums obligations and liabilities of retail decisions PLC (the parent) and any other group company nominated as an additional borrower by the parent if any to the chargee under or in connection with the credit agreement or any of the other financing documents and all liabilities of the pledgor (the company) under the pledge | |
Brevi particolari The pledged collateral which means 100 shares of common stock no par value in transaction billing resources inc and all cash securities dividends proceeds and other property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture made between the company and national westminster bank PLC (the security trustee) | Creato il 11 gen 2000 Consegnato il 17 gen 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities whether present and future, actual or contingent due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 19 feb 1998 Consegnato il 20 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilites whether present or future actual or contingent which may at the date of the debenture or at any time thereafter be or become owing or incurred by the company to the chargee as security trustee,issuing bank and the banks under or pursuant to any of a credit agreement dated 23RD january 1998,a fees letter,and any guarantees and any debenture executed as security for any of the obligations and liabilities of the company and the other companies within the same group under any of the foregoing documents (together the "financing documents") (the "secured obligations") | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CARDCAST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0