OFFICE PROPERTIES PL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | OFFICE PROPERTIES PL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03125437 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MWB PROPERTY LIMITED | 01 lug 2008 | 01 lug 2008 |
| MARYLEBONE WARWICK BALFOUR GROUP PLC | 01 lug 1997 | 01 lug 1997 |
| EX-LANDS PROPERTIES PLC | 08 nov 1995 | 08 nov 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2018 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2019 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 31 ott 2019 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 14 nov 2019 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 31 ott 2018 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomina di Ms Joanne Constance Bushell come amministratore in data 17 ott 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Wayne David Berger come amministratore in data 03 ott 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2025 | 17 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2024 | 17 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Nomina di Mr. Wayne David Berger come amministratore in data 31 mag 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr. Gavin Steven Phillips come amministratore in data 31 mag 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Morris come amministratore in data 31 mag 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2023 | 17 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2022 | 17 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2021 | 20 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 set 2020 | 18 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter David Edward Gibson come amministratore in data 28 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 6 Snow Hill London EC1A 2AY a Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW in data 07 ott 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dimissioni di un liquidatore | 3 pagine | LIQ06 | ||||||||||
Dimissioni di un liquidatore | 3 pagine | LIQ06 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Burwood Place London W2 2UT England a 6 Snow Hill London EC1A 2AY in data 22 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 10 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2018 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2017 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSHELL, Joanne Constance | Amministratore | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | South Africa | British | 341942760001 | |||||||||
| PHILLIPS, Gavin Steven, Mr. | Amministratore | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | British | 324092780001 | |||||||||
| CAVE, Ian Bruce | Segretario | 392 Woodstock Road OX2 8AF Oxford Oxfordshire | British | 102741680001 | ||||||||||
| CROSSLEY, James Daniel | Segretario | 34 Bellevue Road CM12 9HB Billericay Essex | British | 29059900001 | ||||||||||
| CITY GROUP PLC | Segretario | City Road EC1Y 2AG London 30 England |
| 35794270004 | ||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||||||
| PITSEC LIMITED | Segretario | Castle Street RG1 7SR Reading 47 England |
| 38734010001 | ||||||||||
| BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Amministratore | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | 34251500001 | |||||||||
| BERGER, Wayne David, Mr. | Amministratore | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | Canadian | 323759890001 | |||||||||
| BIBRING, Michael Albert | Amministratore | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | 9320160002 | |||||||||
| BLURTON, Andrew Francis | Amministratore | Great Portland Street W1W 5LS London 179 | England | British | 53724380001 | |||||||||
| BOURNE, Graham Alexander | Amministratore | Le Roccabella 24 Avenue Princess Grace Monte Carlo 98000 Monaco | United Kingdom | British | 76871220004 | |||||||||
| BOURNE, Robert Anthony | Amministratore | 100 Cheyne Walk SW10 0DQ London | British | 70526160001 | ||||||||||
| BOUVIER, Alain Charles Patrice | Amministratore | 32 Earls Court Square SW5 9DQ London | England | British | 24106110001 | |||||||||
| BURROW, Robert Philip | Amministratore | 67 Brook Street W1K 4NJ London | England | British | 97252420005 | |||||||||
| CHENERY, Richard James | Amministratore | Lower Slaughter GL54 2HP Cheltenham The Manor Cottage Gloucestershire United Kingdom | England | British | 146075610001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Amministratore | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | Northern Ireland | British | 139640170001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Amministratore | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | England | British | 235422380001 | |||||||||
| HARRISON, John William | Amministratore | 97 Clifton Hill NW8 0JR London | United Kingdom | British | 69263980002 | |||||||||
| MARSHALL, David Courtnall | Amministratore | Savannah House 32 Sherwood Road 4051 Durban North South Africa | South Africa | British | 132056360001 | |||||||||
| MORRIS, Richard | Amministratore | Burwood Place W2 2UT London 1 England | England | British | 190653350001 | |||||||||
| MYERSON, Brian Alan | Amministratore | 52 Winnington Road N2 0TY London | British | 63023520001 | ||||||||||
| PARKER, Christopher John | Amministratore | Hill Place Station Road CM8 3JN Wickham Bishops Essex | British | 8218630001 | ||||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Amministratore | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Amministratore | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| SANDERSON, Eric Fenton | Amministratore | 10 Harelaw Road EH13 0DR Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 126848980001 | |||||||||
| SHASHOU, Joseph Saleem | Amministratore | 28 Elm Tree Road NW8 9JT London | United Kingdom | Brazilian | 51723030002 | |||||||||
| SINGH, Jagtar | Amministratore | West Garden Place Kendal Street W2 2AQ London 1 | United Kingdom | British | 121710890001 | |||||||||
| STARN, William Robert | Amministratore | City Road EC1Y 2AG London 30 | England | American | 154007330001 | |||||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 | |||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Amministratore | 120 East Road N1 6AA London | 38524190001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marley Acquisitions Limited | 11 lug 2017 | Burwood Place W2 2UT London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mwb Serviced Office Holdings Limited (In Liquidation) | 06 apr 2016 | Little New Street EC4A 3TR London Hill House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over shares | Creato il 01 ago 2008 Consegnato il 13 ago 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Entire right, title and interest in and to the 46,951,379 ordinary shares with a nominal value of £0.01 in the capital of mwb business exchange PLC together with all other shares in the capital of mwb business exchange PLC see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 mar 2005 Consegnato il 14 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 03 giu 2003 Consegnato il 16 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all inter-company debts. All the chargor's right, title and interest, present and future, in and to all inter-company debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over shares | Creato il 07 ago 2002 Consegnato il 14 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Subordination agreement | Creato il 30 mag 2002 Consegnato il 10 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any amounts held on trust for the agent towards the payment of all the senior liabilities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Subordination deed between 140 park lane limited flatford limited and flatford (no.2) limited as the obligors the company and nwb (park lane) limited as original junior creditors and the bank | Creato il 08 gen 2002 Consegnato il 18 gen 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A security interest over the "junior liabilities". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share charge | Creato il 28 ago 1997 Consegnato il 12 set 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from mwb (warwick road) limited to the chargee in connection with the loan agreement or any security document | |
Brevi particolari By way of fixed charge the investments and all dividends interest and other money payable to the chargor in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 feb 1996 Consegnato il 09 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0