OFFICE PROPERTIES PL LIMITED

OFFICE PROPERTIES PL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOFFICE PROPERTIES PL LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03125437
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Uhy Hacker Young Llp Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MWB PROPERTY LIMITED01 lug 200801 lug 2008
    MARYLEBONE WARWICK BALFOUR GROUP PLC01 lug 199701 lug 1997
    EX-LANDS PROPERTIES PLC08 nov 199508 nov 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2018
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 ott 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 nov 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al31 ott 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Ms Joanne Constance Bushell come amministratore in data 17 ott 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Wayne David Berger come amministratore in data 03 ott 2025

    1 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2025

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2024

    17 pagineLIQ03

    Nomina di Mr. Wayne David Berger come amministratore in data 31 mag 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr. Gavin Steven Phillips come amministratore in data 31 mag 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Morris come amministratore in data 31 mag 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2023

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2022

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2021

    20 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 set 2020

    18 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Peter David Edward Gibson come amministratore in data 28 ott 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 6 Snow Hill London EC1A 2AY a Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW in data 07 ott 2019

    2 pagineAD01

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Burwood Place London W2 2UT England a 6 Snow Hill London EC1A 2AY in data 22 lug 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 21 giu 2019

    LRESEX

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name20 giu 2019

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 19 giu 2019

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2018 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2017

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUSHELL, Joanne Constance
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    Amministratore
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    South AfricaBritish341942760001
    PHILLIPS, Gavin Steven, Mr.
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    Amministratore
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    EnglandBritish324092780001
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    British102741680001
    CROSSLEY, James Daniel
    34 Bellevue Road
    CM12 9HB Billericay
    Essex
    Segretario
    34 Bellevue Road
    CM12 9HB Billericay
    Essex
    British29059900001
    CITY GROUP PLC
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    England
    Segretario
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1443918
    35794270004
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    PITSEC LIMITED
    Castle Street
    RG1 7SR Reading
    47
    England
    Segretario
    Castle Street
    RG1 7SR Reading
    47
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2451677
    38734010001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Amministratore
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BERGER, Wayne David, Mr.
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    Amministratore
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    EnglandCanadian323759890001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    EnglandBritish53724380001
    BOURNE, Graham Alexander
    Le Roccabella
    24 Avenue Princess Grace
    Monte Carlo
    98000
    Monaco
    Amministratore
    Le Roccabella
    24 Avenue Princess Grace
    Monte Carlo
    98000
    Monaco
    United KingdomBritish76871220004
    BOURNE, Robert Anthony
    100 Cheyne Walk
    SW10 0DQ London
    Amministratore
    100 Cheyne Walk
    SW10 0DQ London
    British70526160001
    BOUVIER, Alain Charles Patrice
    32 Earls Court Square
    SW5 9DQ London
    Amministratore
    32 Earls Court Square
    SW5 9DQ London
    EnglandBritish24106110001
    BURROW, Robert Philip
    67 Brook Street
    W1K 4NJ London
    Amministratore
    67 Brook Street
    W1K 4NJ London
    EnglandBritish97252420005
    CHENERY, Richard James
    Lower Slaughter
    GL54 2HP Cheltenham
    The Manor Cottage
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lower Slaughter
    GL54 2HP Cheltenham
    The Manor Cottage
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish146075610001
    GIBSON, Peter David Edward
    Cromac Square
    BT2 8LA Belfast
    Forsyth House
    Northern Ireland
    Amministratore
    Cromac Square
    BT2 8LA Belfast
    Forsyth House
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish139640170001
    GIBSON, Peter David Edward
    Cromac Square
    BT2 8LA Belfast
    Forsyth House
    Northern Ireland
    Amministratore
    Cromac Square
    BT2 8LA Belfast
    Forsyth House
    Northern Ireland
    EnglandBritish235422380001
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Amministratore
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    MARSHALL, David Courtnall
    Savannah House
    32 Sherwood Road
    4051 Durban North
    South Africa
    Amministratore
    Savannah House
    32 Sherwood Road
    4051 Durban North
    South Africa
    South AfricaBritish132056360001
    MORRIS, Richard
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    Amministratore
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    EnglandBritish190653350001
    MYERSON, Brian Alan
    52 Winnington Road
    N2 0TY London
    Amministratore
    52 Winnington Road
    N2 0TY London
    British63023520001
    PARKER, Christopher John
    Hill Place Station Road
    CM8 3JN Wickham Bishops
    Essex
    Amministratore
    Hill Place Station Road
    CM8 3JN Wickham Bishops
    Essex
    British8218630001
    ROBOTHAM, John Michael
    Brickwall Farmhouse
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    Amministratore
    Brickwall Farmhouse
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    EnglandBritish3914540001
    ROBOTHAM, John Michael
    Brickwall Farmhouse
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    Amministratore
    Brickwall Farmhouse
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    EnglandBritish3914540001
    SANDERSON, Eric Fenton
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish126848980001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Amministratore
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    Amministratore
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    United KingdomBritish121710890001
    STARN, William Robert
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    Amministratore
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    EnglandAmerican154007330001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Marley Acquisitions Limited
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    11 lug 2017
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mwb Serviced Office Holdings Limited (In Liquidation)
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    England
    06 apr 2016
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    England
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Acts 1985-2006
    Luogo di registrazioneCompanies House - Uk
    Numero di registrazione04129282
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over shares
    Creato il 01 ago 2008
    Consegnato il 13 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Entire right, title and interest in and to the 46,951,379 ordinary shares with a nominal value of £0.01 in the capital of mwb business exchange PLC together with all other shares in the capital of mwb business exchange PLC see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 14 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 03 giu 2003
    Consegnato il 16 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all inter-company debts. All the chargor's right, title and interest, present and future, in and to all inter-company debts.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 16 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 07 ago 2002
    Consegnato il 14 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 14 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordination agreement
    Creato il 30 mag 2002
    Consegnato il 10 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any amounts held on trust for the agent towards the payment of all the senior liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordination deed between 140 park lane limited flatford limited and flatford (no.2) limited as the obligors the company and nwb (park lane) limited as original junior creditors and the bank
    Creato il 08 gen 2002
    Consegnato il 18 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A security interest over the "junior liabilities". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 28 ago 1997
    Consegnato il 12 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mwb (warwick road) limited to the chargee in connection with the loan agreement or any security document
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the investments and all dividends interest and other money payable to the chargor in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 12 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 feb 1996
    Consegnato il 09 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 giu 2019Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    James Douglas Ernle Money
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praticante
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Michael David Rollings
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praticante
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Brian N Johnson
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praticante
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praticante
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0