LOCHACRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLOCHACRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03127728
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LOCHACRE LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova LOCHACRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LOCHACRE LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per LOCHACRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Donagh O'sullivan come amministratore in data 23 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Stuart Solomon Conway come amministratore in data 23 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Simon Goldstein come amministratore in data 23 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Cole come amministratore in data 23 nov 2016

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Kim Alexander Gottlieb il 13 mar 2016

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 dic 2015

    Stato del capitale al 17 dic 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Allan Porter il 10 giu 2015

    1 pagineCH03

    Nomina di Allan Porter come segretario in data 10 giu 2015

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr John Cole come amministratore in data 10 giu 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Jonathan Simon Goldstein come amministratore in data 10 giu 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Stephen Stuart Solomon Conway come amministratore in data 10 giu 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Annette Graham Wood come segretario in data 10 giu 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Donagh O'sullivan come amministratore in data 10 giu 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 gen 2015

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Annette Graham Wood il 04 dic 2014

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 3Rd Floor Sterling House Langston Road Loughton Essex IG10 3TS* in data 07 gen 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2014

    Stato del capitale al 06 gen 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Kim Alexander Gottlieb il 10 dic 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2013

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LOCHACRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PORTER, Allan William
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    Segretario
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    198586760001
    GOTTLIEB, Kim Alexander
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th Floor Imperial House
    England
    Amministratore
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th Floor Imperial House
    England
    EnglandBritishCompany Director123856470021
    GRAHAM WOOD, Annette
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    England
    Segretario
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    England
    British47874270001
    KIENER, Wendy
    135 Hammersmith Road
    West Kensington
    W14 0QL London
    Segretario
    135 Hammersmith Road
    West Kensington
    W14 0QL London
    British45652420001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    AZOUZ, Edward
    Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PH London
    30
    Amministratore
    Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PH London
    30
    United KingdomBritishChartered Accountant50527240001
    COLE, John
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    Amministratore
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    United KingdomBritishCompany Director191894580001
    CONWAY, Stephen Stuart Solomon
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    Amministratore
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    United Arab EmiratesBritishCompany Director197472860001
    GOLDSTEIN, Jonathan Simon
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    Amministratore
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    United KingdomBritishCompany Director68352140004
    GOTTLIEB, Nicola Alexandra
    Sparsholt Manor
    Sparsholt
    SO21 2NW Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Sparsholt Manor
    Sparsholt
    SO21 2NW Winchester
    Hampshire
    BritishCompany Director15606060003
    GRAHAM WOOD, Annette
    Little Chartham
    East Shalford Lane Shalford
    GU4 8AF Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Little Chartham
    East Shalford Lane Shalford
    GU4 8AF Guildford
    Surrey
    BritishCompany Secretary47874270001
    O'SULLIVAN, Donagh
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    Amministratore
    Floor Imperial House
    15 Kingsway
    WC2B 6UN London
    4th
    EnglandIrishConstruction Director189234530001
    OMALLEY, Peter
    12a Ellington Road
    Muswell Hill
    N10 3DG London
    Amministratore
    12a Ellington Road
    Muswell Hill
    N10 3DG London
    BritishArchitect90224970001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    LOCHACRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 set 2007
    Consegnato il 03 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 03 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 28 set 2007
    Consegnato il 03 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H site at the junction of gunnersbury avenue and great west road chiswick london t/no AGL57553 and AGL59572 all fixtures fittings and chattels the goodwill all rent and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 03 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over cash deposit
    Creato il 23 mag 2003
    Consegnato il 29 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit and all the present and future rights,titles and benefit of the company whatsoever in the deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 mag 2003
    Consegnato il 29 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mag 2003
    Consegnato il 29 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h land on the north east side of great west road and the west side of gunnersbury avenue,chiswick t/nos AGL59572 and AGL57553. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of life policy
    Creato il 29 gen 1999
    Consegnato il 03 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or a company which is from time to time a member of the same group of companies as the chargee (the "indebtedness")
    Brevi particolari
    Life assurance policy number 65B65E86 for the life assured kim alexander gottlieb issued by j rothschild assurance the commencement date of which is 4 december 1998 and all monies including profits and bonuses which may become payable thereunder and all the right title and interest of the company to the foregoing.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 dic 1998
    Consegnato il 22 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The right to the receipt of all the rental income from the advertising hoardings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alpha Bank London Limited
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at the west of gunnersbury avenue chiswick and land on the north side of the great west road gunnersbury greater london t/no's NGL488071 AGL57553 and MX301838 (part) and a floating charge the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Alpha Bank London Limited
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 mar 1996
    Consegnato il 23 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 150/164 evelyn street deptford london borough of lewisham and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 mar 1996
    Consegnato il 26 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0