COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03128590 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?
- Attività di gestione delle strutture informatiche (62030) / Informazione e comunicazione
Dove si trova COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Europa House Goldstone Villas BN3 3RQ Hove East Sussex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2015 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2016 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Cessazione della carica di Julian John Lomax come amministratore in data 31 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Colesby come amministratore in data 31 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Colesby come amministratore in data 31 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Kenneth Hazeldene come amministratore in data 31 ott 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Kenneth Hazeldene come amministratore in data 31 ott 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Gregory Donald Lomax come segretario in data 31 lug 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin Arthur Titshall come segretario in data 31 lug 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Colin Arthur Titshall il 31 lug 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin Arthur Titshall come amministratore in data 31 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Julian John Lomax il 10 dic 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Kenneth Hazeldene come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Clarke come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Arthur Titshall il 21 nov 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2012 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | MG01 | |||||||||||
legacy | 5 pagine | MG01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMAX, Gregory Donald | Segretario | Europa House Goldstone Villas BN3 3RQ Hove East Sussex | 200290400001 | |||||||
LOMAX, Gregory Donald | Amministratore | 1 St Marys Mount CR3 6SJ Caterham Surrey | England | British | It Consultant | 78243060002 | ||||
HOWELLS, Keith Ivor | Segretario | 15 Sunninghill Avenue BN3 8JB Hove East Sussex | Other | Financial Consultant | 101677300001 | |||||
LOMAX, Gregory Donald | Segretario | 1 St Marys Mount CR3 6SJ Caterham Surrey | British | Director | 78243060002 | |||||
PAGE, Andrew Lawrence | Segretario | 58 Benfield Way BN41 2DL Portslade East Sussex | British | Retired | 127810810001 | |||||
TITSHALL, Colin Arthur | Segretario | Katherine Mews Godstone Road CR3 0ED Whyteleafe Unit 2 Surrey England | British | 173828620001 | ||||||
BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
CLARKE, Robert James | Amministratore | Katherine Mews Godstone Road CR3 0ED Whyteleafe Unit 2 Surrey | United Kingdom | Britsh | None | 151620750001 | ||||
COLESBY, Christopher | Amministratore | 7 Eggington Road DY8 4QJ Stourbridge West Midlands | England | British | Technical Director | 127798320001 | ||||
GRIMES, Daniel Edward Frederick | Amministratore | 45 Shawley Crescent KT18 5PQ Epsom Downs Surrey | British | It Consultant | 94272530001 | |||||
GRIMES, Daniel Edward Frederick | Amministratore | 78 Hillcross Avenue SM4 4EB Morden Surrey | British | Director | 45492140001 | |||||
HAZELDENE, Paul Kenneth | Amministratore | Godstone Road CR3 0ED Whyteleafe Unit 2, Katherine Mews Surrey England | United Kingdom | Uk | Commercial Director | 91847480001 | ||||
LOMAX, Gregory Donald | Amministratore | 30 Winchester Close OX16 4FP Banbury Oxfordshire | British | Director | 78243060001 | |||||
LOMAX, Julian John | Amministratore | Stanley Close CR5 2LN Coulsdon 12 Surrey England | United Kingdom | British | Company Co Ordinator | 80358670002 | ||||
LOMAX, Roderick Hanson | Amministratore | Heathfield Heath Rise GU23 6ET Ripley Surrey | England | British | I T Consultant | 76027880001 | ||||
LOMAX, Wesley Paul | Amministratore | 4 Meadow Approach Copthorne RH10 3RF Crawley West Sussex | British | Clerk | 55159600002 | |||||
REYNOLDS, Peter Anthony | Amministratore | 6 Park Mews Withnell PR6 8AW Chorley Lancashire | British | Sales Consultants | 101712480001 | |||||
ROWELL, Michael James | Amministratore | 86 Grange Road PR9 9AD Southport Merseyside | British | It | 101277990001 | |||||
TITSHALL, Colin Arthur | Amministratore | Katherine Mews Godstone Road CR3 0ED Whyteleafe Unit 2 Surrey England | England | British | Accountant | 173828620001 | ||||
WEBBER, Paul | Amministratore | 21 Surrey Hills Court 106 Godstone Road CR3 6RZ Caterham Surrey | England | British | Finance Director | 124678390001 | ||||
WORRAD, Barnaby | Amministratore | 23 Hastings Road CR0 6PH Croydon Surrey | British | It Consultant | 80358610001 | |||||
DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture (all assets) | Creato il 04 dic 2012 Consegnato il 05 dic 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 ago 2011 Consegnato il 31 ago 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 nov 2010 Consegnato il 14 dic 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 04 ago 2006 Consegnato il 09 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 05 feb 1996 Consegnato il 13 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0