COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED

COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03128590
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?

    • Attività di gestione delle strutture informatiche (62030) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Europa House
    Goldstone Villas
    BN3 3RQ Hove
    East Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2015
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2016
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Julian John Lomax come amministratore in data 31 ago 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Colesby come amministratore in data 31 ago 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Colesby come amministratore in data 31 ago 2016

    1 pagineTM01

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Paul Kenneth Hazeldene come amministratore in data 31 ott 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Kenneth Hazeldene come amministratore in data 31 ott 2015

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Gregory Donald Lomax come segretario in data 31 lug 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Colin Arthur Titshall come segretario in data 31 lug 2015

    1 pagineTM02

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Colin Arthur Titshall il 31 lug 2015

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Colin Arthur Titshall come amministratore in data 31 lug 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 feb 2015

    Stato del capitale al 27 feb 2015

    • Capitale: GBP 78
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Julian John Lomax il 10 dic 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Kenneth Hazeldene come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2014

    Stato del capitale al 26 feb 2014

    • Capitale: GBP 78
    SH01

    Cessazione della carica di Robert Clarke come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Arthur Titshall il 21 nov 2012

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    legacy

    MG01

    legacy

    5 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LOMAX, Gregory Donald
    Europa House
    Goldstone Villas
    BN3 3RQ Hove
    East Sussex
    Segretario
    Europa House
    Goldstone Villas
    BN3 3RQ Hove
    East Sussex
    200290400001
    LOMAX, Gregory Donald
    1 St Marys Mount
    CR3 6SJ Caterham
    Surrey
    Amministratore
    1 St Marys Mount
    CR3 6SJ Caterham
    Surrey
    EnglandBritishIt Consultant78243060002
    HOWELLS, Keith Ivor
    15 Sunninghill Avenue
    BN3 8JB Hove
    East Sussex
    Segretario
    15 Sunninghill Avenue
    BN3 8JB Hove
    East Sussex
    OtherFinancial Consultant101677300001
    LOMAX, Gregory Donald
    1 St Marys Mount
    CR3 6SJ Caterham
    Surrey
    Segretario
    1 St Marys Mount
    CR3 6SJ Caterham
    Surrey
    BritishDirector78243060002
    PAGE, Andrew Lawrence
    58 Benfield Way
    BN41 2DL Portslade
    East Sussex
    Segretario
    58 Benfield Way
    BN41 2DL Portslade
    East Sussex
    BritishRetired127810810001
    TITSHALL, Colin Arthur
    Katherine Mews
    Godstone Road
    CR3 0ED Whyteleafe
    Unit 2
    Surrey
    England
    Segretario
    Katherine Mews
    Godstone Road
    CR3 0ED Whyteleafe
    Unit 2
    Surrey
    England
    British173828620001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    CLARKE, Robert James
    Katherine Mews
    Godstone Road
    CR3 0ED Whyteleafe
    Unit 2
    Surrey
    Amministratore
    Katherine Mews
    Godstone Road
    CR3 0ED Whyteleafe
    Unit 2
    Surrey
    United KingdomBritshNone151620750001
    COLESBY, Christopher
    7 Eggington Road
    DY8 4QJ Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    7 Eggington Road
    DY8 4QJ Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishTechnical Director127798320001
    GRIMES, Daniel Edward Frederick
    45 Shawley Crescent
    KT18 5PQ Epsom Downs
    Surrey
    Amministratore
    45 Shawley Crescent
    KT18 5PQ Epsom Downs
    Surrey
    BritishIt Consultant94272530001
    GRIMES, Daniel Edward Frederick
    78 Hillcross Avenue
    SM4 4EB Morden
    Surrey
    Amministratore
    78 Hillcross Avenue
    SM4 4EB Morden
    Surrey
    BritishDirector45492140001
    HAZELDENE, Paul Kenneth
    Godstone Road
    CR3 0ED Whyteleafe
    Unit 2, Katherine Mews
    Surrey
    England
    Amministratore
    Godstone Road
    CR3 0ED Whyteleafe
    Unit 2, Katherine Mews
    Surrey
    England
    United KingdomUkCommercial Director91847480001
    LOMAX, Gregory Donald
    30 Winchester Close
    OX16 4FP Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    30 Winchester Close
    OX16 4FP Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector78243060001
    LOMAX, Julian John
    Stanley Close
    CR5 2LN Coulsdon
    12
    Surrey
    England
    Amministratore
    Stanley Close
    CR5 2LN Coulsdon
    12
    Surrey
    England
    United KingdomBritishCompany Co Ordinator80358670002
    LOMAX, Roderick Hanson
    Heathfield
    Heath Rise
    GU23 6ET Ripley
    Surrey
    Amministratore
    Heathfield
    Heath Rise
    GU23 6ET Ripley
    Surrey
    EnglandBritishI T Consultant76027880001
    LOMAX, Wesley Paul
    4 Meadow Approach
    Copthorne
    RH10 3RF Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    4 Meadow Approach
    Copthorne
    RH10 3RF Crawley
    West Sussex
    BritishClerk55159600002
    REYNOLDS, Peter Anthony
    6 Park Mews
    Withnell
    PR6 8AW Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    6 Park Mews
    Withnell
    PR6 8AW Chorley
    Lancashire
    BritishSales Consultants101712480001
    ROWELL, Michael James
    86 Grange Road
    PR9 9AD Southport
    Merseyside
    Amministratore
    86 Grange Road
    PR9 9AD Southport
    Merseyside
    BritishIt101277990001
    TITSHALL, Colin Arthur
    Katherine Mews
    Godstone Road
    CR3 0ED Whyteleafe
    Unit 2
    Surrey
    England
    Amministratore
    Katherine Mews
    Godstone Road
    CR3 0ED Whyteleafe
    Unit 2
    Surrey
    England
    EnglandBritishAccountant173828620001
    WEBBER, Paul
    21 Surrey Hills Court
    106 Godstone Road
    CR3 6RZ Caterham
    Surrey
    Amministratore
    21 Surrey Hills Court
    106 Godstone Road
    CR3 6RZ Caterham
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director124678390001
    WORRAD, Barnaby
    23 Hastings Road
    CR0 6PH Croydon
    Surrey
    Amministratore
    23 Hastings Road
    CR0 6PH Croydon
    Surrey
    BritishIt Consultant80358610001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    COMPUFIX COMPUTER SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture (all assets)
    Creato il 04 dic 2012
    Consegnato il 05 dic 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ultimate Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 05 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 30 ago 2011
    Consegnato il 31 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 29 nov 2010
    Consegnato il 14 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Innovation Finance Limited
    Transazioni
    • 14 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 ago 2006
    Consegnato il 09 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 09 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 feb 1996
    Consegnato il 13 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0