STORTEXT MICROFILM LIMITED
Panoramica
| Nome della società | STORTEXT MICROFILM LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03129327 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STORTEXT MICROFILM LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova STORTEXT MICROFILM LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Box-It Winnall Down Farm Alresford Road SO21 1FP Winchester Hampshire United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STORTEXT MICROFILM LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| STERLING MICROFILM LIMITED | 22 nov 1995 | 22 nov 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STORTEXT MICROFILM LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per STORTEXT MICROFILM LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Winnall Down Fair Lane Winchester Hampshire SO21 1HF in data 24 gen 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 6 pagine | MG01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Helen Versluys come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Keeler come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2011 al 31 dic 2010 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John Williams come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Helen Louise Versluys come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mh Secretaries Limited come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Graeme Scott come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Staple Court 11 Staple Inn Buildings London WC1V 7QH in data 04 mar 2010 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di John Simon Bruce Mccowen come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Simon Patrick Ellis come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 nov 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di STORTEXT MICROFILM LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLIS, Simon Patrick | Amministratore | Fair Lane SO21 1HF Winchester Winnall Down Hampshire | England | British | 116198200002 | |||||
| MCCOWEN, John Simon Bruce | Amministratore | Fair Lane SO21 1HF Winchester Winnall Down Hampshire | United Kingdom | British | 43693610001 | |||||
| COOPER, David Arthur | Segretario | Offham House Offham, South Stoke BN18 9PD Arundel West Sussex | British | 66988110001 | ||||||
| KELLY, Paul Matthew | Segretario | 13 Ladysneuk Road FK9 5NE Stirling Stirlingshire | British | 71750740001 | ||||||
| LAMONT, Julian Callum | Segretario | 51 Queen Margaret Close EH10 7EE Edinburgh | British | 56618420001 | ||||||
| WALLACE, Graham Alexander Drummond | Segretario | Brewlands Lodge 22 Newmills Road EH22 2AH Dalkeith Midlothian | British | 70304160001 | ||||||
| CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED | Segretario nominato | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000860001 | |||||||
| MH SECRETARIES LIMITED | Segretario | Staples Court 11 Staple Inn Buildings WC1V 7QH London | 39754020001 | |||||||
| ALSTON, Bernard | Amministratore | Church Farm Hulcote MK17 8BW Milton Keynes | British | 11659090002 | ||||||
| COOPER, David Arthur | Amministratore | Offham House Offham, South Stoke BN18 9PD Arundel West Sussex | England | British | 66988110001 | |||||
| EVANS, Adrian Michael | Amministratore | 44 Beckwith Road Dulwich SE24 9LG London | United Kingdom | British | 15391950001 | |||||
| HENDERSON, Howard Geoffrey | Amministratore | 28 Adrian Close CF36 3LX Porthcawl Mid Glamorgan | United Kingdom | British | 80242420001 | |||||
| KEELER, Simon Nicholas | Amministratore | 32 Dickens Drive Old Stratford MK19 6NN Milton Keynes | England | British | 79093730001 | |||||
| KEELER, Simon Nicholas | Amministratore | 32 Dickens Drive Old Stratford MK19 6NN Milton Keynes | England | British | 79093730001 | |||||
| LAMONT, Julian Callum | Amministratore | 51 Queen Margaret Close EH10 7EE Edinburgh | British | 56618420001 | ||||||
| MACDONALD, Angus Donald Mackintosh | Amministratore | 18 Hermitage Drive EH10 6BZ Edinburgh | Scotland | British | 43780001 | |||||
| MCDONAUGH, James | Amministratore | 10a Corstorphine Road EH12 6HN Edinburgh Midlothian | British | 69813030002 | ||||||
| PATEL, Hiten | Amministratore | 10 Dunblane Drive Orton Southgate PE2 6SW Peterborough Cambridgeshire | British | 109042450001 | ||||||
| RITCHIE, William Martin | Amministratore | Keston 4 Buckstane Park EH10 6PA Edinburgh | Scotland | British | 36556530001 | |||||
| SCOTT, Graeme John | Amministratore | 56 Fountainhall Road EH9 2LP Edinburgh | Scotland | British | 101636440002 | |||||
| VERSLUYS, Helen Louise | Amministratore | Fair Lane SO21 1HF Winchester Winnall Down Hampshire | Uk | British | 149486770001 | |||||
| WALLACE, Graham Alexander Drummond | Amministratore | Brewlands Lodge 22 Newmills Road EH22 2AH Dalkeith Midlothian | Scotland | British | 70304160001 | |||||
| WILLIAMS, John Sinclair | Amministratore | 62 Greenacres Woolton Hill RG20 9TA Newbury Hants | England | British | 81423620003 | |||||
| WILLIAMS, Roy Grainger | Amministratore | Armscote Manor CV37 8DA Armscote Warwickshire | United Kingdom | British | 78315110002 |
STORTEXT MICROFILM LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creato il 16 mag 2012 Consegnato il 22 mag 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Creato il 20 ott 2008 Consegnato il 21 ott 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 11 lug 2000 Consegnato il 01 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 mar 1998 Consegnato il 17 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0