STORTEXT MICROFILM LIMITED

STORTEXT MICROFILM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTORTEXT MICROFILM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03129327
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STORTEXT MICROFILM LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova STORTEXT MICROFILM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Box-It Winnall Down Farm
    Alresford Road
    SO21 1FP Winchester
    Hampshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STORTEXT MICROFILM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STERLING MICROFILM LIMITED22 nov 199522 nov 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di STORTEXT MICROFILM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per STORTEXT MICROFILM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Winnall Down Fair Lane Winchester Hampshire SO21 1HF in data 24 gen 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 dic 2012

    Stato del capitale al 12 dic 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    legacy

    6 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Helen Versluys come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Keeler come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2011 al 31 dic 2010

    3 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di John Williams come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Helen Louise Versluys come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mh Secretaries Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Graeme Scott come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Staple Court 11 Staple Inn Buildings London WC1V 7QH in data 04 mar 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di John Simon Bruce Mccowen come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Simon Patrick Ellis come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STORTEXT MICROFILM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIS, Simon Patrick
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    Amministratore
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    EnglandBritish116198200002
    MCCOWEN, John Simon Bruce
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    Amministratore
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    United KingdomBritish43693610001
    COOPER, David Arthur
    Offham House
    Offham, South Stoke
    BN18 9PD Arundel
    West Sussex
    Segretario
    Offham House
    Offham, South Stoke
    BN18 9PD Arundel
    West Sussex
    British66988110001
    KELLY, Paul Matthew
    13 Ladysneuk Road
    FK9 5NE Stirling
    Stirlingshire
    Segretario
    13 Ladysneuk Road
    FK9 5NE Stirling
    Stirlingshire
    British71750740001
    LAMONT, Julian Callum
    51 Queen Margaret Close
    EH10 7EE Edinburgh
    Segretario
    51 Queen Margaret Close
    EH10 7EE Edinburgh
    British56618420001
    WALLACE, Graham Alexander Drummond
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    Segretario
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    British70304160001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Segretario
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    39754020001
    ALSTON, Bernard
    Church Farm
    Hulcote
    MK17 8BW Milton Keynes
    Amministratore
    Church Farm
    Hulcote
    MK17 8BW Milton Keynes
    British11659090002
    COOPER, David Arthur
    Offham House
    Offham, South Stoke
    BN18 9PD Arundel
    West Sussex
    Amministratore
    Offham House
    Offham, South Stoke
    BN18 9PD Arundel
    West Sussex
    EnglandBritish66988110001
    EVANS, Adrian Michael
    44 Beckwith Road
    Dulwich
    SE24 9LG London
    Amministratore
    44 Beckwith Road
    Dulwich
    SE24 9LG London
    United KingdomBritish15391950001
    HENDERSON, Howard Geoffrey
    28 Adrian Close
    CF36 3LX Porthcawl
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    28 Adrian Close
    CF36 3LX Porthcawl
    Mid Glamorgan
    United KingdomBritish80242420001
    KEELER, Simon Nicholas
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    Amministratore
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    EnglandBritish79093730001
    KEELER, Simon Nicholas
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    Amministratore
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    EnglandBritish79093730001
    LAMONT, Julian Callum
    51 Queen Margaret Close
    EH10 7EE Edinburgh
    Amministratore
    51 Queen Margaret Close
    EH10 7EE Edinburgh
    British56618420001
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    Amministratore
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    ScotlandBritish43780001
    MCDONAUGH, James
    10a Corstorphine Road
    EH12 6HN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    10a Corstorphine Road
    EH12 6HN Edinburgh
    Midlothian
    British69813030002
    PATEL, Hiten
    10 Dunblane Drive
    Orton Southgate
    PE2 6SW Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    10 Dunblane Drive
    Orton Southgate
    PE2 6SW Peterborough
    Cambridgeshire
    British109042450001
    RITCHIE, William Martin
    Keston
    4 Buckstane Park
    EH10 6PA Edinburgh
    Amministratore
    Keston
    4 Buckstane Park
    EH10 6PA Edinburgh
    ScotlandBritish36556530001
    SCOTT, Graeme John
    56 Fountainhall Road
    EH9 2LP Edinburgh
    Amministratore
    56 Fountainhall Road
    EH9 2LP Edinburgh
    ScotlandBritish101636440002
    VERSLUYS, Helen Louise
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    Amministratore
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    UkBritish149486770001
    WALLACE, Graham Alexander Drummond
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    Amministratore
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish70304160001
    WILLIAMS, John Sinclair
    62 Greenacres
    Woolton Hill
    RG20 9TA Newbury
    Hants
    Amministratore
    62 Greenacres
    Woolton Hill
    RG20 9TA Newbury
    Hants
    EnglandBritish81423620003
    WILLIAMS, Roy Grainger
    Armscote Manor
    CV37 8DA Armscote
    Warwickshire
    Amministratore
    Armscote Manor
    CV37 8DA Armscote
    Warwickshire
    United KingdomBritish78315110002

    STORTEXT MICROFILM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 16 mag 2012
    Consegnato il 22 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centric Spv 1 Limited
    Transazioni
    • 22 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 20 ott 2008
    Consegnato il 21 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centric Spv 1 Limited
    Transazioni
    • 21 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 lug 2000
    Consegnato il 01 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 mar 1998
    Consegnato il 17 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0