CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC

CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHEVAL PROPERTY FINANCE PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03131133
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?

    • (6512) /
    • (6523) /

    Dove si trova CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Arundel House 1 Amberley Court
    Whitworth Road
    RH11 7XL Crawley
    West Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHEVAL ACCEPTANCES PLC27 nov 199527 nov 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2016

    11 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2015

    11 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:C.O. To remove liquidator
    15 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2014

    7 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2013

    8 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Indirizzo della sede legale modificato da , 7 More London Riverside, London, SE1 2RT in data 28 feb 2012

    3 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 gen 2012

    14 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    10 pagine2.23B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 lug 2011

    12 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 lug 2011

    13 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da , Meridien House, 69-71 Clarendon, Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS in data 19 mag 2011

    2 pagineAD01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    23 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B

    9 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 dic 2010

    Stato del capitale al 21 dic 2010

    • Capitale: GBP 61,000
    SH01

    Nomina di Mr George Leo Benninger come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Margolis come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gavin Diamond come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di un segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENNINGER, George Leo
    1 Amberley Court
    Whitworth Road
    RH11 7XL Crawley
    Arundel House
    West Sussex
    Amministratore
    1 Amberley Court
    Whitworth Road
    RH11 7XL Crawley
    Arundel House
    West Sussex
    UsaAmericanAttorney149974270001
    HALPERN, Colin
    2940 Le Bateua Drive
    FL 33410 Palm Beach Gardens
    Florida
    Usa
    Amministratore
    2940 Le Bateua Drive
    FL 33410 Palm Beach Gardens
    Florida
    Usa
    United StatesAmericanCompany Director112008300001
    KAY, Allan Howard
    18 Kingsley Avenue
    WD6 4LY Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    18 Kingsley Avenue
    WD6 4LY Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector51275610001
    MARGOLIS, Jeffrey Harold
    69 Embry Way
    HA7 3AY Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    69 Embry Way
    HA7 3AY Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant1849570002
    DIAMOND, Gavin Roland
    Meridien House, 69-71 Clarendon
    Road, Watford
    WD17 1DS Hertfordshire
    Segretario
    Meridien House, 69-71 Clarendon
    Road, Watford
    WD17 1DS Hertfordshire
    149089760001
    EPSTEIN, Norman Clifford
    30 Bentley Way
    HA7 3RP Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    30 Bentley Way
    HA7 3RP Stanmore
    Middlesex
    British53261920001
    KAY, Allan Howard
    18 Kingsley Avenue
    WD6 4LY Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    18 Kingsley Avenue
    WD6 4LY Borehamwood
    Hertfordshire
    British51275610001
    MARGOLIS, Alan Stephen
    41 Chandos Road
    East Finchley
    N2 9AR London
    Segretario
    41 Chandos Road
    East Finchley
    N2 9AR London
    BritishSolicitor67445290003
    MARGOLIS, Alan Stephen
    19 Brackenbury Road
    N2 0SS London
    Segretario
    19 Brackenbury Road
    N2 0SS London
    British67445290002
    MELAMET, Geoffrey Hugh
    87 Meadway
    NW11 6QH London
    Segretario
    87 Meadway
    NW11 6QH London
    BritishSec/Dir2209360001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Segretario nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    CHESLER, Martin David
    26 Goodwyn Avenue
    NW7 3RG London
    Amministratore
    26 Goodwyn Avenue
    NW7 3RG London
    United KingdomBritishAccountant87680650002
    COHEN, Sidney
    9 Redricks Lane
    CM21 0RL Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Redricks Lane
    CM21 0RL Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishMortgage Marketing4528330002
    EPSTEIN, Norman Clifford
    30 Bentley Way
    HA7 3RP Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    30 Bentley Way
    HA7 3RP Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishAccountant53261920001
    GAMMOND, David Keith
    18 Riverside
    Chadderton
    OL1 2TX Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    18 Riverside
    Chadderton
    OL1 2TX Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishDirector12342460001
    HERSCH, Benson Selwyn
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritishAccountant6057020001
    KEY, Gavin
    9 Trafford Close
    WD7 9HU Shenley
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Trafford Close
    WD7 9HU Shenley
    Hertfordshire
    BritishAccountant67799080002
    MARGOLIS, Alan Stephen
    41 Chandos Road
    East Finchley
    N2 9AR London
    Amministratore
    41 Chandos Road
    East Finchley
    N2 9AR London
    EnglandBritishSolicitor67445290003
    MELAMET, Geoffrey Hugh
    87 Meadway
    NW11 6QH London
    Amministratore
    87 Meadway
    NW11 6QH London
    United KingdomBritishSec/Dir2209360001
    POSNIAK, Mark
    4 Grovewood House
    168a Granville Road
    NW2 2DU London
    Amministratore
    4 Grovewood House
    168a Granville Road
    NW2 2DU London
    AustralianMarketing Manager116261630001
    RUMBOLD, Paul Antony George
    Hey House
    Moorbottom Road Holcombe
    BL8 4NS Bury
    Lancashire
    Amministratore
    Hey House
    Moorbottom Road Holcombe
    BL8 4NS Bury
    Lancashire
    United KingdomBritishMarketing Director105913040001
    SHER, Ellis Lester
    Meridien House
    69-71 Clarendon Road
    WD17 1DS Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Meridien House
    69-71 Clarendon Road
    WD17 1DS Watford
    Hertfordshire
    BritishCompany Director109466950002
    WHEELER, John Philip
    86 Beamish Close
    North Weald
    CM16 6JW Epping
    Essex
    Amministratore
    86 Beamish Close
    North Weald
    CM16 6JW Epping
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director67334570001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Amministratore delegato nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 28 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors and each of them to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transazioni
    • 28 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 mar 2007
    Consegnato il 07 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 mar 2005
    Consegnato il 08 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee up to a maximum of £30,000,000
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Volkomen Financiering B.V.
    Transazioni
    • 08 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over security account
    Creato il 30 ott 2003
    Consegnato il 11 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or cheval personal loans limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all its right title interest and benefit in and to the security account and the trust property, all monies standing to the credit of the security account, all interest accrued on monies standing to the credit of the security account and all rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over security account
    Creato il 21 mar 2003
    Consegnato il 29 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the group companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all its right, title interest and benefit in and to the security account.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage (sub charge)
    Creato il 05 feb 2002
    Consegnato il 21 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £186,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    12 oxford street malmesbury.
    Persone aventi diritto
    • Israel Discount Bank Limited
    Transazioni
    • 21 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage (sub charge)
    Creato il 05 feb 2002
    Consegnato il 13 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £139,200.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    2, 2A and 4 st pauls cottages, wenlock drive, halewood.
    Persone aventi diritto
    • Israel Discount Bank Limited
    Transazioni
    • 13 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 ott 2001
    Consegnato il 01 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,000,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Volkomen Financiering Bv
    Transazioni
    • 01 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2011Inizio dell'amministrazione
    08 feb 2012Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Karen Lesley Dukes
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    2
    DataTipo
    08 feb 2012Inizio della liquidazione
    29 lug 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ranjit Bajjon
    Atherton Bailey Llp
    Arundel House 1 Amberley Court
    RH11 7XL Whitworth Road
    Crawley
    Praticante
    Atherton Bailey Llp
    Arundel House 1 Amberley Court
    RH11 7XL Whitworth Road
    Crawley
    Malcolm Peter Fillmore
    Arundel House 1 Amberley Court
    Whitworth Road
    RH11 7XL Crawley
    Praticante
    Arundel House 1 Amberley Court
    Whitworth Road
    RH11 7XL Crawley

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0