CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC
Panoramica
Nome della società | CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società per azioni |
Numero di società | 03131133 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?
- (6512) /
- (6523) /
Dove si trova CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?
Indirizzo della sede legale | Arundel House 1 Amberley Court Whitworth Road RH11 7XL Crawley West Sussex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CHEVAL ACCEPTANCES PLC | 27 nov 1995 | 27 nov 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 11 pagine | 4.72 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2016 | 11 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2015 | 11 pagine | 4.68 | ||||||||||
Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza Court order insolvency:C.O. To remove liquidator | 15 pagine | LIQ MISC OC | ||||||||||
Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario | 1 pagine | 4.40 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2014 | 7 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2013 | 8 pagine | 4.68 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 3 pagine | F10.2 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , 7 More London Riverside, London, SE1 2RT in data 28 feb 2012 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 gen 2012 | 14 pagine | 2.24B | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 1 pagine | 2.34B | ||||||||||
Risultato della riunione dei creditori | 10 pagine | 2.23B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 lug 2011 | 12 pagine | 2.24B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 lug 2011 | 13 pagine | 2.24B | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Meridien House, 69-71 Clarendon, Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS in data 19 mag 2011 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 1 pagine | F2.18 | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 23 pagine | 2.17B | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B | 9 pagine | 2.16B | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr George Leo Benninger come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Margolis come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gavin Diamond come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di un segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENNINGER, George Leo | Amministratore | 1 Amberley Court Whitworth Road RH11 7XL Crawley Arundel House West Sussex | Usa | American | Attorney | 149974270001 | ||||
HALPERN, Colin | Amministratore | 2940 Le Bateua Drive FL 33410 Palm Beach Gardens Florida Usa | United States | American | Company Director | 112008300001 | ||||
KAY, Allan Howard | Amministratore | 18 Kingsley Avenue WD6 4LY Borehamwood Hertfordshire | England | British | Director | 51275610001 | ||||
MARGOLIS, Jeffrey Harold | Amministratore | 69 Embry Way HA7 3AY Stanmore Middlesex | England | British | Accountant | 1849570002 | ||||
DIAMOND, Gavin Roland | Segretario | Meridien House, 69-71 Clarendon Road, Watford WD17 1DS Hertfordshire | 149089760001 | |||||||
EPSTEIN, Norman Clifford | Segretario | 30 Bentley Way HA7 3RP Stanmore Middlesex | British | 53261920001 | ||||||
KAY, Allan Howard | Segretario | 18 Kingsley Avenue WD6 4LY Borehamwood Hertfordshire | British | 51275610001 | ||||||
MARGOLIS, Alan Stephen | Segretario | 41 Chandos Road East Finchley N2 9AR London | British | Solicitor | 67445290003 | |||||
MARGOLIS, Alan Stephen | Segretario | 19 Brackenbury Road N2 0SS London | British | 67445290002 | ||||||
MELAMET, Geoffrey Hugh | Segretario | 87 Meadway NW11 6QH London | British | Sec/Dir | 2209360001 | |||||
RM REGISTRARS LIMITED | Segretario nominato | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900000760001 | |||||||
CHESLER, Martin David | Amministratore | 26 Goodwyn Avenue NW7 3RG London | United Kingdom | British | Accountant | 87680650002 | ||||
COHEN, Sidney | Amministratore | 9 Redricks Lane CM21 0RL Sawbridgeworth Hertfordshire | United Kingdom | British | Mortgage Marketing | 4528330002 | ||||
EPSTEIN, Norman Clifford | Amministratore | 30 Bentley Way HA7 3RP Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Accountant | 53261920001 | ||||
GAMMOND, David Keith | Amministratore | 18 Riverside Chadderton OL1 2TX Oldham Lancashire | England | British | Director | 12342460001 | ||||
HERSCH, Benson Selwyn | Amministratore | 60 Grange Gardens HA5 5QF Pinner Middlesex | United Kingdom | British | Accountant | 6057020001 | ||||
KEY, Gavin | Amministratore | 9 Trafford Close WD7 9HU Shenley Hertfordshire | British | Accountant | 67799080002 | |||||
MARGOLIS, Alan Stephen | Amministratore | 41 Chandos Road East Finchley N2 9AR London | England | British | Solicitor | 67445290003 | ||||
MELAMET, Geoffrey Hugh | Amministratore | 87 Meadway NW11 6QH London | United Kingdom | British | Sec/Dir | 2209360001 | ||||
POSNIAK, Mark | Amministratore | 4 Grovewood House 168a Granville Road NW2 2DU London | Australian | Marketing Manager | 116261630001 | |||||
RUMBOLD, Paul Antony George | Amministratore | Hey House Moorbottom Road Holcombe BL8 4NS Bury Lancashire | United Kingdom | British | Marketing Director | 105913040001 | ||||
SHER, Ellis Lester | Amministratore | Meridien House 69-71 Clarendon Road WD17 1DS Watford Hertfordshire | British | Company Director | 109466950002 | |||||
WHEELER, John Philip | Amministratore | 86 Beamish Close North Weald CM16 6JW Epping Essex | United Kingdom | British | Company Director | 67334570001 | ||||
RM NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900009140001 |
CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 12 dic 2007 Consegnato il 28 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors and each of them to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 mar 2007 Consegnato il 07 apr 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 07 mar 2005 Consegnato il 08 mar 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee up to a maximum of £30,000,000 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over security account | Creato il 30 ott 2003 Consegnato il 11 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or cheval personal loans limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all its right title interest and benefit in and to the security account and the trust property, all monies standing to the credit of the security account, all interest accrued on monies standing to the credit of the security account and all rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over security account | Creato il 21 mar 2003 Consegnato il 29 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and the group companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all its right, title interest and benefit in and to the security account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage (sub charge) | Creato il 05 feb 2002 Consegnato il 21 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £186,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 12 oxford street malmesbury. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage (sub charge) | Creato il 05 feb 2002 Consegnato il 13 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £139,200.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 2, 2A and 4 st pauls cottages, wenlock drive, halewood. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 31 ott 2001 Consegnato il 01 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,000,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CHEVAL PROPERTY FINANCE PLC ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0