RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED

RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03131546
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COLUMBUS TRAVEL SOLUTIONS LIMITED28 nov 199528 nov 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Stato del capitale al 30 dic 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 08 dic 2015

    • Capitale: GBP 82.25
    3 pagineSH01

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 nov 2015

    Stato del capitale al 30 nov 2015

    • Capitale: GBP 81.25
    SH01

    legacy

    94 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 nov 2014

    Stato del capitale al 28 nov 2014

    • Capitale: GBP 81.25
    SH01

    legacy

    92 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    92 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Cessazione della carica di Caroline Withers come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mine Ozkan Hifzi come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 dic 2013

    Stato del capitale al 20 dic 2013

    • Capitale: GBP 81.25
    SH01

    Chi sono gli amministratori di RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Segretario
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    151395750001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritishChief Financial Officer179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritishSolicitor182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Segretario
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    HUNT, Clair Elizabeth
    The Pound House
    The Pound
    SL6 9QD Cookham
    Berkshire
    Segretario
    The Pound House
    The Pound
    SL6 9QD Cookham
    Berkshire
    British95562280001
    PEACE, Caroline Amanda
    Harvest Home
    3 Sack Lane Cottage, Sack Lane
    PO22 9PD Lidsey
    West Sussex
    Segretario
    Harvest Home
    3 Sack Lane Cottage, Sack Lane
    PO22 9PD Lidsey
    West Sussex
    British75009050003
    ALPHA SECRETARIAL LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    Segretario nominato
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900004510001
    TELEWEST SECRETARIES LIMITED
    Export House
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Surrey
    Segretario
    Export House
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Surrey
    92359500001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Segretario
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant96956740001
    GRADDEN, Amanda Jane
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    Amministratore
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    EnglandBritishAccountant77425910003
    GUILLEBAUD, David George
    Dormer House
    86 Dropmore Road
    SL1 8AU Burnham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Dormer House
    86 Dropmore Road
    SL1 8AU Burnham
    Buckinghamshire
    BritishManagment Consultant75809710003
    HIRD, David John
    17 Ascot House
    North Third Street
    MK9 3LZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    17 Ascot House
    North Third Street
    MK9 3LZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector69620800001
    HUNT, Lawrence William
    The Pound House
    The Pound
    SL6 9QD Crookham
    Berkshire
    Amministratore
    The Pound House
    The Pound
    SL6 9QD Crookham
    Berkshire
    BritishDirector41558760001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor47785600002
    MOUNTFIELD, Steven
    12 Keyfield Terrace
    AL1 1QH St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    12 Keyfield Terrace
    AL1 1QH St Albans
    Hertfordshire
    BritishManagement Consultant67082920001
    PARKEY, John Derek
    Moor End Cottage
    London Road
    HP1 2RE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Moor End Cottage
    London Road
    HP1 2RE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSystems Consultant58497910003
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor164134250001
    WEBBER, Keith Alan
    The Slade Oasts
    The Slade
    TN3 8HN Lamberhurst
    Kent
    Amministratore
    The Slade Oasts
    The Slade
    TN3 8HN Lamberhurst
    Kent
    United KingdomBritishGeneral Manager30546730001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor140137570002
    ALPHA DIRECT LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    Amministratore delegato nominato
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900001400001
    TELEWEST DIRECTORS LIMITED
    Export House
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Surrey
    Amministratore
    Export House
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Surrey
    92359560001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    RAPID TRAVEL SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 25 feb 2003
    Consegnato il 27 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £25,000.00 or such other sum standing to the credit of the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Boardfence Limited
    Transazioni
    • 27 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 27 feb 2002
    Consegnato il 04 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A first fixed equitable charge over the deposit balance defined as the amount standing to the credit of the deposit account an interest bearing account.
    Persone aventi diritto
    • Landlink PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 27 feb 2002
    Consegnato il 04 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A fixed equitable charge over the deposit balance defined as the amount standing to the credit of the deposit account an interest bearing account.
    Persone aventi diritto
    • Landlink PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 mag 2001
    Consegnato il 26 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan and option agreement dated 10 may 2001
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • (1) Lawrence Hunt (2) David Hurd (3) David Guillebaud (4) Steve Mountfield
    Transazioni
    • 26 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 apr 2000
    Consegnato il 14 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and rapid business solutions limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Agreement
    Creato il 05 mar 1998
    Consegnato il 18 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment of £152,750 by the company to the chargee as provided in clause 5.2 of the agreement if and in the event of exercise by d j hird of certain put options granted by the company under the instrument
    Brevi particolari
    A designated deposit account with national westminster bank PLC (the account) and the monies for the time being held on deposit in the account.the account is numbered 31162096 in the name of the company with national westminster bank villiers house branch,38 the strand,po box 414,london WC2N 5JQ,sort code 60-40-05.
    Persone aventi diritto
    • David John Hird
    Transazioni
    • 18 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0