LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED

LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03131738
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    • Attività di società holding di distribuzione (64204) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AMRESCO UK HOLDINGS LIMITED24 gen 199624 gen 1996
    COILSTAT LIMITED28 nov 199528 nov 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2017, non revisionato

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    It was resolved that the accounts be and are hereby adopted 08/11/2017
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy John Robinson il 15 ago 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 dic 2015

    Stato del capitale al 29 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 dic 2014

    Stato del capitale al 27 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House 233-235 High Street Guildford Surrey GU1 6BJ a 101 Linkfield Street Redhill RH1 6BY in data 27 dic 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 dic 2013

    Stato del capitale al 25 dic 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Jeremy John Robinson il 14 dic 2011

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approve sale of share capital of plt LTD 31/10/2011
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    Stato del capitale al 08 nov 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    Chi sono gli amministratori di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROYER KENNEDY, Matthew Robert Stefan
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Surrey
    Segretario
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Surrey
    BritishAsset Manager92059070002
    ROBINSON, Jeremy John
    Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    101
    England
    Amministratore
    Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    101
    England
    EnglandBritishManager92059060014
    ROYER KENNEDY, Matthew Robert Stefan
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Surrey
    Amministratore
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Surrey
    EnglandBritishAsset Manager92059070002
    HOLMES, Andrew Dominic
    34 Hill Road
    Borstal
    ME1 3NN Rochester
    Kent
    Segretario
    34 Hill Road
    Borstal
    ME1 3NN Rochester
    Kent
    British48442930001
    MACK, John
    20 St Mary's Avenue
    RG26 5UU Bramley
    Hampshire
    Segretario
    20 St Mary's Avenue
    RG26 5UU Bramley
    Hampshire
    British94773940001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Third Floor Narrow Quay House
    Prince Street
    BS1 4AH Bristol
    Avon
    Segretario
    Third Floor Narrow Quay House
    Prince Street
    BS1 4AH Bristol
    Avon
    75423270001
    ADAIR III, Robert Lafayette
    700 North Pearl Street
    Suite 2400
    Dallas
    Texas 75201
    America
    Amministratore
    700 North Pearl Street
    Suite 2400
    Dallas
    Texas 75201
    America
    AmericanPresident Of Amresco46407640003
    BENSON, Mark Paul
    Pantiles
    Copt Hill, Danbury
    CM3 4NN Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Pantiles
    Copt Hill, Danbury
    CM3 4NN Chelmsford
    Essex
    EnglandEnglishInvestment Management95759080001
    CLARK, Charles Edward
    2516 Selwyn Avenue
    Charlotte
    North Carolina
    28209
    United States Of America
    Amministratore
    2516 Selwyn Avenue
    Charlotte
    North Carolina
    28209
    United States Of America
    AmericanDirector46148890002
    HOLMES, Andrew Dominic
    34 Hill Road
    Borstal
    ME1 3NN Rochester
    Kent
    Amministratore
    34 Hill Road
    Borstal
    ME1 3NN Rochester
    Kent
    BritishAccountant48442930001
    LUTZ (JUNIOR), Robert Harold
    700 North Pearl Street
    Suite 2400
    Dallas
    Texas 75201-7424
    America
    Amministratore
    700 North Pearl Street
    Suite 2400
    Dallas
    Texas 75201-7424
    America
    AmericanChairman Of The Board61566980001
    PARFITT, Stuart Howard
    42 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    Amministratore
    42 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    BritishInvestment Management58854160001
    URQUHART, Douglas Russell
    700 N Pearl Suite 2400
    Dallas
    Texas
    75201
    Usa
    Amministratore
    700 N Pearl Suite 2400
    Dallas
    Texas
    75201
    Usa
    BritishSenior Vice President45191680001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Jeremy John Robinson
    Farnham Road
    Holt Pound
    GU10 4LE Farnham
    Rectory Cottage
    England
    06 apr 2016
    Farnham Road
    Holt Pound
    GU10 4LE Farnham
    Rectory Cottage
    England
    No
    Nazionalità: English
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.
    Mr Matthew Robert Stefan Royer-Kennedy
    Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    101
    06 apr 2016
    Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    101
    No
    Nazionalità: English
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Share pledge agreement registered under 398(2) (due diligence) of the companies act 1985
    Creato il 15 set 2003
    Consegnato il 07 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The entire issue share capital of erste leadenhall deutschland gmbh, consisting of one fully paid share in the nominal amount of DM50,000 together with all present and future dividends and profits deriving therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Oval (1878) Limited
    Transazioni
    • 07 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 set 2003
    Consegnato il 16 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Oval (1878) Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 mar 2000
    Consegnato il 31 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company or any of the other chargors (as defined) to each finance party (as defined) under or pursuant to each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 31 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge of shares contained in an amendment and supplement to stock pledge agreement
    Creato il 18 gen 2000
    Consegnato il 03 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with an amended and restated credit agreement dated on or about 18 january 2000 amending and restating the credit agreement dated 12 august 1998 as modified, amended, supplemented and/or restated from time to time, the stock pledge or otherwise howsoever
    Brevi particolari
    All shares in amresco retail ventures I limited, amresco retail ventures ii limited and five other companies listed and all dividends etc in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America, N.A.
    Transazioni
    • 03 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge of shares contained in a supplement iii to loan documents
    Creato il 21 dic 1999
    Consegnato il 07 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a credit agreement dated 12 august 1998
    Brevi particolari
    All shares in amresco retail ventures I limited,amresco retail ventures ii limited and five other companies listed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America,N.A.
    Transazioni
    • 07 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 lug 1996
    Consegnato il 13 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee as agent for otself and the other financial institutions (as defined) which are parties to the facility agreement (as defined) or other loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationsbank of Texas N.A.
    Transazioni
    • 13 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 giu 1996
    Consegnato il 27 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to nationsbank of texas, N.A. (the agent for itself and other financial institutions which are parties, either originally or otherwise, to the facility agreement) under the facility agreement or other loan documents (as defined in the facility agreement dated 25TH april 1996)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationsbank of Texas, N.A. (The "Agent")
    Transazioni
    • 27 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0