LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03131738 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
- Attività di società holding di distribuzione (64204) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 101 Linkfield Street RH1 6BY Redhill |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
AMRESCO UK HOLDINGS LIMITED | 24 gen 1996 | 24 gen 1996 |
COILSTAT LIMITED | 28 nov 1995 | 28 nov 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2017, non revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy John Robinson il 15 ago 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House 233-235 High Street Guildford Surrey GU1 6BJ a 101 Linkfield Street Redhill RH1 6BY in data 27 dic 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jeremy John Robinson il 14 dic 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 08 nov 2011
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYER KENNEDY, Matthew Robert Stefan | Segretario | 101 Linkfield Street RH1 6BY Redhill Surrey | British | Asset Manager | 92059070002 | |||||
ROBINSON, Jeremy John | Amministratore | Linkfield Street RH1 6BY Redhill 101 England | England | British | Manager | 92059060014 | ||||
ROYER KENNEDY, Matthew Robert Stefan | Amministratore | 101 Linkfield Street RH1 6BY Redhill Surrey | England | British | Asset Manager | 92059070002 | ||||
HOLMES, Andrew Dominic | Segretario | 34 Hill Road Borstal ME1 3NN Rochester Kent | British | 48442930001 | ||||||
MACK, John | Segretario | 20 St Mary's Avenue RG26 5UU Bramley Hampshire | British | 94773940001 | ||||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
NQH (CO SEC) LIMITED | Segretario | Third Floor Narrow Quay House Prince Street BS1 4AH Bristol Avon | 75423270001 | |||||||
ADAIR III, Robert Lafayette | Amministratore | 700 North Pearl Street Suite 2400 Dallas Texas 75201 America | American | President Of Amresco | 46407640003 | |||||
BENSON, Mark Paul | Amministratore | Pantiles Copt Hill, Danbury CM3 4NN Chelmsford Essex | England | English | Investment Management | 95759080001 | ||||
CLARK, Charles Edward | Amministratore | 2516 Selwyn Avenue Charlotte North Carolina 28209 United States Of America | American | Director | 46148890002 | |||||
HOLMES, Andrew Dominic | Amministratore | 34 Hill Road Borstal ME1 3NN Rochester Kent | British | Accountant | 48442930001 | |||||
LUTZ (JUNIOR), Robert Harold | Amministratore | 700 North Pearl Street Suite 2400 Dallas Texas 75201-7424 America | American | Chairman Of The Board | 61566980001 | |||||
PARFITT, Stuart Howard | Amministratore | 42 Chiswick Staithe Hartington Road W4 3TP London | British | Investment Management | 58854160001 | |||||
URQUHART, Douglas Russell | Amministratore | 700 N Pearl Suite 2400 Dallas Texas 75201 Usa | British | Senior Vice President | 45191680001 | |||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Jeremy John Robinson | 06 apr 2016 | Farnham Road Holt Pound GU10 4LE Farnham Rectory Cottage England | No |
Nazionalità: English Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
Mr Matthew Robert Stefan Royer-Kennedy | 06 apr 2016 | Linkfield Street RH1 6BY Redhill 101 | No |
Nazionalità: English Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
|
LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Share pledge agreement registered under 398(2) (due diligence) of the companies act 1985 | Creato il 15 set 2003 Consegnato il 07 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The entire issue share capital of erste leadenhall deutschland gmbh, consisting of one fully paid share in the nominal amount of DM50,000 together with all present and future dividends and profits deriving therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 set 2003 Consegnato il 16 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 mar 2000 Consegnato il 31 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company or any of the other chargors (as defined) to each finance party (as defined) under or pursuant to each finance document (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Pledge of shares contained in an amendment and supplement to stock pledge agreement | Creato il 18 gen 2000 Consegnato il 03 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with an amended and restated credit agreement dated on or about 18 january 2000 amending and restating the credit agreement dated 12 august 1998 as modified, amended, supplemented and/or restated from time to time, the stock pledge or otherwise howsoever | |
Brevi particolari All shares in amresco retail ventures I limited, amresco retail ventures ii limited and five other companies listed and all dividends etc in respect thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Pledge of shares contained in a supplement iii to loan documents | Creato il 21 dic 1999 Consegnato il 07 gen 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a credit agreement dated 12 august 1998 | |
Brevi particolari All shares in amresco retail ventures I limited,amresco retail ventures ii limited and five other companies listed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 25 lug 1996 Consegnato il 13 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee as agent for otself and the other financial institutions (as defined) which are parties to the facility agreement (as defined) or other loan documents (as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 07 giu 1996 Consegnato il 27 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to nationsbank of texas, N.A. (the agent for itself and other financial institutions which are parties, either originally or otherwise, to the facility agreement) under the facility agreement or other loan documents (as defined in the facility agreement dated 25TH april 1996) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0