BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED

BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03132958
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED?

    • Attività di gioco d'azzardo e scommesse (92000) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sg House
    1 Dukes Green Avenue
    TW14 0LR Feltham
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CYBERVIEW TECHNOLOGY LIMITED22 feb 199622 feb 1996
    PROGRAMWATCH LIMITED01 dic 199501 dic 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2017

    Stato del capitale al 04 gen 2017

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Cessazione della carica di Stephen George Frater come amministratore in data 31 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Alex Lee Moorcroft come amministratore in data 11 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Sarno come segretario in data 19 giu 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di David Alex Lee Moorcroft come amministratore in data 11 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Alex Lee Moorcroft come amministratore in data 11 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen George Frater come amministratore in data 31 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Sarno come segretario in data 19 giu 2015

    1 pagineTM02

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Jeffrey Lipkin come amministratore in data 02 mag 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 dic 2013

    Stato del capitale al 12 dic 2013

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Nomina di Mr David Alex Lee Moorcroft come amministratore in data 14 giu 2013

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HORNE, Phillip Douglas
    1 Dukes Green Avenue
    TW14 0LR Feltham
    Sg House
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Dukes Green Avenue
    TW14 0LR Feltham
    Sg House
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritish131859010001
    FAITH, Melissa Elizabeth
    258 Slater Lane
    Leyland
    PR26 7SH Preston
    Lancashire
    Segretario
    258 Slater Lane
    Leyland
    PR26 7SH Preston
    Lancashire
    British68041770003
    LINARD, Sylvie
    46 Parkside
    Knightsbridge
    SW1X 7JP London
    Segretario
    46 Parkside
    Knightsbridge
    SW1X 7JP London
    French46176260002
    SARNO, John, Mr.
    Green Lane
    TW4 6BW Hounslow
    99
    United Kingdom
    Segretario
    Green Lane
    TW4 6BW Hounslow
    99
    United Kingdom
    163360730001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    FAITH, Melissa Elizabeth
    258 Slater Lane
    Leyland
    PR26 7SH Preston
    Lancashire
    Amministratore
    258 Slater Lane
    Leyland
    PR26 7SH Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish68041770003
    FRATER, Stephen George
    Green Lane
    TW4 6BW Hounslow
    99
    United Kingdom
    Amministratore
    Green Lane
    TW4 6BW Hounslow
    99
    United Kingdom
    United KingdomBritish140640680001
    GATTO, Jean Marie
    46 Parkside
    Knightsbridge
    SW1X 7JP London
    Amministratore
    46 Parkside
    Knightsbridge
    SW1X 7JP London
    French46176300002
    GREENHILL, Peter Alfred
    53a Candlemas Lane
    HP9 1AE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    53a Candlemas Lane
    HP9 1AE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish78782490001
    JONES, David Gwyn
    26 Lowside Avenue
    BL1 5XQ Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    26 Lowside Avenue
    BL1 5XQ Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritish121475210001
    KENNEDY, Timothy William
    Green Farm
    Main Street
    DE6 3LD Kirk Ireton
    Derbyshire
    Amministratore
    Green Farm
    Main Street
    DE6 3LD Kirk Ireton
    Derbyshire
    United KingdomBritish80561570001
    LINARD, Sylvie
    46 Parkside
    Knightsbridge
    SW1X 7JP London
    Amministratore
    46 Parkside
    Knightsbridge
    SW1X 7JP London
    United KingdomFrench46176260002
    LIPKIN, Jeffrey, Mr.
    Green Lane
    TW4 6BW Hounslow
    99
    United Kingdom
    Amministratore
    Green Lane
    TW4 6BW Hounslow
    99
    United Kingdom
    UsaAmerican163369580001
    MACKENZIE, David Scott Gray
    Flat 6
    49 Rutland Gate
    SW7 1PL London
    Amministratore
    Flat 6
    49 Rutland Gate
    SW7 1PL London
    American71981100001
    MOORCROFT, David Alex Lee
    1 Dukes Green Avenue
    TW14 0LR Feltham
    Sg House
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Dukes Green Avenue
    TW14 0LR Feltham
    Sg House
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritish106528480001
    NANOVICH, Mark Anthony
    Tilbrook
    Tilthams Green
    GU7 3BT Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Tilbrook
    Tilthams Green
    GU7 3BT Godalming
    Surrey
    Australian84674180002
    TIMMIS, Ian, Mr.
    Green Lane
    TW4 6BW Hounslow
    99
    United Kingdom
    Amministratore
    Green Lane
    TW4 6BW Hounslow
    99
    United Kingdom
    United KingdomBritish163372210001
    WHITE, Robert James
    Kembali
    Back Lane
    BB7 4EL Rimington
    Lancashire
    Amministratore
    Kembali
    Back Lane
    BB7 4EL Rimington
    Lancashire
    United KingdomBritish92001210002
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dukes Green Avenue
    TW14 0LR Feltham
    1 Dukes Green Avenue
    England
    06 apr 2016
    Dukes Green Avenue
    TW14 0LR Feltham
    1 Dukes Green Avenue
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione3500514
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BARCREST GROUP TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 31 mag 2006
    Consegnato il 09 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Business premium account, acc/no 70893552. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent security deposit deed
    Creato il 10 mag 2006
    Consegnato il 20 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit of £40,000.00 and other monies comprising the deposit balance.
    Persone aventi diritto
    • Ives Street Developments Limited
    Transazioni
    • 20 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 16 set 2002
    Consegnato il 01 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fairfax Gerrard Holdings Limited
    Transazioni
    • 01 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 lug 2002
    Consegnato il 26 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 dic 2001
    Consegnato il 22 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease referred to in the rent deposit deed
    Brevi particolari
    Deposit of £40,000.
    Persone aventi diritto
    • Ives Street Developments Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 09 apr 2001
    Consegnato il 18 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re cyberview technology limited high interest business account number 00167606. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent security deposit deed
    Creato il 04 gen 1999
    Consegnato il 05 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date
    Brevi particolari
    The sum of £40,000.
    Persone aventi diritto
    • John Anthony Smith and Aaron Trustee Services Limited
    Transazioni
    • 05 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0