REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED

REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREDSPUR (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03133817
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Begbies Traynor, 31st Floor
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LONDON & NEWCASTLE (HOLDINGS) LIMITED22 mag 201222 mag 2012
    LONDON & NEWCASTLE (HOLDINGS) PLC29 feb 199629 feb 1996
    WESTWOOD CORPORATION PLC04 dic 199504 dic 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 dic 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2024
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al17 ott 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma31 ott 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al17 ott 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Indirizzo della sede legale modificato da Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF United Kingdom a C/O Begbies Traynor, 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 08 lug 2024

    3 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    9 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 02 lug 2024

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da 91 Wimpole Street London W1G 0EF England a Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF in data 29 gen 2024

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2023 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022

    8 pagineAA

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Indirizzo della sede legale modificato da 55 Loudoun Road St John's Wood London NW8 0DL a 91 Wimpole Street London W1G 0EF in data 15 gen 2023

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2021 al 30 dic 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2020, non revisionato

    8 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Daniel Soning il 02 lug 2021

    2 pagineCH01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2019, non revisionato

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 031338170016, creata il 27 set 2019

    34 pagineMR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    11 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARNETT, David Melvyn
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor, 31st Floor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor, 31st Floor
    United KingdomBritishCompany Director39132210004
    SONING, Robert Daniel
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor, 31st Floor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor, 31st Floor
    EnglandBritishDirector33156140034
    BERG, Simon Mark
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    British66989000001
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Melton Street
    NW1 2BW London
    22
    Other
    United Kingdom
    Segretario
    Melton Street
    NW1 2BW London
    22
    Other
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02601236
    38636470004
    E L SERVICES LIMITED
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    Segretario
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    78638580003
    FIRST SECRETARIES LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Segretario nominato
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000780001
    PORTLAND REGISTRARS LIMITED
    23 Bridford Mews
    Off Devonshire Street
    W1N 1LQ London
    Segretario
    23 Bridford Mews
    Off Devonshire Street
    W1N 1LQ London
    1361880001
    ADAMS, Jeffrey William
    Little Scords
    Scords Lane, Toys Hill
    TN16 1QE Westerham
    Kent
    Amministratore
    Little Scords
    Scords Lane, Toys Hill
    TN16 1QE Westerham
    Kent
    United KingdomBritishDirector3480850001
    BERG, Simon Mark
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector66989000001
    HENRIKSEN, Troels Bugge
    Bagley Cottage
    Spring Copse
    OX1 5BJ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bagley Cottage
    Spring Copse
    OX1 5BJ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish,DanishGroup Finance Director44984800004
    PATEL, Rakesh
    10 East Hill
    HA9 9PT Wembley Park
    Middlesex
    Amministratore
    10 East Hill
    HA9 9PT Wembley Park
    Middlesex
    United KingdomBritishAccountant27961710002
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    Amministratore
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    EnglandBritishDirector46176700002
    FIRST DIRECTORS LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Amministratore delegato nominato
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000770001
    FIRST SECRETARIES LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Amministratore delegato nominato
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000780001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Loudoun Road
    St. John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Loudoun Road
    St. John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05808635
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 set 2019
    Consegnato il 02 ott 2019
    In corso
    Breve descrizione
    All of redspur (holdings) limited's land, land rights, ip, plant and equipment, present/future goodwill and uncalled capital, as described in more detail in the charge document.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Regent Enterprises Limited
    Transazioni
    • 02 ott 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Secured deposit deed
    Creato il 12 nov 2010
    Consegnato il 17 nov 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The credit balance which includes the initial deposit. Initial deposit means the sum of £36,000 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derwent Valley Central Limited
    Transazioni
    • 17 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Assignment in security
    Creato il 29 mar 2010
    Consegnato il 31 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all right, title and interest in and to the assigned documents and related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 giu 2008
    Consegnato il 13 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit balance being the amount from time to time standing to the credit of the deposit account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Portman Investments (Baker Street) Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over shares
    Creato il 07 ago 2007
    Consegnato il 17 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its rights,title and interest in and to the scheduled securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transazioni
    • 17 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2006
    Consegnato il 04 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 10 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge over shares
    Creato il 28 feb 2006
    Consegnato il 09 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from london & newcastle (southwark) limited and the guarantors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed equitable charge all of its present and future rights title and interest in and to the scheduled securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent security deed
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 03 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £60,000.
    Persone aventi diritto
    • Portman Investments (Baker Street) Limited
    Transazioni
    • 03 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Subordination agreement
    Creato il 20 mag 2003
    Consegnato il 23 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from harley property ventures limited (borrower) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company as a junior creditor under the subordination agreement has undertaken to the agent that if the borrower makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the junior liabilities or the company receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities by way of payment repayment prepayment set off or in any other manner or on account of the enforcement of any security or payment under any guarantee for any of the junior liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mable Commercial Funding Limited (As Agent)
    Transazioni
    • 23 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 mar 1999
    Consegnato il 23 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as 7 8 and 9 paddington street london W1 fixed plant and machinery all fixtures stocks shares bonds certificate all rights.
    Persone aventi diritto
    • Simon Berg and Janine Berg
    Transazioni
    • 23 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 18 giu 1998
    Consegnato il 07 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether pursuant to the facility letter or otherwise and whether owed by the company its subsidiaries or any associated company
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Erinstand Limited
    Transazioni
    • 07 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Creato il 29 gen 1997
    Consegnato il 05 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit iitially of £2,500 credited toaccount number/designation 10045582 with the bank and any addition to that deposit from time to time of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit and charge over securities
    Creato il 27 nov 1996
    Consegnato il 12 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a debenture of even date and/or the memorandum of deposit and charge over securities and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stocks shares debentures bonds warrants and other securities held by the shareholder in the capital of the company at the date of this charge; and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Erinstand Limited
    Transazioni
    • 12 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 set 1996
    Consegnato il 08 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge the whole of the chargors undertaking and all it's property assets and rights present and future.
    Persone aventi diritto
    • Erinstad Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 ago 1996
    Consegnato il 10 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Erinstand Limited
    Transazioni
    • 10 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 lug 2024Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Robert Appleton
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Melissa Nagi
    31st Floor Forty Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor Forty Bank Street
    E14 5NR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0