REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Liquidazione |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03133817 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Begbies Traynor, 31st Floor 40 Bank Street E14 5NR London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LONDON & NEWCASTLE (HOLDINGS) LIMITED | 22 mag 2012 | 22 mag 2012 |
LONDON & NEWCASTLE (HOLDINGS) PLC | 29 feb 1996 | 29 feb 1996 |
WESTWOOD CORPORATION PLC | 04 dic 1995 | 04 dic 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 dic 2023 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2024 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 17 ott 2024 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 31 ott 2024 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 17 ott 2023 |
Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF United Kingdom a C/O Begbies Traynor, 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 08 lug 2024 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 9 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 91 Wimpole Street London W1G 0EF England a Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF in data 29 gen 2024 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2023 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022 | 8 pagine | AA | ||||||||||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 55 Loudoun Road St John's Wood London NW8 0DL a 91 Wimpole Street London W1G 0EF in data 15 gen 2023 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2021 al 30 dic 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2020, non revisionato | 8 pagine | AA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Daniel Soning il 02 lug 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2019, non revisionato | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 031338170016, creata il 27 set 2019 | 34 pagine | MR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 13 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNETT, David Melvyn | Amministratore | 40 Bank Street E14 5NR London C/O Begbies Traynor, 31st Floor | United Kingdom | British | Company Director | 39132210004 | ||||||||
SONING, Robert Daniel | Amministratore | 40 Bank Street E14 5NR London C/O Begbies Traynor, 31st Floor | England | British | Director | 33156140034 | ||||||||
BERG, Simon Mark | Segretario | 12 Adelaide Close HA7 3EL Stanmore Middlesex | British | 66989000001 | ||||||||||
CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Segretario | Melton Street NW1 2BW London 22 Other United Kingdom |
| 38636470004 | ||||||||||
E L SERVICES LIMITED | Segretario | 25 Harley Street W1G 9BR London | 78638580003 | |||||||||||
FIRST SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000780001 | |||||||||||
PORTLAND REGISTRARS LIMITED | Segretario | 23 Bridford Mews Off Devonshire Street W1N 1LQ London | 1361880001 | |||||||||||
ADAMS, Jeffrey William | Amministratore | Little Scords Scords Lane, Toys Hill TN16 1QE Westerham Kent | United Kingdom | British | Director | 3480850001 | ||||||||
BERG, Simon Mark | Amministratore | 12 Adelaide Close HA7 3EL Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Director | 66989000001 | ||||||||
HENRIKSEN, Troels Bugge | Amministratore | Bagley Cottage Spring Copse OX1 5BJ Oxford Oxfordshire | England | British,Danish | Group Finance Director | 44984800004 | ||||||||
PATEL, Rakesh | Amministratore | 10 East Hill HA9 9PT Wembley Park Middlesex | United Kingdom | British | Accountant | 27961710002 | ||||||||
PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Amministratore | 17 Greenfield Drive Fortes Green N2 9AF London | England | British | Director | 46176700002 | ||||||||
FIRST DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000770001 | |||||||||||
FIRST SECRETARIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000780001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redspur Securities Limited | 06 apr 2016 | Loudoun Road St. John's Wood NW8 0DL London 55 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 27 set 2019 Consegnato il 02 ott 2019 | In corso | ||
Breve descrizione All of redspur (holdings) limited's land, land rights, ip, plant and equipment, present/future goodwill and uncalled capital, as described in more detail in the charge document. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Secured deposit deed | Creato il 12 nov 2010 Consegnato il 17 nov 2010 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The credit balance which includes the initial deposit. Initial deposit means the sum of £36,000 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment in security | Creato il 29 mar 2010 Consegnato il 31 mar 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns all right, title and interest in and to the assigned documents and related rights see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 giu 2008 Consegnato il 13 giu 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The deposit balance being the amount from time to time standing to the credit of the deposit account see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge over shares | Creato il 07 ago 2007 Consegnato il 17 ago 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its rights,title and interest in and to the scheduled securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 giu 2006 Consegnato il 04 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 mar 2006 Consegnato il 10 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge over shares | Creato il 28 feb 2006 Consegnato il 09 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from london & newcastle (southwark) limited and the guarantors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed equitable charge all of its present and future rights title and interest in and to the scheduled securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent security deed | Creato il 28 nov 2003 Consegnato il 03 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £60,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Subordination agreement | Creato il 20 mag 2003 Consegnato il 23 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from harley property ventures limited (borrower) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company as a junior creditor under the subordination agreement has undertaken to the agent that if the borrower makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the junior liabilities or the company receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities by way of payment repayment prepayment set off or in any other manner or on account of the enforcement of any security or payment under any guarantee for any of the junior liabilities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 11 mar 1999 Consegnato il 23 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property known as 7 8 and 9 paddington street london W1 fixed plant and machinery all fixtures stocks shares bonds certificate all rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 18 giu 1998 Consegnato il 07 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee whether pursuant to the facility letter or otherwise and whether owed by the company its subsidiaries or any associated company | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of cash deposit | Creato il 29 gen 1997 Consegnato il 05 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The deposit iitially of £2,500 credited toaccount number/designation 10045582 with the bank and any addition to that deposit from time to time of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of deposit and charge over securities | Creato il 27 nov 1996 Consegnato il 12 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under a debenture of even date and/or the memorandum of deposit and charge over securities and on any account whatsoever | |
Brevi particolari All stocks shares debentures bonds warrants and other securities held by the shareholder in the capital of the company at the date of this charge; and all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 set 1996 Consegnato il 08 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of floating charge the whole of the chargors undertaking and all it's property assets and rights present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 05 ago 1996 Consegnato il 10 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
REDSPUR (HOLDINGS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0