EXCELER IRELAND LIMITED
Panoramica
Nome della società | EXCELER IRELAND LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03135336 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EXCELER IRELAND LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova EXCELER IRELAND LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EXCELER IRELAND LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LEGISLATOR 1264 LIMITED | 07 dic 1995 | 07 dic 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EXCELER IRELAND LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per EXCELER IRELAND LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 6 pagine | 1.4 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore | 4 pagine | 1.1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Janette Malham come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EXCELER IRELAND LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 163496070001 | ||||
FEENEY, Martin | Segretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | Finance Director | 53915080001 | |||||
FORD, Colin Andrew | Segretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
HURRELL, Steven Alfred | Segretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
KIME, Sean Thomas | Segretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
MACFARLANE, Rona Jane | Segretario | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158306110001 | |||||||
MCLEISH, William David | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
MURPHY, Charles Furber | Segretario | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
POOLEY, Maureen | Segretario | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | English | Corporate Controller | 51896650001 | |||||
RUTTER, Christopher | Segretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
ABLETT, Julie | Amministratore | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | Company Director | 57906600001 | |||||
BAILEY, Anne | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 118289800001 | ||||
BARLOW, George Edward | Amministratore | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | Company Director | 66559170001 | ||||
BOLOT, Timothy James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 107837080002 | ||||
BRADEEN, Chester Howard | Amministratore | Barberry Cottage Cheapside Road SL5 7QR Ascot Berkshire | Us Citizen | Director | 44958580001 | |||||
BUCHAN, William James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 79917240001 | ||||
COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890003 | ||||
COUSINS, Carol | Amministratore | Crumlin Road Ballinderry Upper BT28 2JX Lisburn 26 County Antrim | Northern Ireland | British | Director | 249170210001 | ||||
DAVIS, Mary | Amministratore | Oakdene 200 Culduthel Road IV2 4BH Inverness | British | Director | 76212360001 | |||||
FARRALL, Elaine Ann | Amministratore | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | Director | 14241020001 | |||||
FEENEY, Martin | Amministratore | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | Finance Director | 53915080001 | ||||
FLAHERTY, James Paul | Amministratore | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | Director | 100530310001 | |||||
FOULKES, Kamma | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 111188390002 | ||||
GOSLING, Mark David | Amministratore | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | Director | 66801660002 | |||||
HAMILTON, Thomas Banks | Amministratore | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | Company Chairman | 79846610001 | |||||
JAP, Chee Miau | Amministratore | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | Director | 101200680001 | ||||
LAWRENCE, Stephen John | Amministratore | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | Director | 5579020001 | ||||
LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | Director | 144822040001 | ||||
MALHAM, Janette | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 91088900004 | ||||
MARSHALL, Diana Jane | Amministratore | 9 The Elms St Faiths Road, Old Catton NR6 7BP Norwich | British | Solicitor | 47799990002 | |||||
MCINTEER, Warren Hill | Amministratore | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Director | 100131200001 | ||||
MCKEEVER, Pauline Ann | Amministratore | 40 Pine Place G5 0BX Glasgow | Britain | British | Managing Director | 91521130001 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 110640170001 | ||||
MOSS, John Rhys | Amministratore | Bryn Y Gwynt Graigfechan LL15 2EY Ruthin Clwyd | British | Director | 36148600001 |
EXCELER IRELAND LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 11 apr 1997 Consegnato il 25 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 11TH april 1997 | |
Brevi particolari The initial deposit, all interest, the deposit account and balance relating to the lease of land at montague private nursing home, 17 church street, portstewart, county londonderry.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 apr 1997 Consegnato il 25 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 11TH april 1997 | |
Brevi particolari The initial deposit, all interest, the deposit account and balance in respect of the lease of land at bramblewood nursing home, 201 gransha road, bangor, county down.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 apr 1997 Consegnato il 25 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 11TH april 1997 | |
Brevi particolari The initial deposit, all interest, the deposit account and balance relating to the lease in respect of land at marina private nursing home, shore road, ballyronan, county londonderry.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 apr 1997 Consegnato il 18 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default | |
Brevi particolari An interest bearing account designated deposit account and the amount standing to the credit of the deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 11 apr 1997 Consegnato il 17 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari First fixed charge on l/h premises situate at rockfield nursing home windmill road newry county down fixed charge over all other freehold leasehold and other immoveable property present and future all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery all patents fees and royalties all goodwill uncalled capital all present and future book debts and floating charge over the remainder of the company's property and assets whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 05 ott 1996 | In corso | Importo garantito All sums payable by the company to the chargee in the event of a default (as defined) | |
Brevi particolari The initial deposit; all interests; the deposit account; and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 05 ott 1996 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises situate at bramblewood nursing home, 201 gransha road, bangor county down; floating charge over .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 05 ott 1996 | In corso | Importo garantito All sums payable by the company to the chargee in the event of a default (as defined) | |
Brevi particolari The initial deposit; all interests; the deposit account; and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 05 ott 1996 | In corso | Importo garantito All sums payable by the company to the chargee in the event of a default (as defined) | |
Brevi particolari The initial deposit; all interests; the deposit account; and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 05 ott 1996 | In corso | Importo garantito All sums payable by the company to the chargee in the event of a default (as defined) | |
Brevi particolari The initial deposit; all interests; the deposit account; and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
EXCELER IRELAND LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0