EXCELER IRELAND LIMITED

EXCELER IRELAND LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXCELER IRELAND LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03135336
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EXCELER IRELAND LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova EXCELER IRELAND LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXCELER IRELAND LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEGISLATOR 1264 LIMITED07 dic 199507 dic 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXCELER IRELAND LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per EXCELER IRELAND LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2012

    Stato del capitale al 18 gen 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    23 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Janette Malham come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di EXCELER IRELAND LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector163496070001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Segretario
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    BritishFinance Director53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Segretario
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Segretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Segretario
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158306110001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Segretario
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    EnglishCorporate Controller51896650001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Amministratore
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    BritishCompany Director57906600001
    BAILEY, Anne
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector118289800001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director66559170001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Barberry Cottage Cheapside Road
    SL5 7QR Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Barberry Cottage Cheapside Road
    SL5 7QR Ascot
    Berkshire
    Us CitizenDirector44958580001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    COUSINS, Carol
    Crumlin Road
    Ballinderry Upper
    BT28 2JX Lisburn
    26
    County Antrim
    Amministratore
    Crumlin Road
    Ballinderry Upper
    BT28 2JX Lisburn
    26
    County Antrim
    Northern IrelandBritishDirector249170210001
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Amministratore
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    BritishDirector76212360001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    BritishDirector14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Amministratore
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    AmericanDirector100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Amministratore
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    BritishDirector66801660002
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Amministratore
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    BritishCompany Chairman79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Amministratore
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporeanDirector101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Amministratore
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritishDirector5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    MALHAM, Janette
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector91088900004
    MARSHALL, Diana Jane
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    Amministratore
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    BritishSolicitor47799990002
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector100131200001
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Amministratore
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritishManaging Director91521130001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector110640170001
    MOSS, John Rhys
    Bryn Y Gwynt
    Graigfechan
    LL15 2EY Ruthin
    Clwyd
    Amministratore
    Bryn Y Gwynt
    Graigfechan
    LL15 2EY Ruthin
    Clwyd
    BritishDirector36148600001

    EXCELER IRELAND LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 11 apr 1997
    Consegnato il 25 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 11TH april 1997
    Brevi particolari
    The initial deposit, all interest, the deposit account and balance relating to the lease of land at montague private nursing home, 17 church street, portstewart, county londonderry.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 apr 1997
    Consegnato il 25 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 11TH april 1997
    Brevi particolari
    The initial deposit, all interest, the deposit account and balance in respect of the lease of land at bramblewood nursing home, 201 gransha road, bangor, county down.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 apr 1997
    Consegnato il 25 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 11TH april 1997
    Brevi particolari
    The initial deposit, all interest, the deposit account and balance relating to the lease in respect of land at marina private nursing home, shore road, ballyronan, county londonderry.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 apr 1997
    Consegnato il 18 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default
    Brevi particolari
    An interest bearing account designated deposit account and the amount standing to the credit of the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transazioni
    • 18 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 11 apr 1997
    Consegnato il 17 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on l/h premises situate at rockfield nursing home windmill road newry county down fixed charge over all other freehold leasehold and other immoveable property present and future all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery all patents fees and royalties all goodwill uncalled capital all present and future book debts and floating charge over the remainder of the company's property and assets whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 05 ott 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums payable by the company to the chargee in the event of a default (as defined)
    Brevi particolari
    The initial deposit; all interests; the deposit account; and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.I PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 05 ott 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises situate at bramblewood nursing home, 201 gransha road, bangor county down; floating charge over .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. I PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 05 ott 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums payable by the company to the chargee in the event of a default (as defined)
    Brevi particolari
    The initial deposit; all interests; the deposit account; and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.I PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 05 ott 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums payable by the company to the chargee in the event of a default (as defined)
    Brevi particolari
    The initial deposit; all interests; the deposit account; and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.I PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 05 ott 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums payable by the company to the chargee in the event of a default (as defined)
    Brevi particolari
    The initial deposit; all interests; the deposit account; and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. I PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)

    EXCELER IRELAND LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0