BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED

BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBANNATYNE FITNESS (6) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03136013
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LIVINGWELL (HOLDINGS) LIMITED03 gen 199603 gen 1996
    DE FACTO 450 LIMITED08 dic 199508 dic 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al03 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma17 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al03 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2024 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

    5 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 031360130010, creata il 20 set 2023

    79 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Victora Lyndsey Brown il 16 giu 2022

    2 pagineCH01

    Nomina di Miss Victora Lyndsey Brown come amministratore in data 16 giu 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Edwin James come segretario in data 15 giu 2022

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Edwin Michael Lewis James come amministratore in data 15 giu 2022

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    5 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Bannatyne Fitness Limited come persona con controllo significativo il 16 lug 2021

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Kenneth Peter Campling come amministratore in data 16 lug 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 031360130009, creata il 31 mar 2021

    79 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Edwin Michael Lewis James il 21 dic 2020

    2 pagineCH01

    Iscrizione dell'ipoteca 031360130008, creata il 05 nov 2020

    78 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA

    Nomina di Miss Karen Wilkinson come amministratore in data 13 mag 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Edwin James il 20 apr 2020

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Justin Musgrove come amministratore in data 30 giu 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Victoria Lyndsey
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    Power House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    Power House
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant282451200001
    HANCOCK, Steven
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    United KingdomEnglishNational Technical Services Director165843870001
    WILKINSON, Karen
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    EnglandBritishCompany Director259996520001
    BUCKNALL, Matthew William
    34 The Mount
    Aspley Guise
    MK17 8EA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    34 The Mount
    Aspley Guise
    MK17 8EA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishAccountant31734540001
    HODGES, Simon
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Secretary66090970001
    HOPKINSON, Scott
    53 Lancaster Drive
    Hadrian Park
    NE28 9TF Wallsend
    Tyne & Wear
    Segretario
    53 Lancaster Drive
    Hadrian Park
    NE28 9TF Wallsend
    Tyne & Wear
    BritishBusinessman193828440001
    HUGHES, Barbara
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    Segretario
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    British45702460001
    JAMES, Edwin
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Segretario
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    192653800001
    WATSON, Christopher Paul
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Segretario
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    BritishAccountant128523570002
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Segretario
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Segretario nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    ARMSTRONG, Graham Nigel
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    EnglandBritishManaging Director157742370001
    BANNATYNE, Duncan Walker
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    United KingdomBritishChairman127705150001
    BELL, Anthony
    169 Coniscliffe Road
    DL3 8EX Darlington
    County Durham
    Amministratore
    169 Coniscliffe Road
    DL3 8EX Darlington
    County Durham
    EnglandBritishDirector68213370001
    BOYDELL, Joanna
    Boreas
    Rushmere Lane
    HP5 3QY Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Boreas
    Rushmere Lane
    HP5 3QY Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishAccountant118883430001
    BROSTER, Stuart Paul
    Charley Chapel Lodge Charley Road
    Charley
    LE12 9YB Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Charley Chapel Lodge Charley Road
    Charley
    LE12 9YB Loughborough
    Leicestershire
    BritishManaging Director52874020001
    BUCKNALL, Matthew William
    34 The Mount
    Aspley Guise
    MK17 8EA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 The Mount
    Aspley Guise
    MK17 8EA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishAccountant31734540001
    BURNET, Keith Alexander
    The Barn Wood Burcote
    NN12 6JR Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Barn Wood Burcote
    NN12 6JR Towcester
    Northamptonshire
    BritishManaging Director109880230001
    CAMPBELL, Graeme James
    11 Hawkshill
    Dellfield Road
    AL1 5HU St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    11 Hawkshill
    Dellfield Road
    AL1 5HU St. Albans
    Hertfordshire
    BritishAccountant66982580004
    CAMPLING, Kenneth Peter
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    United KingdomBritishChief Financial Officer204870700001
    CHESTER, John Geoffrey
    Hatherley House 4 Hatherley Road
    Kew Gardens
    TW9 3LH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    Hatherley House 4 Hatherley Road
    Kew Gardens
    TW9 3LH Richmond
    Surrey
    BritishSolicitor46470520003
    CHESTER, John Geoffrey
    Hatherley House 4 Hatherley Road
    Kew Gardens
    TW9 3LH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    Hatherley House 4 Hatherley Road
    Kew Gardens
    TW9 3LH Richmond
    Surrey
    BritishSolicitor46470520003
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Amministratore
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritishFinance Director780950001
    FITZGIBBON, Patrick William
    Maystone House
    Stoney Hill Paulersbury
    HG5 8EE Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    Maystone House
    Stoney Hill Paulersbury
    HG5 8EE Towcester
    Northamptonshire
    BritishCompany Director97258440003
    HARVEY, Paul Victor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    BritishAccountant116809270001
    HOPKINSON, Scott
    53 Lancaster Drive
    Hadrian Park
    NE28 9TF Wallsend
    Tyne & Wear
    Amministratore
    53 Lancaster Drive
    Hadrian Park
    NE28 9TF Wallsend
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishFinance Director193828440001
    JAMES, Edwin Michael Lewis
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    EnglandBritishSolicitor161571400001
    JAMES, Edwin Michael Lewis
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    EnglandBritishSolicitor161571400003
    JAMES, Paul Frederick
    53 Lonsdale Drive
    Oakwood
    EN2 7LR Enfield
    Amministratore
    53 Lonsdale Drive
    Oakwood
    EN2 7LR Enfield
    BritishSolicitor48791500001
    MCCANN, Christopher Connor
    10 Lonsdale Square
    N1 1EW London
    Amministratore
    10 Lonsdale Square
    N1 1EW London
    BritishCompany Director46495850001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    BritishCompany Director4855250001
    MUSGROVE, Justin
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Powerhouse
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    County Durham
    EnglandEnglishCommercial Director192866520001
    POTTER, Andrew
    21 Water Close
    MK9 6NZ Old Stratford
    Buckinghamshire
    Amministratore
    21 Water Close
    MK9 6NZ Old Stratford
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director109879840001
    REED, Frank Andrew
    46 Crieff Road
    SW18 2EA London
    Amministratore
    46 Crieff Road
    SW18 2EA London
    BritishDirector63761060001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    Power House
    County Durham
    England
    06 apr 2016
    Haughton Road
    DL1 1ST Darlington
    Power House
    County Durham
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03287770
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BANNATYNE FITNESS (6) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 set 2023
    Consegnato il 22 set 2023
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 2023Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 mar 2021
    Consegnato il 01 apr 2021
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 nov 2020
    Consegnato il 06 nov 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 23 dic 2016
    Consegnato il 28 dic 2016
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Secured Parties (as Defined in the Instrument))
    Transazioni
    • 28 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 01 set 2015
    Consegnato il 03 set 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 mar 2014
    Consegnato il 08 mar 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Obligor's debenture
    Creato il 09 ago 2006
    Consegnato il 25 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC the Security Trustee
    Transazioni
    • 25 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 ago 2006
    Consegnato il 15 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to any of the lenders and all other monies due or to become due from the company to the chargee, the agent or any of the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Agent and the Lenders (Thesecurity Trustee)
    Transazioni
    • 15 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 gen 1996
    Consegnato il 17 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 05 gen 1996
    Consegnato il 17 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Charge over shares and all allotments accretions benefits and advantages in respect of the mortgaged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0