ATKINS & CRIPPS LIMITED

ATKINS & CRIPPS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàATKINS & CRIPPS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03140130
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    UHY HACKER YOUNG LLP
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    EW1 YW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    YANKEE LIMITED15 dic 199515 dic 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 mag 2011

    7 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Kemp House Cumnor Hill Oxford Oxfordshire OX2 9PH in data 14 dic 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 nov 2010

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 gen 2010

    Stato del capitale al 11 gen 2010

    • Capitale: GBP 3,200,001
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    17 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    19 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Deliberazione elettiva

    ELRES

    legacy

    3 pagine363a

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine225

    Chi sono gli amministratori di ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Segretario
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    English15662110002
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Amministratore
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandEnglish15662110002
    FINEMAN, Simon
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    Amministratore
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    EnglandBritish61133550002
    DAVIES, Gareth
    Adams Gate
    Mallows Green Road, Manuden
    CM23 1DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Segretario
    Adams Gate
    Mallows Green Road, Manuden
    CM23 1DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British71865070001
    MARRIOTT, Duncan Peter
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    Segretario
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    British50701840001
    PHILLIPS, Lawrence Stephen
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    British11800250003
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Segretario nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    BARRINGER, Paul Brandon
    11 Longstreet Road
    27890 Weldon
    Nc
    United States Of America
    Amministratore
    11 Longstreet Road
    27890 Weldon
    Nc
    United States Of America
    American34440990001
    BARRINGER, Victor
    PO BOX 829
    Green Street Extension
    Weldon
    North Carolina 27890
    Amministratore
    PO BOX 829
    Green Street Extension
    Weldon
    North Carolina 27890
    American50712820003
    BOSTON, Neil Moir, Mr.
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish113486000001
    CAMPOLL, Henry William
    105 Joelene Court
    Rocky Mount
    North Carolina 27803
    Usa
    Amministratore
    105 Joelene Court
    Rocky Mount
    North Carolina 27803
    Usa
    American54149770001
    CONGER, Stephen Halsey
    Box 829
    NC 27890 Weldon
    North Carolina
    Amministratore
    Box 829
    NC 27890 Weldon
    North Carolina
    American47437230001
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Amministratore
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandEnglish15662110002
    GORMAN, James John Stuart
    2 Lime Meadows
    Sewards End
    CB10 2LQ Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    2 Lime Meadows
    Sewards End
    CB10 2LQ Saffron Walden
    Essex
    British47435900001
    HAYWOOD, David James
    Blackberry Cottage
    Turnpike Hill Withersfield
    CB9 7RY Haverhill
    Suffolk
    Amministratore
    Blackberry Cottage
    Turnpike Hill Withersfield
    CB9 7RY Haverhill
    Suffolk
    United KingdomBritish47436450002
    HIPKIN, Ian Robert
    1 Van Gogh Place
    St Ives
    PE27 3HE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    1 Van Gogh Place
    St Ives
    PE27 3HE Huntingdon
    Cambridgeshire
    British78621800001
    MARRIOTT, Duncan Peter
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritish50701840001
    MCGAGIN, Timothy A
    201 Candlewood Road
    Rocky Mount
    North Carolina
    27804
    United States Of America
    Amministratore
    201 Candlewood Road
    Rocky Mount
    North Carolina
    27804
    United States Of America
    Usa40432680002
    SEAY, Ronald Frederick
    21 Pumpkin Lane
    NC 27850 Littleton
    North Carolina
    America
    Amministratore
    21 Pumpkin Lane
    NC 27850 Littleton
    North Carolina
    America
    American47437050001
    THEWLIS, Clive Roger
    8 Harolds Close
    Leafield
    OX29 9PU Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    8 Harolds Close
    Leafield
    OX29 9PU Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritish125543430001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Amministratore delegato nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    ATKINS & CRIPPS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 set 2006
    Consegnato il 07 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 28 gen 2005
    Consegnato il 01 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 50-54, lancaster way, ely, cambridgeshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 04 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 set 2000
    Consegnato il 13 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 set 2000
    Consegnato il 13 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a 95 london road bishops stortford t/n HD316227. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 07 feb 2000
    Consegnato il 10 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined therein
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the deposit of £6,500 held in an interest bearing deposit account in accordance with the deed.
    Persone aventi diritto
    • Southend Property Management Limited
    Transazioni
    • 10 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 07 feb 2000
    Consegnato il 10 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,500 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Units 1 & 2 tamar view industrial estate saltash.
    Persone aventi diritto
    • Southend Property Management Limited
    Transazioni
    • 10 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 03 apr 1997
    Consegnato il 04 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £13,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the deed
    Brevi particolari
    By way of legal charge the sum of £13,000 or such other monies held from time to time pursuant to the deed.
    Persone aventi diritto
    • Southend Property Management Limited
    Transazioni
    • 04 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 gen 1996
    Consegnato il 09 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brevi particolari
    L/H-property k/a sheffield park sawmills uckfield east sussex. F/h-unit 5 bilston industrial estate bilston west midlands t/n-WM421694. F/h-95 london road bishop's stortford t/n-HD316227. F/h-9 burrington way plymouth t/n-DN241029. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Coastal Lumber Company
    Transazioni
    • 09 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture created by the company formerly known as yankee limited
    Creato il 22 gen 1996
    Consegnato il 26 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston
    Transazioni
    • 26 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ATKINS & CRIPPS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 nov 2010Inizio della liquidazione
    01 ott 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael Kiely
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praticante
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praticante
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0