CSG HEALTHCARE LIMITED

CSG HEALTHCARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCSG HEALTHCARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03140174
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CSG HEALTHCARE LIMITED?

    • (8514) /

    Dove si trova CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLUE ARROW CARE LIMITED09 set 200309 set 2003
    WELBECK CARE LIMITED15 dic 199515 dic 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    15 pagineMG01

    legacy

    15 pagineMG01

    Stato del capitale al 29 giu 2012

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 dic 2011

    12 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 1st Floor Pellipar House 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Burchall il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    BritishSolicitor70686070002
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor70686070002
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Segretario
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    BritishDirector26433460001
    BOUVIER, Graham John
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    Segretario
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    BritishAccountant117533510001
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Segretario
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    British64640450003
    MCS SECRETARIES LIMITED
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Segretario nominato
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    900006380001
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Amministratore
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    BritishDirector26433460001
    BOUVIER, Graham John
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    Amministratore
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    BritishAccountant117533510001
    BRAILEY, Geoffrey Ian
    Oakfields Theobalds Road
    RH15 0SS Burgess Hill
    East Sussex
    Amministratore
    Oakfields Theobalds Road
    RH15 0SS Burgess Hill
    East Sussex
    BritishDirector10317690002
    CORNISH, Diana Frederica
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChairman Recruitment6048720001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Amministratore
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritishDirector266121440001
    EDEN, Roger Charles
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector41649520001
    LAKE, David Anthony
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Amministratore
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    EnglandBritishDirector59820940001
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Amministratore
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    United KingdomBritishDirector64640450003
    MCHUGH, Gerard John
    42 Cameford Court
    New Park Road
    SW2 4LJ London
    Amministratore
    42 Cameford Court
    New Park Road
    SW2 4LJ London
    United KingdomIrishNurse42016500001
    PALMER, Christopher Frank
    Hillcrest
    52 Longdon Wood
    BR2 6EW Keston Park
    Kent
    Amministratore
    Hillcrest
    52 Longdon Wood
    BR2 6EW Keston Park
    Kent
    BritishCompany Director44804390001
    ROWLEY, John
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    Amministratore
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director11900790002
    SARSON, Michael Robert
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector27419330001
    MCS NOMINEES LIMITED
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Amministratore delegato nominato
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    900006370001

    CSG HEALTHCARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 23 ago 2012
    Consegnato il 28 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 08 ago 2012
    Consegnato il 14 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 mag 2008
    Consegnato il 17 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 apr 2007
    Consegnato il 12 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (jointly and severally with each security obligor) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 apr 2004
    Consegnato il 12 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee (whether for its own account or as agent or trustee for the finance parties) or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor charges all the mortgaged property all real property the mortgaged property being the freehold property 39 ardwick green north manchester t/n GM654955, l/h property brierley hill shaw house wychbury court two woods lane dudley & l/h property being newcastle suite 2 gunner house by way of fixed charge its insurances its intellectual property rights any beneficial interest claim or entitlement it may have in any pension fund its uncalled capital by way of floating charge all present and future assets property business undertaking and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 12 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 ago 2000
    Consegnato il 20 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities owing by any obligor to the chargee under any of the finance documents whether a). Present or future b). Actual or contingent or c). Owed solely, jointly or severally
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Llc the ("Security Trustee" and "Security Bene Ficiary") and Gmac Commercial Credit Development Limited ("Gmac UK") ("Security Beneficiary")
    Transazioni
    • 20 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 mag 1999
    Consegnato il 20 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 gen 1996
    Consegnato il 19 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kellock Limited
    Transazioni
    • 19 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0