THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale |
| Numero di società | 03142762 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
- Istruzione secondaria tecnica e professionale (85320) / Istruzione
- Altra istruzione n.c.a. (85590) / Istruzione
Dove si trova THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Adcroft Hilton 269 Church Street FY1 3PB Blackpool |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 ago 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 14 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 mar 2022 | 11 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 mar 2021 | 12 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 5 pagine | NDISC | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Appleby Goods Shed Station Yard Appleby in Westmorland Cumbria CA16 6UL a Adcroft Hilton 269 Church Street Blackpool FY1 3PB in data 21 apr 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 10 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Mc Darren come amministratore in data 16 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2019 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 9 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr John Caldwell come amministratore in data 01 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2018 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Malcolm Preston come amministratore in data 30 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2017 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Guy Mills come amministratore in data 30 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Janet Ailsa Hartley come amministratore in data 01 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Maxwell Keetley come amministratore in data 01 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2016 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2016 al 31 ago 2016 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVIETY, Alan | Segretario | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | British | 1714060001 | ||||||
| CALDWELL, John | Amministratore | Hilton CA16 6LU Appleby-In-Westmorland Swindale House United Kingdom | United Kingdom | British | 254965880001 | |||||
| COLLINSON, William Gibson | Amministratore | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | England | British | 140754300002 | |||||
| HARTLEY, Janet Ailsa | Amministratore | Home Farm Buildings CA17 4AP Kirkby Stephen Out Of Eden Eden Cumbria United Kingdom | England | British | 46963080005 | |||||
| MC DARREN, John | Amministratore | Hilton CA16 6LU Appleby-In-Westmorland Fair View England | England | British | 266921600001 | |||||
| MCVIETY, Alan | Amministratore | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | England | British | 1714060001 | |||||
| ROSTRON, Jonathan | Amministratore | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | United Kingdom | English | 127918960001 | |||||
| WOOFF, Eric Stanley Charles | Amministratore | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | United Kingdom | British | 44610730001 | |||||
| ALGIE, Tom Howard | Segretario | Hillfoot Barn Selside BD24 0HZ Settle North Yorkshire | British | 45794310002 | ||||||
| JL NOMINEES TWO LIMITED | Segretario nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
| ALGIE, Tom Howard | Amministratore | Hillfoot Barn Selside BD24 0HZ Settle North Yorkshire | British | 45794310002 | ||||||
| BARTON, John Michael | Amministratore | Haverbrack House LA7 7AH Milnthorpe Cumbria | British | 64425490002 | ||||||
| BENDELOW, Victor Carl | Amministratore | Old School Long Marton CA16 6JP Appleby In Westmorland Cumbria | England | British | 2487670001 | |||||
| CLARK, Robert Lawrence | Amministratore | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | United Kingdom | British | 2770530001 | |||||
| COULTHARD, Leonard | Amministratore | Chapel House Milburn CA10 1TW Penrith Cumbria | England | British | 66835790002 | |||||
| GRAHAM, Duncan Gilmour | Amministratore | Parkburn Colby CA16 6BD Appleby Cumbria | British | 91888120001 | ||||||
| HAYES, Gareth, Dr | Amministratore | 2 Keith Grove Appleby CA16 6XR Cumbria | British | 92840510001 | ||||||
| HOUSTON, Ruth Jane | Amministratore | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | England | British | 157297690001 | |||||
| JOHNSON, Stephen | Amministratore | Wetheriggs Lane CA11 8NG Penrith Ullswater Community College Cumbria United Kingdom | United Kingdom | British | 96329550001 | |||||
| KEETLEY, David Maxwell | Amministratore | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | United Kingdom | British | 147692860001 | |||||
| LANGAN, Ella, Councillor | Amministratore | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Cumbria | British | 95604180001 | |||||
| LANGAN, Ella, Councillor | Amministratore | Kambrela Colby CA16 6BD Appleby Cumbria | Cumbria | British | 95604180001 | |||||
| MILLS, Nicholas Guy | Amministratore | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 157297680001 | |||||
| PACKWOOD, Christopher Francis Harmon | Amministratore | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 83153260001 | |||||
| PATTERSON, Clare | Amministratore | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 102861750001 | |||||
| PORTER, John Eric | Amministratore | Brook House Upton Caldbeck CA7 8EU Wigton Cumbria | United Kingdom | British | 38463950001 | |||||
| PRESTON, Stephen Malcolm | Amministratore | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 66836630001 | |||||
| RHODES, Alexander | Amministratore | The Cottage Croft Ends CA16 6JW Appleby In Westmorland Cumbria | British | 110015210001 | ||||||
| SCOTT, Keith Watson | Amministratore | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 110971270001 | |||||
| SPENCE, Archie Campbell | Amministratore | 14 Hothfield Drive CA16 6HJ Appleby In Westmorland Cumbria | England | British | 66836110001 | |||||
| WILSON, Jennifer | Amministratore | 4 Scaur Close Lazonby CA10 1BT Penrith Cumbria | British | 39719270001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 02 gen 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 02 mar 2010 Consegnato il 05 mar 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0