MPG ASSOCIATES LIMITED

MPG ASSOCIATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMPG ASSOCIATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03145255
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MPG ASSOCIATES LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova MPG ASSOCIATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MPG ASSOCIATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MOTORWAY MEDIA LIMITED11 gen 199611 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di MPG ASSOCIATES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 apr 2010
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 gen 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per MPG ASSOCIATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mag 2016

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mag 2015

    22 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mag 2014

    19 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mag 2013

    19 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mag 2012

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mag 2011

    10 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    11 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 17 mag 2010

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 London Wall London EC2Y 5AB* in data 24 mag 2010

    2 pagineAD01

    legacy

    11 pagineMG01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 feb 2010

    Stato del capitale al 18 feb 2010

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Maclay Murray & Spens Llp il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Lee Robert Barwick il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Gallucci il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 apr 2008

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    3 pagine395

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 apr 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di MPG ASSOCIATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One
    United Kingdom
    Segretario
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One
    United Kingdom
    Forma giuridicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Numero di registrazioneSO300744
    116685100001
    BARWICK, Lee Robert
    90 Welbeck Avenue
    Bedgrove
    HP21 9BN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    90 Welbeck Avenue
    Bedgrove
    HP21 9BN Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish61030870001
    GALLUCCI, Michael Paul
    2 Juniper Grove
    WD17 4RZ Watford
    Herts
    Amministratore
    2 Juniper Grove
    WD17 4RZ Watford
    Herts
    United KingdomBritish46563550003
    GALLUCCI, Michael Paul
    2 Juniper Grove
    WD17 4RZ Watford
    Herts
    Segretario
    2 Juniper Grove
    WD17 4RZ Watford
    Herts
    British46563550003
    SCF SECRETARIES LIMITED LIABILITY COMPANY
    American National Bank Building
    1912 Capital Avenue
    82001 Cheyenne
    Wyoming
    Usa
    Segretario nominato
    American National Bank Building
    1912 Capital Avenue
    82001 Cheyenne
    Wyoming
    Usa
    900010880001
    ANDREA, Costas
    109 Puller Road
    EN5 4HQ Barnet
    Amministratore
    109 Puller Road
    EN5 4HQ Barnet
    British88274810001
    WHITEFIELD, Kevin David
    34 Bedford Street
    WD24 5DT Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    34 Bedford Street
    WD24 5DT Watford
    Hertfordshire
    British80236410001
    S C F (UK) LIMITED
    90-100 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    Amministratore delegato nominato
    90-100 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    900010870001

    MPG ASSOCIATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 apr 2010
    Consegnato il 13 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 apr 2009
    Consegnato il 03 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 12 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the agreement to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 28 dic 2007
    Consegnato il 04 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 27 lug 2005
    Consegnato il 10 ago 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The amount from time to time standing to the credit of the interest earnings deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Inchstar Limited
    Transazioni
    • 10 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture deed
    Creato il 02 giu 2003
    Consegnato il 04 giu 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 04 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 24 ott 2001
    Consegnato il 07 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,777.40 together with other sums due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit account and all money from time to time withdrawn from it in accordance with the deed.
    Persone aventi diritto
    • Inchstar Limited
    Transazioni
    • 07 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 gen 2001
    Consegnato il 18 gen 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all debts and their related rights which fail to vest absolutely and effectively in the security holder.by way of floating charge all the undertaking all the property rights and assets of the company including stock in trade and its uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 18 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 feb 2000
    Consegnato il 24 feb 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a rent deposit deed and an underlease of even date
    Brevi particolari
    The amount standing to the credit of a designated deposit account under the terms of a rent deposit deed dated 21 february 2000.
    Persone aventi diritto
    • Lr Investments Limited
    Transazioni
    • 24 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 27 ago 1999
    Consegnato il 04 set 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date herewith
    Brevi particolari
    £2,000.
    Persone aventi diritto
    • Frogmore Developments Limited
    Transazioni
    • 04 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)

    MPG ASSOCIATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 mag 2010Inizio della liquidazione
    30 apr 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Lloyd Christopher Biscoe
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex
    Praticante
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex
    Jamie Taylor
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend On Sea Essex
    Praticante
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend On Sea Essex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0