NORTH NELSON LIMITED

NORTH NELSON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNORTH NELSON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03145734
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NORTH NELSON LIMITED?

    • (5190) /

    Dove si trova NORTH NELSON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O ROBSON LAIDLER LLP
    Fernwood House Fernwood Road Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NORTH NELSON LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FONE LOGISTICS LIMITED03 giu 199603 giu 1996
    HAVANAH DISTRIBUTION LIMITED12 gen 199612 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di NORTH NELSON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per NORTH NELSON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 ago 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Atley Way North Nelson Industr Cramlington Northumberland NE23 1WA in data 26 apr 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 31 mar 2010

    LRESEX

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2008

    23 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    5 pagineMG02

    legacy

    5 pagineMG02

    legacy

    5 pagineMG02

    legacy

    5 pagineMG02

    legacy

    5 pagineMG02

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed fone logistics LIMITED\certificate issued on 10/11/09
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name10 nov 2009

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 ott 2009

    RES15

    Bilancio annuale redatto al 07 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2007

    23 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2006

    22 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NORTH NELSON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FITZPATRICK, Michael Thomas
    35 Grosvenor Place
    NE29 0NH North Shields
    Tyne & Wear
    Segretario
    35 Grosvenor Place
    NE29 0NH North Shields
    Tyne & Wear
    Irish99961200001
    FITZPATRICK, Michael Thomas
    35 Grosvenor Place
    NE29 0NH North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    35 Grosvenor Place
    NE29 0NH North Shields
    Tyne & Wear
    United KingdomIrish99961200001
    GILLESPIE, Ian William
    Heathery Edge
    Newton
    NE43 7XB Stocksfield
    Northumberland
    Amministratore
    Heathery Edge
    Newton
    NE43 7XB Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritish39788280002
    DAVIS, Christine
    12 Brockwell Drive
    NE39 2PX Rowlands Gill
    Tyne & Wear
    Segretario
    12 Brockwell Drive
    NE39 2PX Rowlands Gill
    Tyne & Wear
    British46005770002
    GILLESPIE, Ian William
    Havanah House
    East Farm Court
    NE23 9LF Cramlington
    Northumberland
    Segretario
    Havanah House
    East Farm Court
    NE23 9LF Cramlington
    Northumberland
    British39788280001
    GILLESPIE, Ian William
    Havanah House
    East Farm Court
    NE23 9LF Cramlington
    Northumberland
    Segretario
    Havanah House
    East Farm Court
    NE23 9LF Cramlington
    Northumberland
    British39788280001
    GUPPY, Richard David
    The Old Chapel
    West Woodburn
    NE48 2RA Hexham
    Northumberland
    Segretario
    The Old Chapel
    West Woodburn
    NE48 2RA Hexham
    Northumberland
    British83393010001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BOWER, Michael John
    Ingle Manor
    Moor Park Beckwithshaw
    HG3 1QN Harrogate
    Amministratore
    Ingle Manor
    Moor Park Beckwithshaw
    HG3 1QN Harrogate
    EnglandBritish141547520001
    FAWCETT, Gary
    Barleycote Hall
    Ilkley Road, Riddlesden
    BD20 5PN Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Barleycote Hall
    Ilkley Road, Riddlesden
    BD20 5PN Keighley
    West Yorkshire
    British77042190001
    FULLER, Robert
    Fenrother Grange Fenrother
    Longhorsley
    NE61 3DP Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Fenrother Grange Fenrother
    Longhorsley
    NE61 3DP Morpeth
    Northumberland
    British36842350002
    HUTCHINGS, Keith
    5 Shillingridge Park
    Frieth Road
    SL7 2QX Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    5 Shillingridge Park
    Frieth Road
    SL7 2QX Marlow
    Buckinghamshire
    British97358820001
    JOHNSON, Guy
    Ladham House
    Ladham Road
    TN17 1DB Goudhurst
    Kent
    Amministratore
    Ladham House
    Ladham Road
    TN17 1DB Goudhurst
    Kent
    British98774840001
    LEA, Nicholas
    3 Peel Court
    Front Street
    NE13 6EA Seaton Burn
    Tyne & Wear
    Amministratore
    3 Peel Court
    Front Street
    NE13 6EA Seaton Burn
    Tyne & Wear
    British99431060001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    NORTH NELSON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 25 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alan George Robson (Debenture Holder)
    Transazioni
    • 25 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 25 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter John Stoker (Debenture Holder)
    Transazioni
    • 25 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 25 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ian William Gillespie (Debenture Holder)
    Transazioni
    • 25 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 25 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Paul Graham Bell, Peter John Stoker, Richard Murrough Wilson and Rachel Elizabeth Mayall(Debenture Holder)
    Transazioni
    • 25 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 18 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 nov 2003
    Consegnato il 15 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 giu 2003
    Consegnato il 26 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 12TH october 1999 issued by the company
    Creato il 08 gen 2003
    Consegnato il 15 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 28 august 2002 between the company and the bank of scotland and all book and other debts the subject thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 ago 2002
    Consegnato il 04 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge (supplemental to a debenture dated 12 october 1999)
    Creato il 05 nov 1999
    Consegnato il 11 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Brevi particolari
    All right title and interest in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 25 june 1996 between the company and singer & friedlander factors limited and all book and other debts the subject thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 ott 1999
    Consegnato il 29 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 nov 1996
    Consegnato il 12 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 giu 1996
    Consegnato il 05 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and asets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Factors Limited
    Transazioni
    • 05 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NORTH NELSON LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 dic 2010Data di scioglimento
    31 mar 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Martin Daley
    Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    William Paxton
    Fernwood House Fernwood Road
    NE2 1TJ Jesmond
    Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    Fernwood House Fernwood Road
    NE2 1TJ Jesmond
    Newcastle Upon Tyne

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0