COMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED

COMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03147400
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova COMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O HOUSING21
    The Triangle
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMPLETE HOLDINGS LIMITED17 gen 199617 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di COMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per COMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Mr Leslie Patrick Clarke come amministratore in data 01 feb 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen John Perry come amministratore in data 01 feb 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 gen 2012

    Stato del capitale al 10 gen 2012

    • Capitale: GBP 67,500
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Claimar Care Group 40 Vicarage Road Edgbaston Birmingham B15 3EZ United Kingdom

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Richard Humphries come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Dominic Rothwell come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sheila Bowden come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagineMG04

    Nomina di Mr Stephen John Perry come amministratore

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    10 gen 2011Inconsistency At the time of filing, this document appeared to be inconsistent with other information filed against the company. The document is a duplicate of an AP01(ef) registered on 05/08/10.

    Cessazione della carica di Nicholas Townend come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen John Perry come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas Townend come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas Townend come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Sarah Delyth Hampton come segretario

    1 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da Claimar House 40 Vicarage Road Edgbaston Birmingham West Midlands B15 3EZ in data 10 giu 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 10 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2008

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAMPTON, Sarah Delyth
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    151897390001
    CLARKE, Leslie Patrick
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish123317050001
    HUMPHRIES, Richard
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish156574000001
    RAGUVARAN, Pushpa
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish146887380001
    ROTHWELL, Dominic
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish156573860001
    BORTHWICK, John Leslie
    19 Wynbank Close Miles Green
    Bignall End
    ST7 8LR Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    19 Wynbank Close Miles Green
    Bignall End
    ST7 8LR Stoke On Trent
    Staffordshire
    British41795900001
    BRUNT, Sarah
    Avoncroft Road
    Stoke Heath
    B60 4NG Bromsgrove
    67
    West Midlands
    Segretario
    Avoncroft Road
    Stoke Heath
    B60 4NG Bromsgrove
    67
    West Midlands
    British130638250001
    BURTON, David
    Edney House
    Poachers Gate, Dawley
    TF4 3PZ Telford
    Shropshire
    Segretario
    Edney House
    Poachers Gate, Dawley
    TF4 3PZ Telford
    Shropshire
    British86446240001
    HART, James Thomas Lewis
    15 Cremorne Road
    Four Oaks
    B75 5AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    15 Cremorne Road
    Four Oaks
    B75 5AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British22609770001
    JACKSON, David
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    British280628560001
    TOWNEND, Nicholas Adam
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    British154577090001
    WHITAKER, Anne Michelle
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British38436390001
    ADAMS, Mark Ian
    3 D'Abernon Close
    Esher Place
    KT10 8PT Esher
    Surrey
    Amministratore
    3 D'Abernon Close
    Esher Place
    KT10 8PT Esher
    Surrey
    British100846890003
    BALL, Helen Louise
    3 Aston Court Mews
    TF11 8TP Shifnal
    Salop
    Amministratore
    3 Aston Court Mews
    TF11 8TP Shifnal
    Salop
    British63123880001
    BORTHWICK, John Leslie
    19 Wynbank Close Miles Green
    Bignall End
    ST7 8LR Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    19 Wynbank Close Miles Green
    Bignall End
    ST7 8LR Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish41795900001
    BOWDEN, Sheila Elisabeth
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish86445700001
    BURTON, David
    40 Vicarage Road
    Edgbaston
    B15 3EZ Birmingham
    Claimar House
    West Midlands
    Amministratore
    40 Vicarage Road
    Edgbaston
    B15 3EZ Birmingham
    Claimar House
    West Midlands
    EnglandBritish236544840001
    HALES, Mark
    40 Vicarage Road
    Edgbaston
    B15 3EZ Birmingham
    Claimar House
    West Midlands
    Amministratore
    40 Vicarage Road
    Edgbaston
    B15 3EZ Birmingham
    Claimar House
    West Midlands
    EnglandBritish115420980001
    HANDLEY, Ian Malcolm
    39 Borrowcop Lane
    WS14 9DG Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    39 Borrowcop Lane
    WS14 9DG Lichfield
    Staffordshire
    British47137740001
    HART, James Thomas Lewis
    15 Cremorne Road
    Four Oaks
    B75 5AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    15 Cremorne Road
    Four Oaks
    B75 5AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish22609770001
    JACKSON, David
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish280628560001
    PERRY, Stephen John
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish252596450001
    SCANDRETT, Barbara
    Rhallt Lane
    SY21 9HR Welshpool Lane
    The Rhallt Farm
    Powys
    Amministratore
    Rhallt Lane
    SY21 9HR Welshpool Lane
    The Rhallt Farm
    Powys
    WalesBritish161743730001
    TAYLOR, Hannah
    15 Queens Street
    Castlefields
    SY1 2JX Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    15 Queens Street
    Castlefields
    SY1 2JX Shrewsbury
    Salop
    British111898540001
    TAYLOR, Leigh
    35 High Street
    Coalport
    TF8 7HT Telford
    Salop
    Amministratore
    35 High Street
    Coalport
    TF8 7HT Telford
    Salop
    EnglandBritish70272950003
    TOWNEND, Nicholas Adam
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish154577090001
    WHITAKER, Anne Michelle
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish38436390001
    WHITAKER, Robert Alston
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish37434920001

    COMPLETE CASE MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 01 nov 2007
    Consegnato il 09 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for National Westminster Bank PLC(The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 09 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 30 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 24 apr 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Insurer bupa health assurance limited policy no. H225864601/CTV8/001 life assured mr david burton sum assured £250,000.00. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignement of keyman life policy
    Creato il 24 apr 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Insurer st james's place UK PLC policy no 27C66C7 life assured ms barbara scandrett sum assured £1,000.000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 apr 2007
    Consegnato il 04 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 04 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 dic 2002
    Consegnato il 27 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities due or to become due from the company to the chargee or the noteholders (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Capital Limited
    Transazioni
    • 27 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 dic 2002
    Consegnato il 21 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Occupational underlease of suite number G.02 (2F) ground floor grosvenor house central park telford title number SL29178, occupational underlease of unit number 403 (formerly known as unit 34B) fourth floor grosvenor house central park telford title number SL29178. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 feb 1998
    Consegnato il 24 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ott 1997
    Consegnato il 13 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0