RUMSON ESTATES LIMITED

RUMSON ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRUMSON ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03147910
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RUMSON ESTATES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova RUMSON ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Molineux House
    Russell Gardens
    SS11 8BL Wickford
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RUMSON ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (1048) LIMITED18 gen 199618 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di RUMSON ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per RUMSON ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A6ZNLUUB

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA
    AFFOFU34

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 feb 2011

    Stato del capitale al 22 feb 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01
    XTTLCRU1

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    11 pagineAA
    ADKUNP8L

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X14YBI81

    Nomina di David Mark Wernick come amministratore

    2 pagineAP01
    RWNUGERP

    Nomina di Stephen George Potter come segretario

    2 pagineAP03
    AIWS2EGC

    Indirizzo della sede legale modificato da The Quadrant 99 Parkway Avenue Sheffield South Yorkshire S9 4WG in data 30 ott 2009

    1 pagineAD01
    AIWS4EGE

    Cessazione della carica di William Kellie come amministratore

    1 pagineTM01
    AIWS3EGD

    Cessazione della carica di William Kellie come segretario

    1 pagineTM02
    PZ84FEG9

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA
    AIU03EGJ

    legacy

    3 pagine395
    A1KHTD7P

    legacy

    4 pagine363a
    ARN1T7RG

    legacy

    1 pagine287
    ARN257RT

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    11 pagineAA
    ABICJ3EF

    legacy

    3 pagine363a
    X8BE50PO

    legacy

    3 pagine363a
    XTPIPYVF

    legacy

    1 pagine288a
    XTPIRYVH

    legacy

    1 pagine288b
    XTPIQYVG

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    11 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RUMSON ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    POTTER, Stephen George
    Goat Hall Lane
    Galleywood
    CM2 8PH Chelmsford
    2 Lodge Farm Cottages
    Essex
    Segretario
    Goat Hall Lane
    Galleywood
    CM2 8PH Chelmsford
    2 Lodge Farm Cottages
    Essex
    British146628530001
    WERNICK, David Mark
    Mimms Lane
    EN6 3LY Ridge
    Falcon Lodge
    Hertfordshire
    Amministratore
    Mimms Lane
    EN6 3LY Ridge
    Falcon Lodge
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector11702660003
    ANDERSON, John
    27 Croft Road
    SW19 2NF London
    Segretario
    27 Croft Road
    SW19 2NF London
    British53485800001
    ATKINS, Zoe Rachel
    3 Burden Way
    GU2 9RB Guildford
    Surrey
    Segretario
    3 Burden Way
    GU2 9RB Guildford
    Surrey
    British72201740002
    BALE, Andrew Paul
    157 York Road
    GU22 7XS Woking
    Surrey
    Segretario
    157 York Road
    GU22 7XS Woking
    Surrey
    BritishAccountant76005930001
    BALE, Andrew Paul
    157 York Road
    GU22 7XS Woking
    Surrey
    Segretario
    157 York Road
    GU22 7XS Woking
    Surrey
    BritishAccountant76005930001
    DENTON, Mark Edward
    7 Turner Close
    GU4 7JN Guildford
    Surrey
    Segretario
    7 Turner Close
    GU4 7JN Guildford
    Surrey
    British57643460001
    FINLAYSON, Anita
    107 Winston Avenue
    Branksome
    BH12 1PB Poole
    Dorset
    Segretario
    107 Winston Avenue
    Branksome
    BH12 1PB Poole
    Dorset
    British114302540001
    FISHER, Lisa Joanne
    80 The Mount
    GU2 5JB Guildford
    Surrey
    Segretario
    80 The Mount
    GU2 5JB Guildford
    Surrey
    BritishAccountant52428620001
    KELLIE, William Brian
    3 The Highlands
    Ossett
    WF5 8LD Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    3 The Highlands
    Ossett
    WF5 8LD Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director192867130001
    LLEWELYN, Rhydian Hedd
    57 New Road
    Chilworth
    GU4 8LP Guildford
    Surrey
    Segretario
    57 New Road
    Chilworth
    GU4 8LP Guildford
    Surrey
    BritishAccountant93073060001
    PRICE, Andrew Christopher
    The Briars
    36 Pilkington Avenue
    B72 1LD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    The Briars
    36 Pilkington Avenue
    B72 1LD Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishAccountant120883400001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    CLARKSON, Jeremy David
    17 Oak Ridge
    LS22 6GT Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Oak Ridge
    LS22 6GT Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector29690770001
    COMPSON, Stephen Edwin John
    Blenheim Cottage Elm Corner
    Ockham
    GU23 6PX Woking
    Surrey
    Amministratore
    Blenheim Cottage Elm Corner
    Ockham
    GU23 6PX Woking
    Surrey
    EnglandBritishDirector45307380002
    HICKTON, Neil Colin
    6 Francis Road
    Market Lavington
    SN10 4DH Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    6 Francis Road
    Market Lavington
    SN10 4DH Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector46336920001
    KELLIE, William Brian
    3 The Highlands
    Ossett
    WF5 8LD Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 The Highlands
    Ossett
    WF5 8LD Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCo Director192867130001
    MOORE, Thomas
    Gransden House
    Cooks Bank Acton Trussell
    ST17 0RF Stafford
    Amministratore
    Gransden House
    Cooks Bank Acton Trussell
    ST17 0RF Stafford
    EnglandBritishCompany Director83054600001
    NEWMAN, Amanda Jane
    Longridge
    South Road St Georges Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Longridge
    South Road St Georges Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishAccount Executive56633850001
    NEWMAN, John Watson
    Longridge
    St George's Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Longridge
    St George's Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director3088870002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    RUMSON ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 set 2009
    Consegnato il 12 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 31 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or newship group limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings on the south west side of school lane chandlers ford hampshire t/n HP163177.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 set 1996
    Consegnato il 04 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Robbins myers unit school lane chandlers ford hampshire t/n: HP163177.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 04 giu 1996
    Consegnato il 12 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever .
    Brevi particolari
    All the undertaking property assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 giu 1996
    Consegnato il 12 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever .
    Brevi particolari
    Units 1-8 cartwright road pin green industrial estate stevenage hertfordshire t/n:- HD159282.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0