BJ TRUSTEE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBJ TRUSTEE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03148118
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BJ TRUSTEE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BJ TRUSTEE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BJ TRUSTEE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BJ IT SERVICES LIMITED26 mar 200426 mar 2004
    PROTEK I.T. SERVICES LIMITED27 mar 199627 mar 1996
    BROOMCO (1032) LIMITED18 gen 199618 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di BJ TRUSTEE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per BJ TRUSTEE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 nov 2023

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cody Technology Park Ively Road Farnborough Hampshire GU14 0LX a C/O Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ in data 23 nov 2023

    2 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per James Stephen Field il 17 apr 2023

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di James Richard Willis come amministratore in data 21 ott 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Alexander Haworth come amministratore in data 13 set 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di James Stephen Field come segretario in data 25 ago 2022

    2 pagineAP03

    Nomina di James Stephen Field come amministratore in data 25 ago 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Heather Anne Cashin come amministratore in data 25 ago 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jon Messent come segretario in data 11 ago 2022

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    7 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Boldon James Holdings Limited come persona con controllo significativo il 22 giu 2020

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Martin Leslie Sugden come amministratore in data 22 giu 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BJ TRUSTEE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FIELD, James Stephen
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    Segretario
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    299524340001
    CASHIN, Heather Anne
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    Amministratore
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    EnglandBritish298988210001
    FIELD, James Stephen
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    Amministratore
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    EnglandBritish298479420002
    BOARDMAN, Lynton David
    Cherwell
    Forest Drive
    KT20 6LU Kingswood
    Surrey
    Segretario
    Cherwell
    Forest Drive
    KT20 6LU Kingswood
    Surrey
    British72633900005
    FRENCH, Rodger Ernest Arthur
    1 Northumberland Avenue
    HP21 7HG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 Northumberland Avenue
    HP21 7HG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British23883290001
    HACKETT, Katherine Ann
    The Hawthorns
    Harbour Lane, Wheelton
    PR6 8JS Chorley
    Lancashire
    Segretario
    The Hawthorns
    Harbour Lane, Wheelton
    PR6 8JS Chorley
    Lancashire
    British105793600003
    MESSENT, Jon
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    Segretario
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    British157180340001
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    British100207880001
    SUGDEN, Martin Leslie
    Hill House
    Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    Segretario
    Hill House
    Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    British63057200002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    ADCOCK, Miles John, Dr
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Amministratore
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritish177091950001
    BEAUMONT, Paul Anthony
    Church Croft
    Church Lane
    HX5 9QB Elland
    West Yorkshire
    Amministratore
    Church Croft
    Church Lane
    HX5 9QB Elland
    West Yorkshire
    EnglandBritish89531160001
    BENNETT, Simon David, Dr
    Manor Farm House
    Main Street, Westbury
    NN13 5JR Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    Manor Farm House
    Main Street, Westbury
    NN13 5JR Brackley
    Northamptonshire
    United KingdomBritish74322240001
    BUTCHER, Geoffrey Charles
    Fosse Way
    Harbury
    CV33 9JP Nr Leamington Spa
    Leamington Hall Farm
    Warwickshire
    Amministratore
    Fosse Way
    Harbury
    CV33 9JP Nr Leamington Spa
    Leamington Hall Farm
    Warwickshire
    EnglandBritish134288870001
    CORDING, Stephen
    114 Norsey Road
    CM11 1BH Billericay
    Essex
    Amministratore
    114 Norsey Road
    CM11 1BH Billericay
    Essex
    EnglandBritish92462850001
    EVANS, Spencer Gareth
    Buckingham Gate
    SW1E 6PD London
    85
    Amministratore
    Buckingham Gate
    SW1E 6PD London
    85
    EnglandBritish148976480001
    GARROD, Kim Maria Michelle
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish130666660002
    GARROD, Michael James Baring
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Amministratore
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritish224052010001
    HAWORTH, John Alexander
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Amministratore
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritish246944280001
    HUMPHRIES, Nicholas James
    8 Maple Fold
    New Farnley
    LS12 5RX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Maple Fold
    New Farnley
    LS12 5RX Leeds
    West Yorkshire
    British45629590001
    LING, Christopher Adam
    85 Buckingham Gate
    London
    SW1E 6PD
    Amministratore
    85 Buckingham Gate
    London
    SW1E 6PD
    EnglandBritish65865520001
    MACFARLANE, Andrew John
    Gatehouse
    Ranters Lane
    TN17 1HL Kilndown
    Kent
    Amministratore
    Gatehouse
    Ranters Lane
    TN17 1HL Kilndown
    Kent
    EnglandBritish13050510001
    MCNAUGHT-DAVIS, James
    28 King Street
    SW1 London
    Amministratore
    28 King Street
    SW1 London
    Irish65403370002
    PALETHORPE, Mark John
    2 Fitzwilliams Court
    Greatford
    PE9 4QQ Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    2 Fitzwilliams Court
    Greatford
    PE9 4QQ Stamford
    Lincolnshire
    British125949860001
    PALSER, Adam Howard, Dr
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish248968590001
    PICON, Jaime
    Apartado 60649
    Caracas 10
    FOREIGN Venezuela
    Amministratore
    Apartado 60649
    Caracas 10
    FOREIGN Venezuela
    Venezuelan46984050001
    RAZDAN, Sanjay
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Amministratore
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandCanadian165471790001
    SUGDEN, Martin Leslie
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Amministratore
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritish63057200004
    WATTERSON, Ian George Walter
    314 Barkham Road
    RG41 4DA Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    314 Barkham Road
    RG41 4DA Wokingham
    Berkshire
    British81496480001
    WILLIS, James Richard
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Amministratore
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritish243854880001
    WOOD, Martin James
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Amministratore
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritish45073950001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BJ TRUSTEE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gyldan 11 Limited
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    England
    06 apr 2016
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies In England And Wales
    Numero di registrazione5357068
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BJ TRUSTEE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 02 giu 2005
    Consegnato il 16 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee or to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Isis Equity Partners PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 giu 2005
    Consegnato il 16 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 02 giu 2005
    Consegnato il 08 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 lug 2003
    Consegnato il 11 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 mar 1998
    Consegnato il 15 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee and debenture and all sums which have become due and shall not have been paid under a loan agreement dated 31 march 1998
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Greyrock Business Credit
    Transazioni
    • 15 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1998
    Consegnato il 07 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BJ TRUSTEE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 nov 2023Inizio della liquidazione
    23 mag 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gareth Rutt Morris
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Praticante
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Matthew Whitchurch
    Kings Orchard 1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Praticante
    Kings Orchard 1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0