BJ TRUSTEE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BJ TRUSTEE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03148118 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BJ TRUSTEE LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova BJ TRUSTEE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BJ TRUSTEE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BJ IT SERVICES LIMITED | 26 mar 2004 | 26 mar 2004 |
| PROTEK I.T. SERVICES LIMITED | 27 mar 1996 | 27 mar 1996 |
| BROOMCO (1032) LIMITED | 18 gen 1996 | 18 gen 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BJ TRUSTEE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per BJ TRUSTEE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Cody Technology Park Ively Road Farnborough Hampshire GU14 0LX a C/O Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ in data 23 nov 2023 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per James Stephen Field il 17 apr 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Richard Willis come amministratore in data 21 ott 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Alexander Haworth come amministratore in data 13 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di James Stephen Field come segretario in data 25 ago 2022 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di James Stephen Field come amministratore in data 25 ago 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Heather Anne Cashin come amministratore in data 25 ago 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jon Messent come segretario in data 11 ago 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Boldon James Holdings Limited come persona con controllo significativo il 22 giu 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Leslie Sugden come amministratore in data 22 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BJ TRUSTEE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD, James Stephen | Segretario | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Trading Limited | 299524340001 | |||||||
| CASHIN, Heather Anne | Amministratore | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Trading Limited | England | British | 298988210001 | |||||
| FIELD, James Stephen | Amministratore | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Trading Limited | England | British | 298479420002 | |||||
| BOARDMAN, Lynton David | Segretario | Cherwell Forest Drive KT20 6LU Kingswood Surrey | British | 72633900005 | ||||||
| FRENCH, Rodger Ernest Arthur | Segretario | 1 Northumberland Avenue HP21 7HG Aylesbury Buckinghamshire | British | 23883290001 | ||||||
| HACKETT, Katherine Ann | Segretario | The Hawthorns Harbour Lane, Wheelton PR6 8JS Chorley Lancashire | British | 105793600003 | ||||||
| MESSENT, Jon | Segretario | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | British | 157180340001 | ||||||
| PERKS, Timothy Howard | Segretario | Bowdown Farmhouse Burys Bank Road Greenham RG19 8DA Newbury Berkshire | British | 100207880001 | ||||||
| SUGDEN, Martin Leslie | Segretario | Hill House Heckfield RG27 0JY Hook Hampshire | British | 63057200002 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
| ADCOCK, Miles John, Dr | Amministratore | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 177091950001 | |||||
| BEAUMONT, Paul Anthony | Amministratore | Church Croft Church Lane HX5 9QB Elland West Yorkshire | England | British | 89531160001 | |||||
| BENNETT, Simon David, Dr | Amministratore | Manor Farm House Main Street, Westbury NN13 5JR Brackley Northamptonshire | United Kingdom | British | 74322240001 | |||||
| BUTCHER, Geoffrey Charles | Amministratore | Fosse Way Harbury CV33 9JP Nr Leamington Spa Leamington Hall Farm Warwickshire | England | British | 134288870001 | |||||
| CORDING, Stephen | Amministratore | 114 Norsey Road CM11 1BH Billericay Essex | England | British | 92462850001 | |||||
| EVANS, Spencer Gareth | Amministratore | Buckingham Gate SW1E 6PD London 85 | England | British | 148976480001 | |||||
| GARROD, Kim Maria Michelle | Amministratore | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | United Kingdom | British | 130666660002 | |||||
| GARROD, Michael James Baring | Amministratore | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 224052010001 | |||||
| HAWORTH, John Alexander | Amministratore | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 246944280001 | |||||
| HUMPHRIES, Nicholas James | Amministratore | 8 Maple Fold New Farnley LS12 5RX Leeds West Yorkshire | British | 45629590001 | ||||||
| LING, Christopher Adam | Amministratore | 85 Buckingham Gate London SW1E 6PD | England | British | 65865520001 | |||||
| MACFARLANE, Andrew John | Amministratore | Gatehouse Ranters Lane TN17 1HL Kilndown Kent | England | British | 13050510001 | |||||
| MCNAUGHT-DAVIS, James | Amministratore | 28 King Street SW1 London | Irish | 65403370002 | ||||||
| PALETHORPE, Mark John | Amministratore | 2 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | British | 125949860001 | ||||||
| PALSER, Adam Howard, Dr | Amministratore | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | United Kingdom | British | 248968590001 | |||||
| PICON, Jaime | Amministratore | Apartado 60649 Caracas 10 FOREIGN Venezuela | Venezuelan | 46984050001 | ||||||
| RAZDAN, Sanjay | Amministratore | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | Canadian | 165471790001 | |||||
| SUGDEN, Martin Leslie | Amministratore | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 63057200004 | |||||
| WATTERSON, Ian George Walter | Amministratore | 314 Barkham Road RG41 4DA Wokingham Berkshire | British | 81496480001 | ||||||
| WILLIS, James Richard | Amministratore | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 243854880001 | |||||
| WOOD, Martin James | Amministratore | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 45073950001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BJ TRUSTEE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyldan 11 Limited | 06 apr 2016 | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BJ TRUSTEE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creato il 02 giu 2005 Consegnato il 16 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the chargee or to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 02 giu 2005 Consegnato il 16 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 02 giu 2005 Consegnato il 08 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 08 lug 2003 Consegnato il 11 lug 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 31 mar 1998 Consegnato il 15 apr 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee and debenture and all sums which have become due and shall not have been paid under a loan agreement dated 31 march 1998 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 mar 1998 Consegnato il 07 apr 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
BJ TRUSTEE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0