WM (2002) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWM (2002) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03150483
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WM (2002) LIMITED?

    • (6420) /

    Dove si trova WM (2002) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place, Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WM (2002) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IMS TELECOM LIMITED30 ott 199830 ott 1998
    WORLD TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LIMITED20 mag 199620 mag 1996
    NUMBERASSET LIMITED24 gen 199624 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di WM (2002) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per WM (2002) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    1 pagine4.43
    A5W8XPNS

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Varie

    O/C - replacement of liquidator
    6 pagineMISC

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Notifica di revoca dell'ordinanza di amministrazione

    3 pagine2.19

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    legacy

    1 pagine287

    Notifica del risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23

    Relazione sulle proposte dell'amministratore

    23 pagine2.21

    legacy

    1 pagine287

    Memorandum e Statuto

    24 pagineMA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed ims telecom LIMITED\certificate issued on 15/02/02
    3 pagineCERTNM

    Ordinanza di amministrazione

    4 pagine2.7

    Notifica dell'ordinanza di amministrazione

    1 pagine2.6

    legacy

    5 pagine395

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di WM (2002) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOWE, Trevor Bruce
    82 Main Street
    LS29 6HS Menston
    West Yorkshire
    Segretario
    82 Main Street
    LS29 6HS Menston
    West Yorkshire
    English72313700001
    RYAN, Liam Francis
    9 Goole Road
    Swinefleet
    DN14 8AR Goole
    North Humberside
    Amministratore
    9 Goole Road
    Swinefleet
    DN14 8AR Goole
    North Humberside
    EnglandBritishCompany Director46971060001
    BELL, Kevin
    24 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    24 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishBusiness Management68546980001
    FOXFORD, Michael John
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    Segretario
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    British96216260001
    FROGGATT, Nicholas Paul
    2 Leadhall Crescent
    HG2 9NG Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Leadhall Crescent
    HG2 9NG Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant31066820001
    HALL, David
    22 Milton Rough
    Acton Bridge
    CW8 2RF Northwich
    Cheshire
    Segretario
    22 Milton Rough
    Acton Bridge
    CW8 2RF Northwich
    Cheshire
    BritishChartered Sec6387590001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BELL, Kevin
    24 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    24 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishBusiness Management68546980001
    FROGGATT, Nicholas Paul
    2 Leadhall Crescent
    HG2 9NG Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Leadhall Crescent
    HG2 9NG Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant31066820001
    HALL, David
    22 Milton Rough
    Acton Bridge
    CW8 2RF Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    22 Milton Rough
    Acton Bridge
    CW8 2RF Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Sec6387590001
    HOFFMAN, Lawrence
    Winton Lodge 11 Bentinck Road
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Winton Lodge 11 Bentinck Road
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor35569030002
    KNOWLES, Keith
    Bowden View
    Moss Lane, Ollerton
    WA16 8SW Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Bowden View
    Moss Lane, Ollerton
    WA16 8SW Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishManager65992090002
    NIELD, Gary Eric
    161 Mottram Road
    SK15 2QU Stalybridge
    Cheshire
    Amministratore
    161 Mottram Road
    SK15 2QU Stalybridge
    Cheshire
    BritishBusiness Management61786060001
    ROUSE, Paul Michael
    Derwent Lodge
    Main Street
    YO4 5BN Sutton Upon Derwent
    York North Yorkshire
    Amministratore
    Derwent Lodge
    Main Street
    YO4 5BN Sutton Upon Derwent
    York North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director30392350001
    SMITH, Norman Harold
    14 Gorse Lane
    Oadby
    LE2 4RQ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    14 Gorse Lane
    Oadby
    LE2 4RQ Leicester
    Leicestershire
    BritishSales Management43126170001
    WILSON, William Robinson
    Brendene, Layton Avenue
    Rawdon
    LS19 6QQ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Brendene, Layton Avenue
    Rawdon
    LS19 6QQ Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director29588110002
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    WM (2002) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 gen 2002
    Consegnato il 02 feb 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V. (UK Branch)
    Transazioni
    • 02 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 31 ott 2000
    Consegnato il 08 nov 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transazioni
    • 08 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Single debenture
    Creato il 26 mar 1998
    Consegnato il 07 apr 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Generale Bank N.V.-Generale De Banque S.A.
    Transazioni
    • 07 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Single debenture
    Creato il 16 dic 1997
    Consegnato il 17 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited
    Transazioni
    • 17 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 mag 1997
    Consegnato il 10 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • David Hall
    Transazioni
    • 10 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 mag 1997
    Consegnato il 10 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Keith Knowles
    Transazioni
    • 10 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 giu 1996
    Consegnato il 10 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WM (2002) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 feb 2002Inizio dell'amministrazione
    14 mag 2004Amministrazione scaricata
    Ordine di amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Garry Wilson
    Arthur Andersen
    1 City Square
    Leeds
    Ls1 2al
    Praticante
    Arthur Andersen
    1 City Square
    Leeds
    Ls1 2al
    Simon Allport
    Bank House
    9 Charlotte Street
    M1 4EU Manchester
    Praticante
    Bank House
    9 Charlotte Street
    M1 4EU Manchester
    2
    DataTipo
    07 mar 2011Data di scioglimento
    26 mar 2004Data della petizione
    30 nov 2010Conclusione della liquidazione
    14 mag 2004Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Garry Wilson
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praticante
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Simon Allport
    Ernst & Young
    Cloth Hall Court
    14 King Street
    Leeds Ls1 2jn
    Praticante
    Ernst & Young
    Cloth Hall Court
    14 King Street
    Leeds Ls1 2jn
    Garry Wilson
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praticante
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0