UNION SNACK LIMITED
Panoramica
Nome della società | UNION SNACK LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03150564 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di UNION SNACK LIMITED?
- Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere
Dove si trova UNION SNACK LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di UNION SNACK LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per UNION SNACK LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 13 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 15 giu 2016
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2014 al 30 giu 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate Stanley County Durham DH9 9XS | 1 pagine | AD04 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Patrick Hebron come amministratore in data 31 ago 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Giles Alexander Glidden Henderson come amministratore in data 31 ago 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Hebron come segretario in data 31 ago 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Mark Christopher Thorpe come amministratore in data 31 ago 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Nicholas Robert Bunker come amministratore in data 31 ago 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Robinson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ian Lavery come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di UNION SNACK LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNKER, Nicholas Robert | Amministratore | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 129281570003 | ||||
HENDERSON, Giles Alexander Glidden | Amministratore | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham | England | British | Finance Director | 175409820001 | ||||
THORPE, Mark Christopher | Amministratore | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham | England | British | M.D. Operations | 177004550001 | ||||
ANTHONY, Caroline Jane | Segretario | 12 St Helens Terrace Spittal TD15 1RJ Berwick Upon Tweed Northumberland | British | 40750480002 | ||||||
BRUNTON, Mark John | Segretario | 201 Broadway Cullercoats NE30 3DQ North Shields Tyne & Wear | British | Solicitor | 5143550001 | |||||
HEBRON, Nigel | Segretario | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham | 178312210001 | |||||||
HOPE, Kathryn | Segretario | 28 George Street Blackhill DH8 0AE Consett County Durham | British | 82812540001 | ||||||
HOPE, Kathryn | Segretario | 28 George Street Blackhill DH8 0AE Consett County Durham | British | Accountant | 82812540001 | |||||
WALLEY, Clive | Segretario | 24 Craven Way Boroughbridge YO51 9UR York | English | Company Director | 67457790002 | |||||
WALLEY, Clive | Segretario | 24 Craven Way Boroughbridge YO51 9UR York | English | 67457790002 | ||||||
WEATHERHEAD, Michael John | Segretario | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham | British | Company Director | 127902340001 | |||||
WILKIE, George | Segretario | 3 Denwick Close DH2 3TL Chester Le Street County Durham | British | Business Adviser | 46330890001 | |||||
JL NOMINEES TWO LIMITED | Segretario nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
CHARLESWORTH, Thomas | Amministratore | 4 Heatheryhill Lowgate NE46 2NZ Hexham Northumberland | British | Adviser | 56654630002 | |||||
HEBRON, Nigel Patrick | Amministratore | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham | England | British | Accountant | 71676680002 | ||||
KOESTER, Klaus Juergen | Amministratore | Im Grunde 2a Bergisch-Gladbach 51427 Germany | German | Director | 118475380001 | |||||
LAVERY, Ian | Amministratore | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham | England | British | Operations Director | 149907970001 | ||||
PIKE, John Hadley | Amministratore | The White House Leazes Lane NE46 3AZ Hexham Northumberland | United Kingdom | British | Company Director | 43948830001 | ||||
ROBINSON, Richard Anthony | Amministratore | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham | England | British | Managing Director | 161051380001 | ||||
RYDER, Calum | Amministratore | 32 Belle Vue Avenue NE3 1AH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Manufacturing Director | 47991630002 | |||||
VINCENT, John Martin | Amministratore | 11 Milburn Close NE46 2NY Hexham Northumberland | United Kingdom | British | Sales Marketing | 100749920001 | ||||
WALLEY, Clive | Amministratore | 24 Craven Way Boroughbridge YO51 9UR York | England | English | Accountant | 67457790002 | ||||
WEATHERHEAD, Michael John | Amministratore | Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9XS Stanley County Durham | United Kingdom | British | Company Director | 127902340001 | ||||
WILKIE, George | Amministratore | 3 Denwick Close DH2 3TL Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 46330890001 | ||||
WOLF, Werner Josef, Dr | Amministratore | Wolfsbind Str.24 Brugin 71379 FOREIGN Germany | German | Director | 69973550001 | |||||
JL NOMINEES ONE LIMITED | Amministratore delegato nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007210001 |
UNION SNACK LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Chattel mortgage | Creato il 10 feb 1997 Consegnato il 18 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Model 99 "lump buster" serial number tba supplied by jacobson minneapolis,spangler water meter ,rpm dough extruder ebc-40-03-177-96081 supplied by reading pretzel machinery corp,rpm die sets with compression heads supplied by reading pretzel machinery corp and all other items of plant and equipment as detailed in the appendix to form 395 to include items 1 to 22 inclusive. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 09 ago 1996 Consegnato il 19 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Items of plant and equipment as detailed in the schedule on the reverse of the form 395 to include items numbers 1 to 20 (inclusive). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 25 mar 1996 Consegnato il 29 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0