UNION SNACK LIMITED

UNION SNACK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUNION SNACK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03150564
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UNION SNACK LIMITED?

    • Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova UNION SNACK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di UNION SNACK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per UNION SNACK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2016

    3 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 giu 2016

    • Capitale: GBP 0.10
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account and capital redemption reserve 09/06/2016
    RES13

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2016

    Stato del capitale al 28 gen 2016

    • Capitale: GBP 65,367.4
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2014 al 30 giu 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 gen 2015

    Stato del capitale al 30 gen 2015

    • Capitale: GBP 65,367.4
    SH01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Unit Bt95/4 Tanfield Lea Industrial Estate Stanley County Durham DH9 9XS

    1 pagineAD04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Nigel Patrick Hebron come amministratore in data 31 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Giles Alexander Glidden Henderson come amministratore in data 31 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nigel Hebron come segretario in data 31 ago 2014

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Mark Christopher Thorpe come amministratore in data 31 ago 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Nicholas Robert Bunker come amministratore in data 31 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Robinson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Lavery come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 gen 2014

    Stato del capitale al 24 gen 2014

    • Capitale: GBP 65,367.4
    SH01

    Chi sono gli amministratori di UNION SNACK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUNKER, Nicholas Robert
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Amministratore
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    United KingdomBritishChief Executive Officer129281570003
    HENDERSON, Giles Alexander Glidden
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Amministratore
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    EnglandBritishFinance Director175409820001
    THORPE, Mark Christopher
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Amministratore
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    EnglandBritishM.D. Operations177004550001
    ANTHONY, Caroline Jane
    12 St Helens Terrace
    Spittal
    TD15 1RJ Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    Segretario
    12 St Helens Terrace
    Spittal
    TD15 1RJ Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    British40750480002
    BRUNTON, Mark John
    201 Broadway
    Cullercoats
    NE30 3DQ North Shields
    Tyne & Wear
    Segretario
    201 Broadway
    Cullercoats
    NE30 3DQ North Shields
    Tyne & Wear
    BritishSolicitor5143550001
    HEBRON, Nigel
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Segretario
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    178312210001
    HOPE, Kathryn
    28 George Street
    Blackhill
    DH8 0AE Consett
    County Durham
    Segretario
    28 George Street
    Blackhill
    DH8 0AE Consett
    County Durham
    British82812540001
    HOPE, Kathryn
    28 George Street
    Blackhill
    DH8 0AE Consett
    County Durham
    Segretario
    28 George Street
    Blackhill
    DH8 0AE Consett
    County Durham
    BritishAccountant82812540001
    WALLEY, Clive
    24 Craven Way
    Boroughbridge
    YO51 9UR York
    Segretario
    24 Craven Way
    Boroughbridge
    YO51 9UR York
    EnglishCompany Director67457790002
    WALLEY, Clive
    24 Craven Way
    Boroughbridge
    YO51 9UR York
    Segretario
    24 Craven Way
    Boroughbridge
    YO51 9UR York
    English67457790002
    WEATHERHEAD, Michael John
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Segretario
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    BritishCompany Director127902340001
    WILKIE, George
    3 Denwick Close
    DH2 3TL Chester Le Street
    County Durham
    Segretario
    3 Denwick Close
    DH2 3TL Chester Le Street
    County Durham
    BritishBusiness Adviser46330890001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Segretario nominato
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    CHARLESWORTH, Thomas
    4 Heatheryhill
    Lowgate
    NE46 2NZ Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    4 Heatheryhill
    Lowgate
    NE46 2NZ Hexham
    Northumberland
    BritishAdviser56654630002
    HEBRON, Nigel Patrick
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Amministratore
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    EnglandBritishAccountant71676680002
    KOESTER, Klaus Juergen
    Im Grunde 2a
    Bergisch-Gladbach
    51427
    Germany
    Amministratore
    Im Grunde 2a
    Bergisch-Gladbach
    51427
    Germany
    GermanDirector118475380001
    LAVERY, Ian
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Amministratore
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    EnglandBritishOperations Director149907970001
    PIKE, John Hadley
    The White House
    Leazes Lane
    NE46 3AZ Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    The White House
    Leazes Lane
    NE46 3AZ Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director43948830001
    ROBINSON, Richard Anthony
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Amministratore
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    EnglandBritishManaging Director161051380001
    RYDER, Calum
    32 Belle Vue Avenue
    NE3 1AH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    32 Belle Vue Avenue
    NE3 1AH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishManufacturing Director47991630002
    VINCENT, John Martin
    11 Milburn Close
    NE46 2NY Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    11 Milburn Close
    NE46 2NY Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishSales Marketing100749920001
    WALLEY, Clive
    24 Craven Way
    Boroughbridge
    YO51 9UR York
    Amministratore
    24 Craven Way
    Boroughbridge
    YO51 9UR York
    EnglandEnglishAccountant67457790002
    WEATHERHEAD, Michael John
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Amministratore
    Unit Bt95/4
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director127902340001
    WILKIE, George
    3 Denwick Close
    DH2 3TL Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    3 Denwick Close
    DH2 3TL Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant46330890001
    WOLF, Werner Josef, Dr
    Wolfsbind Str.24
    Brugin 71379
    FOREIGN Germany
    Amministratore
    Wolfsbind Str.24
    Brugin 71379
    FOREIGN Germany
    GermanDirector69973550001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    UNION SNACK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattel mortgage
    Creato il 10 feb 1997
    Consegnato il 18 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Model 99 "lump buster" serial number tba supplied by jacobson minneapolis,spangler water meter ,rpm dough extruder ebc-40-03-177-96081 supplied by reading pretzel machinery corp,rpm die sets with compression heads supplied by reading pretzel machinery corp and all other items of plant and equipment as detailed in the appendix to form 395 to include items 1 to 22 inclusive. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 09 ago 1996
    Consegnato il 19 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Items of plant and equipment as detailed in the schedule on the reverse of the form 395 to include items numbers 1 to 20 (inclusive). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 mar 1996
    Consegnato il 29 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0