OAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED

OAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03150712
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova OAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gamma House Laser Quay, Culpeper Close
    Medway City Estate
    ME2 4HU Rochester
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di OAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per OAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 28 feb 2013

    11 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 28 feb 2012

    11 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 28 feb 2011

    11 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 21 feb 2010

    11 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 28 feb 2009

    11 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 28 feb 2008

    11 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 28 feb 2013

    11 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 28 feb 2008

    11 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 28 feb 2009

    11 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 28 feb 2011

    11 pagineAAMD

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 apr 2014

    Stato del capitale al 18 apr 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 28 feb 2013

    3 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 28 feb 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 28 feb 2011

    4 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 21 feb 2012 al 28 feb 2011

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 12E Manor Road London N16 5SA* in data 05 ott 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di OAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANDHU, Jasbir
    Laser Quay, Culpeper Close
    Medway City Estate
    ME2 4HU Rochester
    Gamma House
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Laser Quay, Culpeper Close
    Medway City Estate
    ME2 4HU Rochester
    Gamma House
    Kent
    United Kingdom
    British39443920002
    SANDHU, Jasbir
    Pear Tree Lane
    Shorne
    DA12 3JS Gravesend
    Buckleberry
    Kent
    Amministratore
    Pear Tree Lane
    Shorne
    DA12 3JS Gravesend
    Buckleberry
    Kent
    United KingdomBritishDirector39443920003
    BURGESS, Richard Frank Stark
    16 Berkeley Street
    W1X 5AE London
    Segretario
    16 Berkeley Street
    W1X 5AE London
    British35178560001
    HARRIS, Jackie
    109 Mounts Road
    DA9 9ND Greenhithe
    Kent
    Segretario
    109 Mounts Road
    DA9 9ND Greenhithe
    Kent
    BritishPersonal Assistant73842140002
    PHAGURA, Kalbir
    6 Cobham Terrace
    Bean Road
    DA9 9HZ Greenhithe
    Kent
    Segretario
    6 Cobham Terrace
    Bean Road
    DA9 9HZ Greenhithe
    Kent
    BritishCompany Secretary46776200001
    SCF SECRETARIES LIMITED LIABILITY COMPANY
    American National Bank Building
    1912 Capital Avenue
    82001 Cheyenne
    Wyoming
    Usa
    Segretario nominato
    American National Bank Building
    1912 Capital Avenue
    82001 Cheyenne
    Wyoming
    Usa
    900010880001
    DOSANJH, Harmail Singh
    24 Sussex Road
    DA8 1JB Erith
    Kent
    Amministratore
    24 Sussex Road
    DA8 1JB Erith
    Kent
    BritishHydrolic Engineer61912860001
    PHAGURA, Kalbir
    109 Mounts Road
    DA9 9ND Greenhithe
    Kent
    Amministratore
    109 Mounts Road
    DA9 9ND Greenhithe
    Kent
    BritishBuilder50971740002
    SANDHU, Jasbir
    6 Milton Road
    DA12 2RE Gravesend
    Kent
    Amministratore
    6 Milton Road
    DA12 2RE Gravesend
    Kent
    BritishDirector39443920002
    SANDHU, Jasbir
    6 Cobham Terrace
    Bean Road
    DA9 9HZ Greenhithe
    Kent
    Amministratore
    6 Cobham Terrace
    Bean Road
    DA9 9HZ Greenhithe
    Kent
    EnglandBritishCompany Director46776160001
    SHERGILL, Kulvinder
    109 Mounts Road
    DA9 9ND Greenhithe
    Kent
    Amministratore
    109 Mounts Road
    DA9 9ND Greenhithe
    Kent
    United KingdomBritishPost Officer Worker80324520001
    S C F (UK) LIMITED
    90-100 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    Amministratore delegato nominato
    90-100 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    900010870001

    OAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 18 apr 2007
    Consegnato il 01 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 4 lion yard, 34 ospringe street faversham.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 21 mar 2007
    Consegnato il 23 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Granville court deste road ramsgate.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 ott 2006
    Consegnato il 24 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 02 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    £1,400,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a granville court deste road ramsgate t/no K816137.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 28 giu 2004
    Consegnato il 07 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land adjoining the south west side of granville house, victoria parade, ramsgate now k/a granville court. By way of assignment the benefit of all covenants and rights relating to the above property and the benefit of all easements, assigns all the right title and interest of the company in each and every policy of insurance and assigns the plant, machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment implement and utensils of the company now and in the future.
    Persone aventi diritto
    • United Trust Bank LTD
    Transazioni
    • 07 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 giu 2004
    Consegnato il 07 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • United Trust Bank LTD
    Transazioni
    • 07 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 26 set 2002
    Consegnato il 12 ott 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2002
    Consegnato il 06 set 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a granville house, victoria parade, ramsgate.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1999
    Consegnato il 19 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 369 canterbury street gillingham kent t/n K502712 and K659262.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 22 apr 1999
    Consegnato il 23 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    49 neville road croydon surrey t/n SY194363. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 29 set 1997
    Consegnato il 03 ott 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land at chancery lane london t/n K742718, K194368 and K748335. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 18 apr 1997
    Consegnato il 24 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 1996
    Consegnato il 04 apr 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 4, 45/49 grove road, chatham, kent t/no: K708310.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 14 mar 1996
    Consegnato il 20 mar 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    26 durham rise plumstead l/b of greenwich t/no SGL287509.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1996
    Consegnato il 22 mar 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 6 141 auckland road south norwood l/borough of croydon t/n sgl 410330.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)

    OAKLEIGH DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 feb 2015Inizio della liquidazione
    07 feb 2018Conclusione della liquidazione
    01 ago 2014Data della petizione
    16 mag 2018Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Chatham Maritime
    West Wing Ground Floor The Observatory
    Brunel
    ME4 4AF Chatham Maritime
    Kent
    Praticante
    West Wing Ground Floor The Observatory
    Brunel
    ME4 4AF Chatham Maritime
    Kent

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0