MONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED

MONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03151667
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova MONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Meyer House, No. 5 Bromford Gate Bromford Lane
    Heartlands
    B24 8DW Birmingham
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MONTAGUE L MEYER LIMITED31 gen 200331 gen 2003
    LAWGRA (NO.344) LIMITED26 gen 199626 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di MONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 feb 2011

    Stato del capitale al 08 feb 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2011 al 31 dic 2010

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Glenn Mccardle come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da PO Box 3 Rippleway Wharf River Road Barking Essex IG11 0DU in data 07 set 2010

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Mark Bryan Stokes come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael Trippick come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    8 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    7 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed montague l meyer LIMITED\certificate issued on 24/09/07
    3 pagineCERTNM

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di MONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STOKES, Mark Bryan
    Bromford Lane
    Heartlands
    B24 8DW Birmingham
    Meyer House, No. 5 Bromford Gate
    United Kingdom
    Segretario
    Bromford Lane
    Heartlands
    B24 8DW Birmingham
    Meyer House, No. 5 Bromford Gate
    United Kingdom
    153908790001
    STOKES, Mark Bryan
    Oulton Grove
    ST15 8WB Stone
    1
    Staffordshire
    Amministratore
    Oulton Grove
    ST15 8WB Stone
    1
    Staffordshire
    United KingdomBritishGrp Finance Dir100570310002
    BETTS, Paul Alex
    11 Gleaners Close
    Weavering
    ME14 5ST Maidstone
    Kent
    Segretario
    11 Gleaners Close
    Weavering
    ME14 5ST Maidstone
    Kent
    BritishCompany Director6870750001
    HUNTER, Jacqueline Louise
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    Segretario
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    BritishChartered Accountant147493940002
    TRIPPICK, Michael Wilfred, Dr
    67 The Paddock
    Thorley Park
    CM23 4JW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Segretario
    67 The Paddock
    Thorley Park
    CM23 4JW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishFinancial Controller105269430002
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Segretario nominato
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    BETTS, Paul Alex
    11 Gleaners Close
    Weavering
    ME14 5ST Maidstone
    Kent
    Amministratore
    11 Gleaners Close
    Weavering
    ME14 5ST Maidstone
    Kent
    EnglandBritishCompany Director6870750001
    CHAMBERS, Paul Jonathan
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector1188140001
    CUNNINGHAM, Tracy Ann
    58 Tufnell Park Road
    N7 0DT London
    Amministratore delegato nominato
    58 Tufnell Park Road
    N7 0DT London
    British900012310001
    HUNTER, Jacqueline Louise
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    Amministratore
    Norwood Cottage
    Norwood Lane
    DA13 0YE Meopham
    Kent
    EnglandBritishFinancial Director147493940002
    LEVERETT, Gavin Louis
    43 Woodmere Drive
    Old Whittington
    S41 9TE Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    43 Woodmere Drive
    Old Whittington
    S41 9TE Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector121663960001
    MCCARDLE, Glenn
    Wirral Cottage
    High Street Wroot
    DN9 2BU Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Wirral Cottage
    High Street Wroot
    DN9 2BU Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector33766950004
    PORT, David Charles
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector58053990001
    SIMPSON, Charles Frank
    Flowers Mead
    St Ives Road Hemingford Grey
    PE18 9DX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Flowers Mead
    St Ives Road Hemingford Grey
    PE18 9DX Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director6870800002
    TRILK, Nigel Craig, Dr
    Common Farm
    OX25 1TE Blackthorn
    Oxfordshire
    Amministratore
    Common Farm
    OX25 1TE Blackthorn
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector147333690001
    WEBB, Colin
    26 Sale Drive
    Clothall Common
    SG7 6NS Baldock
    Hertfordshire
    Amministratore
    26 Sale Drive
    Clothall Common
    SG7 6NS Baldock
    Hertfordshire
    BritishDirector57547850002

    MONTAGUE L. MEYER PANELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 mar 2005
    Consegnato il 26 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 mag 1996
    Consegnato il 30 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0