FREEDOM4 ACCESS LIMITED
Panoramica
Nome della società | FREEDOM4 ACCESS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03152569 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova FREEDOM4 ACCESS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Daisy House Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Lancashire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PIPEX COMMUNICATIONS BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | 18 nov 2003 | 18 nov 2003 |
FIRSTNET SERVICES LIMITED | 30 gen 1996 | 30 gen 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per FREEDOM4 ACCESS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Robinson Riley come amministratore in data 24 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Notifica di Daisy Communications Ltd come persona con controllo significativo il 21 mar 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Freedom4 Limited come persona con controllo significativo il 21 mar 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 14 apr 2016
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr David Lewis Mcglennon il 30 gen 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Daisy House Suite 1 Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR a Daisy House Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR in data 15 mag 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Gareth Kirkwood come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGLENNON, David Lewis | Segretario | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | 149418700001 | |||||||
SMITH, Stephen Alan | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 161471940001 | ||||
COBLEY, Bryan Nicholas | Segretario | 40 West Park Avenue LS8 2EB Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 66305750001 | |||||
GIBSON, Carolyn Ann | Segretario | 10 Hanger Hill KT13 9XR Weybridge Surrey | British | 59736770001 | ||||||
KENNEDY, Christina Lillian | Segretario | Walnut House Walnut Gardens Claydon OX17 1NA Banbury Oxfordshire | British | 7909160003 | ||||||
PORTER, Stewart Charles | Segretario | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | British | Finance Director | 67037910004 | |||||
PORTER, Stewart Charles | Segretario | 1 Triangle Business Park HP22 5BL Stoke Mandeville Buckinghamshire | British | 67037910002 | ||||||
SANDERSON, Clive Anthony | Segretario | 47 Oakdale Glen HG1 2JY Harrogate North Yorkshire | British | Internet Provider | 39875270002 | |||||
SCARFE, Colleen Miriam Anne | Segretario | 14 West Lea Close Moortown LS17 5DB Leeds | British | 60112470003 | ||||||
BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
COBLEY, Bryan Nicholas | Amministratore | 40 West Park Avenue LS8 2EB Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 66305750001 | |||||
COBLEY, Bryan Nicholas | Amministratore | 40 West Park Avenue LS8 2EB Leeds West Yorkshire | British | General Manager | 66305750001 | |||||
DUBENS, Peter Adam Daiches | Amministratore | Cadogan Gate SW1X 0AS London 3 | Switzerland | British | Company Director | 153016810001 | ||||
DUBENS, Peter Adam Daiches | Amministratore | The Economist Building 8th Floor 25 St Jamess Street SW1A 1HA London | Switzerland | British | Company Director | 153016810001 | ||||
HASWELL, Peter Alfred | Amministratore | 56 Wordsworth Grove Stanley WF3 4JL Wakefield West Yorkshire | British | Wed Developer | 67154200001 | |||||
KEIR, Christopher | Amministratore | 16 Marshall Street Crossgates LS15 8DY Leeds Yorkshire | British | Company Director | 39875260001 | |||||
KEIR, Christopher | Amministratore | 16 Marshall Street Crossgates LS15 8DY Leeds Yorkshire | British | Information Technology Sales | 39875260001 | |||||
KELLY, Robert Daniel | Amministratore | Stafford House 33 Stafford Hill Lane HD5 0EE Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 71715970001 | ||||
KIRKWOOD, Gareth Robert | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Suite 1 Lancashire | England | British | Company Director | 174056480001 | ||||
KITCHING, Kevin Peter | Amministratore | 110 Cliff Road Crigglestone WF4 3EJ Wakefield West Yorkshire | British | Director | 48430870003 | |||||
KOZUSZEK, Colin | Amministratore | 52 Burnett Avenue BD5 9LU Bradford West Yorkshire | British | Information Technology Sales | 66376950001 | |||||
MARROCCO, Dominic Anthony | Amministratore | 5 Moorland View LS17 6EY Leeds | British | Managing Director | 47321170002 | |||||
PORTER, Stewart Charles | Amministratore | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | British | Finance Director | 67037910004 | |||||
PORTER, Stewart Charles | Amministratore | 1 Triangle Business Park HP22 5BL Stoke Mandeville Buckinghamshire | British | Company Director | 67037910002 | |||||
PURVIS, Grahame Robert | Amministratore | 21 Leydene Park GU32 1HF East Meon Hampshire | United Kingdom | United Kingdom | Company Director | 113467720001 | ||||
READ, Michael David | Amministratore | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | United Kingdom | British | Director | 81004070007 | ||||
READ, Michael David | Amministratore | 1 Triangle Business Park HP22 5BL Stoke Mandeville Buckinghamshire | British | Director | 81004070003 | |||||
RILEY, Anthony John | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Suite 1 Lancashire | England | British | Company Director | 89230160001 | ||||
RILEY, Matthew Robinson | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 178585250001 | ||||
SANDERSON, Clive Anthony | Amministratore | 47 Oakdale Glen HG1 2JY Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Internet Provider | 39875270002 | ||||
DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Communications Ltd | 21 mar 2017 | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Freedom4 Limited | 06 apr 2016 | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
FREEDOM4 ACCESS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 04 nov 2004 Consegnato il 16 nov 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 ott 2003 Consegnato il 12 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 07 mar 2003 Consegnato il 18 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Interest in the sum equal to £48,175.00. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 03 set 2002 Consegnato il 09 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land k/a peregrine house gelderd close gelderd road leeds west yorkshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 dic 1999 Consegnato il 30 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All assets and undertaking of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 13 mag 1998 Consegnato il 22 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0