FREEDOM4 ACCESS LIMITED

FREEDOM4 ACCESS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFREEDOM4 ACCESS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03152569
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FREEDOM4 ACCESS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Daisy House
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PIPEX COMMUNICATIONS BUSINESS SOLUTIONS LIMITED18 nov 200318 nov 2003
    FIRSTNET SERVICES LIMITED30 gen 199630 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per FREEDOM4 ACCESS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A6LSS17K

    Cessazione della carica di Matthew Robinson Riley come amministratore in data 24 ott 2017

    1 pagineTM01
    X6JOLDJV

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04
    X6GGWPX4

    Notifica di Daisy Communications Ltd come persona con controllo significativo il 21 mar 2017

    2 paginePSC02
    X6BC3S3D

    Cessazione di Freedom4 Limited come persona con controllo significativo il 21 mar 2017

    1 paginePSC07
    X6BC27D5

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    14 pagineAA
    A60JUBCX

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01
    X60A7VBS

    Stato del capitale al 14 apr 2016

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19
    A53XRQ56

    legacy

    1 pagineSH20
    S53YEU8Z

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    A53XRQ5M

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 30 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 feb 2016

    Stato del capitale al 29 feb 2016

    • Capitale: GBP 17,450
    SH01
    X51JN42I

    Dettagli del segretario cambiati per Mr David Lewis Mcglennon il 30 gen 2016

    1 pagineCH03
    X51JN41U

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    11 pagineAA
    A4MSZ1XN

    Indirizzo della sede legale modificato da Daisy House Suite 1 Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR a Daisy House Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR in data 15 mag 2015

    1 pagineAD01
    X47HFN8Q

    Bilancio annuale redatto al 30 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 feb 2015

    Stato del capitale al 23 feb 2015

    • Capitale: GBP 17,450
    SH01
    X41TRQH5

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    15 pagineAA
    A3M3JJRE

    Bilancio annuale redatto al 30 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2014

    Stato del capitale al 26 feb 2014

    • Capitale: GBP 17,450
    SH01
    X32FSDYW

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA
    A2L57V2Z

    Bilancio annuale redatto al 30 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X22PEZI2

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    8 pagineAA
    A1NRXPUG

    Cessazione della carica di Gareth Kirkwood come amministratore

    1 pagineTM01
    X180RJ1K

    Bilancio annuale redatto al 30 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X13PUE3L

    Chi sono gli amministratori di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCGLENNON, David Lewis
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    Segretario
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    149418700001
    SMITH, Stephen Alan
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director161471940001
    COBLEY, Bryan Nicholas
    40 West Park Avenue
    LS8 2EB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    40 West Park Avenue
    LS8 2EB Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director66305750001
    GIBSON, Carolyn Ann
    10 Hanger Hill
    KT13 9XR Weybridge
    Surrey
    Segretario
    10 Hanger Hill
    KT13 9XR Weybridge
    Surrey
    British59736770001
    KENNEDY, Christina Lillian
    Walnut House
    Walnut Gardens Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    Segretario
    Walnut House
    Walnut Gardens Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    British7909160003
    PORTER, Stewart Charles
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Segretario
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    BritishFinance Director67037910004
    PORTER, Stewart Charles
    1 Triangle Business Park
    HP22 5BL Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 Triangle Business Park
    HP22 5BL Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    British67037910002
    SANDERSON, Clive Anthony
    47 Oakdale Glen
    HG1 2JY Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    47 Oakdale Glen
    HG1 2JY Harrogate
    North Yorkshire
    BritishInternet Provider39875270002
    SCARFE, Colleen Miriam Anne
    14 West Lea Close
    Moortown
    LS17 5DB Leeds
    Segretario
    14 West Lea Close
    Moortown
    LS17 5DB Leeds
    British60112470003
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    COBLEY, Bryan Nicholas
    40 West Park Avenue
    LS8 2EB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    40 West Park Avenue
    LS8 2EB Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director66305750001
    COBLEY, Bryan Nicholas
    40 West Park Avenue
    LS8 2EB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    40 West Park Avenue
    LS8 2EB Leeds
    West Yorkshire
    BritishGeneral Manager66305750001
    DUBENS, Peter Adam Daiches
    Cadogan Gate
    SW1X 0AS London
    3
    Amministratore
    Cadogan Gate
    SW1X 0AS London
    3
    SwitzerlandBritishCompany Director153016810001
    DUBENS, Peter Adam Daiches
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    Amministratore
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    SwitzerlandBritishCompany Director153016810001
    HASWELL, Peter Alfred
    56 Wordsworth Grove
    Stanley
    WF3 4JL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    56 Wordsworth Grove
    Stanley
    WF3 4JL Wakefield
    West Yorkshire
    BritishWed Developer67154200001
    KEIR, Christopher
    16 Marshall Street
    Crossgates
    LS15 8DY Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    16 Marshall Street
    Crossgates
    LS15 8DY Leeds
    Yorkshire
    BritishCompany Director39875260001
    KEIR, Christopher
    16 Marshall Street
    Crossgates
    LS15 8DY Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    16 Marshall Street
    Crossgates
    LS15 8DY Leeds
    Yorkshire
    BritishInformation Technology Sales39875260001
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector71715970001
    KIRKWOOD, Gareth Robert
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House Suite 1
    Lancashire
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House Suite 1
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director174056480001
    KITCHING, Kevin Peter
    110 Cliff Road
    Crigglestone
    WF4 3EJ Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    110 Cliff Road
    Crigglestone
    WF4 3EJ Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector48430870003
    KOZUSZEK, Colin
    52 Burnett Avenue
    BD5 9LU Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    52 Burnett Avenue
    BD5 9LU Bradford
    West Yorkshire
    BritishInformation Technology Sales66376950001
    MARROCCO, Dominic Anthony
    5 Moorland View
    LS17 6EY Leeds
    Amministratore
    5 Moorland View
    LS17 6EY Leeds
    BritishManaging Director47321170002
    PORTER, Stewart Charles
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Amministratore
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    BritishFinance Director67037910004
    PORTER, Stewart Charles
    1 Triangle Business Park
    HP22 5BL Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Triangle Business Park
    HP22 5BL Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director67037910002
    PURVIS, Grahame Robert
    21 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Amministratore
    21 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    United KingdomUnited KingdomCompany Director113467720001
    READ, Michael David
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Amministratore
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector81004070007
    READ, Michael David
    1 Triangle Business Park
    HP22 5BL Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Triangle Business Park
    HP22 5BL Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    BritishDirector81004070003
    RILEY, Anthony John
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House, Suite 1
    Lancashire
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House, Suite 1
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director89230160001
    RILEY, Matthew Robinson
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director178585250001
    SANDERSON, Clive Anthony
    47 Oakdale Glen
    HG1 2JY Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    47 Oakdale Glen
    HG1 2JY Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishInternet Provider39875270002
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FREEDOM4 ACCESS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    21 mar 2017
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04145329
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    06 apr 2016
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5751878
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FREEDOM4 ACCESS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 nov 2004
    Consegnato il 16 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of the Finance Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 ott 2003
    Consegnato il 12 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 07 mar 2003
    Consegnato il 18 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interest in the sum equal to £48,175.00. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cheshire County Council
    Transazioni
    • 18 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2002
    Consegnato il 09 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a peregrine house gelderd close gelderd road leeds west yorkshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 dic 1999
    Consegnato il 30 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All assets and undertaking of the company.
    Persone aventi diritto
    • Minorplanet Systems PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 mag 1998
    Consegnato il 22 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0