AMEY DATEL GROUP LIMITED

AMEY DATEL GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAMEY DATEL GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03152636
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DATEL FERRANTI GROUP LIMITED30 gen 199630 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2012

    Stato del capitale al 21 giu 2012

    • Capitale: GBP 10,504,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Melvyn Ewell il 30 nov 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Sherard Secretariat Services Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    legacy

    1 pagine190a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    14 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    2 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5615519
    109588620001
    EWELL, Melvyn
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish61515760002
    NELSON, Andrew Latham
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish36191090003
    HUI, Carol
    GU8
    Segretario
    GU8
    British72371980001
    SMITH, Michael John
    63 Fields Road
    Haslingden
    BB4 6QA Rossendale
    Lancashire
    Segretario
    63 Fields Road
    Haslingden
    BB4 6QA Rossendale
    Lancashire
    British61711420001
    TETLOW, John Richard
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    British68445840001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Richard Hawthorn
    Bramley Cottage Coppice Hill
    Chalford
    GL6 8DZ Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Bramley Cottage Coppice Hill
    Chalford
    GL6 8DZ Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish56940900001
    BATCHELOR, Graeme Warwick
    2 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Lancashire
    Amministratore
    2 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Lancashire
    British58892340002
    BRADBURY, Richard George
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    Amministratore
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    British42234330002
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Amministratore
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    British50174710001
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Amministratore
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    British50174710001
    HARRIS, Howard Daniel
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British44607740001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish141893610001
    LEO, Jose
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Spanish93348510004
    MCCARTNEY, Alan
    17 The Orchards
    WA16 0LS Pickmere
    Cheshire
    Amministratore
    17 The Orchards
    WA16 0LS Pickmere
    Cheshire
    British118583390001
    MILLER, David John
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    Amministratore
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    United KingdomBritish152304230002
    MOGG, Charles Michael
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British87961010001
    MORRIS, Keith Peter
    Keepers Cottage
    Lilac Avenue
    FY8 4LG Lytham St. Annes
    Lancashire
    Amministratore
    Keepers Cottage
    Lilac Avenue
    FY8 4LG Lytham St. Annes
    Lancashire
    United KingdomBritish43135960002
    MURAD, Simon William
    The Rookeries
    Roundabout Copse
    RH20 2RB West Chiltington
    West Sussex
    Amministratore
    The Rookeries
    Roundabout Copse
    RH20 2RB West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomBritish75114990001
    PEAT, Stephen Hedley
    25 Canynge Square
    Clifton
    BS8 3LB Bristol
    Avon
    Amministratore
    25 Canynge Square
    Clifton
    BS8 3LB Bristol
    Avon
    British70137370001
    POWERS, Glenn Patrick
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    Amministratore
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    British72486520001
    PUGH, Graham John
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    Amministratore
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    British24512450001
    ROBINSON, John Hamilton
    Bull Rush House 8 Kennett Place
    Chilton Foliat
    RG17 0TB Hungerford
    Berkshire
    Amministratore
    Bull Rush House 8 Kennett Place
    Chilton Foliat
    RG17 0TB Hungerford
    Berkshire
    American69410760003
    STAPLES, Brian Lynn
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish55479560003
    SWEENEY, John Trevor
    6 Scarlet Oaks
    Portsmouth Road
    GU15 1RD Camberley
    Surrey
    Amministratore
    6 Scarlet Oaks
    Portsmouth Road
    GU15 1RD Camberley
    Surrey
    British70137390001
    WILLIAMSON, Stephen
    120 Warbreck Hill Road
    FY2 0TR Blackpool
    Lancashire
    Amministratore
    120 Warbreck Hill Road
    FY2 0TR Blackpool
    Lancashire
    British36188290001

    AMEY DATEL GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 14 mar 2003
    Consegnato il 26 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee on Behalf of the Finance Parties
    Transazioni
    • 26 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 giu 1998
    Consegnato il 17 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 ott 1996
    Consegnato il 17 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0