INVESTBUILD LIMITED

INVESTBUILD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINVESTBUILD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03153078
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INVESTBUILD LIMITED?

    • (5010) /

    Dove si trova INVESTBUILD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    65 St Edmunds Church Street
    SP1 1EF Salisbury
    Wiltshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di INVESTBUILD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per INVESTBUILD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 26 ott 2016

    22 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 set 2016

    16 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 mar 2016

    18 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 set 2015

    17 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 mar 2015

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 set 2014

    17 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 mar 2014

    16 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 set 2013

    18 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 mar 2013

    17 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 ott 2012

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 mag 2012

    15 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    9 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    24 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Arcadia House Maritime Walk Ocean Village Southampton Hampshire SO14 3TL* in data 18 nov 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    5 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2011

    Stato del capitale al 09 mar 2011

    • Capitale: GBP 66,667
    SH01

    Nomina di Mr Neil John Moulton come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Simon David Moulton come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2009

    34 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di INVESTBUILD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOULTON, Neil John
    54 Celtic Drive
    SP10 2UA Andover
    Hampshire
    Segretario
    54 Celtic Drive
    SP10 2UA Andover
    Hampshire
    British93794760002
    HOULT, Norman Harry
    93 Hocombe Road
    Chandlers Ford
    SO53 5QB Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    93 Hocombe Road
    Chandlers Ford
    SO53 5QB Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector49259290001
    MOULTON, David William
    Boldre Lane
    Boldre
    SO41 8PD Lymington
    The Old School House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Boldre Lane
    Boldre
    SO41 8PD Lymington
    The Old School House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector66050150002
    MOULTON, Neil John
    Celtic Drive
    SP10 2UA Andover
    54
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Celtic Drive
    SP10 2UA Andover
    54
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director156643400001
    MOULTON, Simon David
    Cottage
    Pitt House Lane Hurn
    BH23 6AU Christchurch
    Pitt House
    Dorset
    Great Britain
    Amministratore
    Cottage
    Pitt House Lane Hurn
    BH23 6AU Christchurch
    Pitt House
    Dorset
    Great Britain
    EnglandBritishDirector66050230004
    ROWLES, Garry David
    Botley Road
    Horton Heath
    SO50 7DN Eastleigh
    Stoneham House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Botley Road
    Horton Heath
    SO50 7DN Eastleigh
    Stoneham House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector64143460003
    MACKENZIE, Donald Roderick
    29 Prentiss Court
    Charlton Lane
    SE7 8LD London
    Segretario
    29 Prentiss Court
    Charlton Lane
    SE7 8LD London
    BritishDirector122879010001
    MOULTON, David William
    Shilling Cottage
    Monxton Road Abbotts Ann
    SP11 7BA Andover
    Hampshire
    Segretario
    Shilling Cottage
    Monxton Road Abbotts Ann
    SP11 7BA Andover
    Hampshire
    BritishDirector66050150001
    WILLIAMS, Margaret Iona
    47 Kingsmead Road
    Tulse Hill
    SW2 3HY London
    England
    Segretario
    47 Kingsmead Road
    Tulse Hill
    SW2 3HY London
    England
    BritishAccoutant21530720001
    SECRETARIAL LAW LIMITED
    Charter Court
    Third Avenue
    SO15 0AP Southampton
    Hampshire
    Segretario
    Charter Court
    Third Avenue
    SO15 0AP Southampton
    Hampshire
    31358160005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLEMINSON, Benjamin Simons
    P O Box 21
    Blantyre
    Malawi
    Amministratore
    P O Box 21
    Blantyre
    Malawi
    BritishDirector19361770001
    MACKENZIE, Donald Roderick
    29 Prentiss Court
    Charlton Lane
    SE7 8LD London
    Amministratore
    29 Prentiss Court
    Charlton Lane
    SE7 8LD London
    United KingdomBritishCompany Director122879010001
    WILLIAMS, Margaret Iona
    47 Kingsmead Road
    Tulse Hill
    SW2 3HY London
    England
    Amministratore
    47 Kingsmead Road
    Tulse Hill
    SW2 3HY London
    England
    BritishAccoutant21530720001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    INVESTBUILD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 27 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    278 weyhill road andover test valley hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Exxonmobil Petroleum & Chemical Bvba
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 08 ott 2009
    Consegnato il 14 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    278 weyhill road andover test valley hampshire, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Exxonmobil Petroleum & Chemical Bvba
    Transazioni
    • 14 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 26 giu 2006
    Consegnato il 14 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    278 weyhill road andover test valley hampshire t/no HP543872 and such other interests. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Exxonmobil Petroleum & Chemical Bvba
    Transazioni
    • 14 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 15 lug 2005
    Consegnato il 03 ago 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from from the company to each of the secured parties or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale LTD
    Transazioni
    • 03 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 2002
    Consegnato il 25 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £322,500 and all or any monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The premises known as 278 weyhill road andover test valley hampshire title numer HP543872. Fixed charge the goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Esso Petroleum Company Limited
    Transazioni
    • 25 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 26 giu 2002
    Consegnato il 03 lug 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all the dealer's undertaking and property and assets both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 03 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 04 set 1999
    Consegnato il 11 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 278 weyhill road andover hampshire all fixtures and fittings all rental income and the proceeds of sale the goodwill of the business and the benefit of all debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bp Oil UK Limited and Mobil Oil Company Limited
    Transazioni
    • 11 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1999
    Consegnato il 07 set 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    278 weyhill road andover hampshire HP543872. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 mar 1999
    Consegnato il 19 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mar 1999
    Consegnato il 19 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 30 apr 1996
    Consegnato il 02 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge allstocks of new and used vehicles owned by the company stock in trade work in progress book debts prepayments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 02 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 apr 1996
    Consegnato il 02 mag 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixe charge on all existing or future stock of used vehicles now owned or to be owned by the dealer. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 02 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)

    INVESTBUILD LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 nov 2011Inizio dell'amministrazione
    26 ott 2016Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Julie Anne Palmer
    Begbies Traynor (Central) Llp
    65 St Edmunds Church Street
    SP1 1EF Salisbury
    Wiltshire
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp
    65 St Edmunds Church Street
    SP1 1EF Salisbury
    Wiltshire
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0