BS REALISATIONS (2009) LIMITED

BS REALISATIONS (2009) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBS REALISATIONS (2009) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03153784
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    • (5243) /

    Dove si trova BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BERTIE SHOES LIMITED08 feb 200108 feb 2001
    CABLE & CO (UK) LIMITED26 gen 199626 gen 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 gen 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 mar 2010

    8 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 30 mar 2010

    1 pagine2.35B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 set 2009

    21 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    5 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    33 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed bertie shoes LIMITED\certificate issued on 23/03/09
    3 pagineCERTNM

    Bilancio redatto al 26 gen 2008

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 27 gen 2007

    13 pagineAA

    legacy

    31 pagine395

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    18 pagine155(6)a

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Facility/loan agreement 12/10/06
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07

    Risoluzioni

    Resolutions
    5 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILKS, Jessica
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    Segretario
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    British116562380001
    GLANVILLE, Richard Spencer
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    Amministratore
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    United KingdomBritish69669910005
    LOVELOCK, Derek John
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116560620001
    LUSTMAN, Margaret Eve
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    Amministratore
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    EnglandBritish40930620002
    SHEARWOOD, Mike
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish95093740001
    CASSAR, Stefan
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    Segretario
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    British57039310004
    FLEETWOOD, Matthew David
    37 Hunts Field Close
    WA13 0SS Lymm
    Cheshire
    Segretario
    37 Hunts Field Close
    WA13 0SS Lymm
    Cheshire
    British67509880002
    HALL, Vikki
    28 Burman Drive
    Coleshill
    B46 3NB Birmingham
    Segretario
    28 Burman Drive
    Coleshill
    B46 3NB Birmingham
    British82602670001
    KAPPES, Alyson Elizabeth
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    Segretario
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    British47964550001
    KAPPES, Alyson Elizabeth
    139 Clapham Road
    SW99 0HR London
    Segretario
    139 Clapham Road
    SW99 0HR London
    British46132570001
    MCCARTHY, Donald
    20 Copley Dene
    BR1 2PW Bromley
    Kent
    Segretario
    20 Copley Dene
    BR1 2PW Bromley
    Kent
    British64482220001
    MCCARTHY, Julie Ann
    Attleborough House Townsend Drive
    Attleborough Fields Indu
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    Segretario
    Attleborough House Townsend Drive
    Attleborough Fields Indu
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    British54849760001
    PHILIP, Colin James
    11 Oakcroft Close
    HA5 3YY Pinner
    Middlesex
    Segretario
    11 Oakcroft Close
    HA5 3YY Pinner
    Middlesex
    British8205160001
    QUINLAN, Diane
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    Segretario
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    British38760910001
    CASSAR, Stefan
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    Amministratore
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    British57039310004
    COTTERELL, Rebecca Jane
    Attleborough House
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    Attleborough House
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    British37924130001
    DANSKY, Ira
    115 Dundee Drive
    Stamford
    Connecticut 06903
    Usa
    Amministratore
    115 Dundee Drive
    Stamford
    Connecticut 06903
    Usa
    Us Citizen72028040001
    DARLINGTON, John
    Attleborough House Townsend Drive
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    Attleborough House Townsend Drive
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    British145849750001
    DEFTY, David Andrew
    Radcliffe House
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    Amministratore
    Radcliffe House
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    British38530980001
    DIPUMA, Gloria Walker
    45 Tupper Drive
    06902 Stamford
    Connecticut
    America
    Amministratore
    45 Tupper Drive
    06902 Stamford
    Connecticut
    America
    Us Citizen59134040001
    DRUM, John David Francis
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    Amministratore
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    British13103440003
    DRUM, John David Francis
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    Amministratore
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    British13103440003
    EGAN, John Gerard
    17 Kent Road
    KT8 9JZ East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    17 Kent Road
    KT8 9JZ East Molesey
    Surrey
    British73851980002
    GALVIN, Robert
    44 Holmes Road
    Ridgefield Connecticut Ct 06877
    Usa
    Amministratore
    44 Holmes Road
    Ridgefield Connecticut Ct 06877
    Usa
    American53481670001
    GRIFFITHS, David John
    Radcliffe Houseet Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Radcliffe Houseet Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    West Midlands
    British78157950001
    HODSON, Beverley Cliffe
    139 Clapham
    SW9 0HR London
    Amministratore
    139 Clapham
    SW9 0HR London
    British53709690001
    HOWALD, Jeffrey Kevin
    2155 Riding Trail Drive
    Chesterfield 63005
    FOREIGN Missouri Usa
    Amministratore
    2155 Riding Trail Drive
    Chesterfield 63005
    FOREIGN Missouri Usa
    Us Citizen72240490001
    LENICH, William
    5 Spruce Meadow Court
    Wilton
    Connecticut Ct 06897
    Usa
    Amministratore
    5 Spruce Meadow Court
    Wilton
    Connecticut Ct 06897
    Usa
    American50466570001
    MADORE, Robert
    463 North Street
    Ridefield
    Ct 06877
    United States
    Amministratore
    463 North Street
    Ridefield
    Ct 06877
    United States
    American73693980001
    MCCARTHY, Donald
    2 Fairway Gardens
    Park Langley
    BR3 6YL Beckenham
    London
    Amministratore
    2 Fairway Gardens
    Park Langley
    BR3 6YL Beckenham
    London
    British64482220002
    MINTERN, Andrew
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    Amministratore
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    British49420330001
    O'CONNOR, Michael Victor
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    Amministratore
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    British67194680004
    PACK, Michael Anthony
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    Amministratore
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    British40673900001
    RENNISON, Gordon
    Attleborough House Townsend Drive
    Attleborough Fields Indu
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    Attleborough House Townsend Drive
    Attleborough Fields Indu
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    British59804930003
    SPITZ, David Barry
    Flat 3 The Pavilions
    24/26 Avenue Road St Johns Wood
    NW8 6BS London
    Amministratore
    Flat 3 The Pavilions
    24/26 Avenue Road St Johns Wood
    NW8 6BS London
    United KingdomBritish34724360002

    BS REALISATIONS (2009) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 27 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 27 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 ott 2006
    Consegnato il 21 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 21 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 02 feb 2005
    Consegnato il 12 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 12 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 ago 2003
    Consegnato il 02 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due , subject to a maximum aggregate amount of £3,500,000, from the company and each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all assets now or in future.
    Persone aventi diritto
    • David Spitz for and on Behalf of Himself and as Agent on Behalf of the Noteholders
    Transazioni
    • 02 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture between the company and others (as charging companies) and the chargee
    Creato il 29 gen 2001
    Consegnato il 09 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly k/a cable & co (UK) limited and/or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BS REALISATIONS (2009) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 mar 2009Inizio dell'amministrazione
    30 mar 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0