BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED
Panoramica
Nome della società | BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03156768 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | c/o BRUNTWOOD LIMITED York House York Street M2 3BB Manchester England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SLATERSHELFCO 312 LIMITED | 08 feb 1996 | 08 feb 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT a C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB in data 07 giu 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin James Crotty il 28 giu 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin James Crotty come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Allan come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* in data 21 dic 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Yates come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Malin come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Iain Grant come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2009 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BD* in data 10 mar 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKES, Katharine Jane | Segretario | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | British | Company Director | 96739300002 | |||||
CROTTY, Kevin James | Amministratore | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | England | British | Chartered Accountant | 117797270004 | ||||
OGLESBY, Christopher George | Amministratore | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | Company Director | 53530470002 | ||||
OGLESBY, Michael John | Amministratore | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | Company Director | 148307320001 | ||||
GREENWOOD, Clive Norman Kristian | Segretario | Meadows Farm SK12 7EH Kettleshulme Cheshire | British | 2582690002 | ||||||
ORRELL, Jeremy Peter | Segretario nominato | 2 Greylands Close M33 6GS Sale Cheshire | British | 900005190001 | ||||||
ALLAN, Andrew John | Amministratore | c/o Bruntwood Limited Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 80043450001 | ||||
DUNN, Christopher Frank | Amministratore delegato nominato | 4 Ashcroft Close SK9 1RB Wilmslow Cheshire | British | 900005180001 | ||||||
GRANT, Iain James | Amministratore | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 45918940003 | ||||
GREENWOOD, Clive Norman Kristian | Amministratore | Meadows Farm SK12 7EH Kettleshulme Cheshire | United Kingdom | British | Accountant | 2582690002 | ||||
MALIN, Richard William | Amministratore | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Banker | 48153170001 | ||||
OGLESBY, Jean Davies | Amministratore | Moss Farm Southdowns Road Bowdon WA14 3DR Altrincham Cheshire | England | British | Company Director | 29553390001 | ||||
ORRELL, Jeremy Peter | Amministratore delegato nominato | 2 Greylands Close M33 6GS Sale Cheshire | British | 900005190001 | ||||||
YATES, Robert David | Amministratore | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 30535590006 |
BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
B2000 borrower security agreement | Creato il 06 feb 2007 Consegnato il 20 feb 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 06 dic 2001 Consegnato il 18 dic 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership or otherwise or in any other manner whatsoever and also all monies and liabilities which shall for the time being be due or to become due from bruntwood estates limited and/or bruntwood 2000 first properties limited to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership and on any account or in any other manner whatsoever | |
Brevi particolari The property being freehold property known as fanum house (now known as landmark house) station road cheadle hulme stockport greater manchester title number GM76157 leasehold property known as land being part of fanum house (now known as landmark house) title number GM682291 for further details of the property please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of supplemental charge | Creato il 02 feb 2000 Consegnato il 18 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito (A) all monies and liabilties due or to become due from the company to lloyds tsb bank PLC, capital markets (the "agent") and/or the banks and each of them on any account whatsoever and (b) the third party liabilities (as defined) | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage l/h land k/a north tower (formerly k/a highland house) victoria bridge street and 19 chapel street salford greater manchester. By way of first fixed charge all plant machinery implements building materials furniture and equipment; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils building materials furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 set 1996 Consegnato il 30 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a credit agreement dated 20/9/96 and the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 31 mag 1996 Consegnato il 13 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fanum house station road cheadle hulme greater manchester t/no GM676157 and GM682291 with the goodwill of the business and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 31 mag 1996 Consegnato il 06 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £262,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge | |
Brevi particolari Fanum house, station road, cheadle hume, greater manchester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 mag 1996 Consegnato il 04 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0