BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED

BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03156768
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SLATERSHELFCO 312 LIMITED08 feb 199608 feb 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT a C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB in data 07 giu 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 feb 2016

    Stato del capitale al 09 feb 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 feb 2015

    Stato del capitale al 12 feb 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 feb 2014

    Stato del capitale al 20 feb 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin James Crotty il 28 giu 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Kevin James Crotty come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Allan come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* in data 21 dic 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Robert Yates come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Malin come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Iain Grant come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BD* in data 10 mar 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Segretario
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    BritishCompany Director96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director148307320001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Segretario
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Segretario nominato
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ALLAN, Andrew John
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant80043450001
    DUNN, Christopher Frank
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore delegato nominato
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    British900005180001
    GRANT, Iain James
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor45918940003
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Amministratore
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant2582690002
    MALIN, Richard William
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker48153170001
    OGLESBY, Jean Davies
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director29553390001
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Amministratore delegato nominato
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    YATES, Robert David
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor30535590006

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    B2000 borrower security agreement
    Creato il 06 feb 2007
    Consegnato il 20 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    Transazioni
    • 20 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 06 dic 2001
    Consegnato il 18 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership or otherwise or in any other manner whatsoever and also all monies and liabilities which shall for the time being be due or to become due from bruntwood estates limited and/or bruntwood 2000 first properties limited to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership and on any account or in any other manner whatsoever
    Brevi particolari
    The property being freehold property known as fanum house (now known as landmark house) station road cheadle hulme stockport greater manchester title number GM76157 leasehold property known as land being part of fanum house (now known as landmark house) title number GM682291 for further details of the property please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transazioni
    • 18 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of supplemental charge
    Creato il 02 feb 2000
    Consegnato il 18 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    (A) all monies and liabilties due or to become due from the company to lloyds tsb bank PLC, capital markets (the "agent") and/or the banks and each of them on any account whatsoever and (b) the third party liabilities (as defined)
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage l/h land k/a north tower (formerly k/a highland house) victoria bridge street and 19 chapel street salford greater manchester. By way of first fixed charge all plant machinery implements building materials furniture and equipment; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils building materials furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 set 1996
    Consegnato il 30 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a credit agreement dated 20/9/96 and the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 30 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 1996
    Consegnato il 13 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fanum house station road cheadle hulme greater manchester t/no GM676157 and GM682291 with the goodwill of the business and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 1996
    Consegnato il 06 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £262,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge
    Brevi particolari
    Fanum house, station road, cheadle hume, greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • The Automobile Association Limited
    Transazioni
    • 06 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mag 1996
    Consegnato il 04 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0