MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED

MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03158847
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni

    Dove si trova MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MIDAS PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED02 mag 200302 mag 2003
    MIDAS COMMERCIAL DEVELOPMENTS LIMITED08 giu 199808 giu 1998
    MIDAS GROUP LIMITED01 lug 199601 lug 1996
    NC3 LIMITED08 mag 199608 mag 1996
    BONDCO 608 LIMITED14 feb 199614 feb 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    19 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    36 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    12 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    71 pagineAM06

    Indirizzo della sede legale modificato da Midas House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WS a C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham B3 3HN in data 03 mar 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    71 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Iscrizione dell'ipoteca 031588470013, creata il 07 gen 2022

    9 pagineMR01

    Cessazione della carica di Scott George Poulter come amministratore in data 21 dic 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 ott 2020

    21 pagineAA

    Nomina di Mr Peter Iain Maynard Skoulding come segretario in data 06 lug 2021

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Peter Iain Maynard Skoulding come amministratore in data 06 lug 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael James Ready come amministratore in data 10 mar 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael James Ready come segretario in data 10 mar 2021

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 apr 2020 al 31 ott 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Derek Anthony Quinn come amministratore in data 10 gen 2020

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael James Ready il 19 ago 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 apr 2019

    21 pagineAA

    Nomina di Mr Michael James Ready come segretario in data 01 lug 2019

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Michael James Ready come amministratore in data 01 lug 2019

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SKOULDING, Peter Iain Maynard
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    Segretario
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    285034490001
    HINDLEY, Stephen Lewis
    The Coach House
    Powderham
    EX6 8JJ Exeter
    Devon
    Amministratore
    The Coach House
    Powderham
    EX6 8JJ Exeter
    Devon
    EnglandBritish20842990003
    HOPE, Alan Edward
    Midas House
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Devon
    Amministratore
    Midas House
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Devon
    EnglandBritish97589270003
    SKOULDING, Peter Iain Maynard
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    Amministratore
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    United KingdomBritish285032770001
    BRADFORD, Philip John
    11 Redcliffe Road
    St Marychurch
    TQ1 4QG Torquay
    Devon
    Segretario
    11 Redcliffe Road
    St Marychurch
    TQ1 4QG Torquay
    Devon
    British34799510002
    HOCKING, Michael Wesley
    Cathail
    Chalbury Heights, Brill, Constantine
    TR11 5UR Falmouth
    Cornwall
    Segretario
    Cathail
    Chalbury Heights, Brill, Constantine
    TR11 5UR Falmouth
    Cornwall
    British120083390003
    READY, Michael James
    Midas House
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Devon
    Segretario
    Midas House
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Devon
    260360440001
    ROGERSON, Duncan Fraser
    Old Rydon Ley
    EX2 7UA Exeter
    11
    United Kingdom
    Segretario
    Old Rydon Ley
    EX2 7UA Exeter
    11
    United Kingdom
    156790990001
    SMITH, Robert John
    Burton Row
    Brent Knoll
    TA9 4BW Highbridge
    Bay Tree House
    Somerset
    United Kingdom
    Segretario
    Burton Row
    Brent Knoll
    TA9 4BW Highbridge
    Bay Tree House
    Somerset
    United Kingdom
    British204446640001
    WRIGHT, Beverley Ann
    Evenshade Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    Surrey
    Segretario
    Evenshade Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    Surrey
    British48360170001
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Segretario nominato
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005060001
    BARBER, Paul Jason
    Midas House
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Devon
    Amministratore
    Midas House
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Devon
    British89475690002
    BOYD MAUNSELL, Michael Francis Wray
    La Cache Rue Des Maltieres
    JE3 9EB Grouville
    Jersey
    Amministratore
    La Cache Rue Des Maltieres
    JE3 9EB Grouville
    Jersey
    British115355120001
    BRADFORD, Philip John
    11 Redcliffe Road
    St Marychurch
    TQ1 4QG Torquay
    Devon
    Amministratore
    11 Redcliffe Road
    St Marychurch
    TQ1 4QG Torquay
    Devon
    United KingdomBritish34799510002
    EWING, David Alistair Harris
    Highclere House Higher Warberry Road
    TQ1 1SF Torquay
    Devon
    Amministratore
    Highclere House Higher Warberry Road
    TQ1 1SF Torquay
    Devon
    British34799480001
    GUNNING, Richard James
    8 Yomede Park
    Newbridge
    BA1 3LS Bath
    Amministratore
    8 Yomede Park
    Newbridge
    BA1 3LS Bath
    British89475900001
    HOCKING, Michael Wesley
    Cathail
    Chalbury Heights, Brill, Constantine
    TR11 5UR Falmouth
    Cornwall
    Amministratore
    Cathail
    Chalbury Heights, Brill, Constantine
    TR11 5UR Falmouth
    Cornwall
    EnglandBritish120083390003
    JOHNSTON, Andrew David
    2 Moorview Close
    Pennsylvania
    EX4 6EZ Exeter
    Devon
    Amministratore
    2 Moorview Close
    Pennsylvania
    EX4 6EZ Exeter
    Devon
    EnglandBritish89475970003
    LEWIS, Leonard James
    Ty Gwyn Edginswell Close
    TQ2 7JA Torquay
    Devon
    Amministratore
    Ty Gwyn Edginswell Close
    TQ2 7JA Torquay
    Devon
    British7233800001
    MURCH, Terence Robert
    Middle Blagdon Cottage
    Blagdon Road
    TQ3 3YD Paignton
    Devon
    Amministratore
    Middle Blagdon Cottage
    Blagdon Road
    TQ3 3YD Paignton
    Devon
    United KingdomBritish118976570001
    MURCH, Terence Robert
    Middle Blagdon Cottage
    Blagdon Road
    TQ3 3YD Paignton
    Devon
    Amministratore
    Middle Blagdon Cottage
    Blagdon Road
    TQ3 3YD Paignton
    Devon
    United KingdomBritish118976570001
    MURCH, Terence Robert
    Middle Blagdon Cottage
    Blagdon Road
    TQ3 3YD Paignton
    Devon
    Amministratore
    Middle Blagdon Cottage
    Blagdon Road
    TQ3 3YD Paignton
    Devon
    United KingdomBritish118976570001
    PARRY, Darryn Keith
    Quarry House
    21 King Charles Road
    NP11 4HF Newbridge
    Gwent
    Amministratore
    Quarry House
    21 King Charles Road
    NP11 4HF Newbridge
    Gwent
    United KingdomBritish157637000001
    POULTER, Scott George
    Fairway Gardens
    Rownhams
    SO16 8JJ Southampton
    8
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fairway Gardens
    Rownhams
    SO16 8JJ Southampton
    8
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish165751160001
    QUINN, Derek Anthony
    32 Belvoir Road
    St Andrews
    BS6 5DJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    32 Belvoir Road
    St Andrews
    BS6 5DJ Bristol
    Avon
    EnglandBritish127625980001
    READY, Michael James
    Midas House
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Devon
    Amministratore
    Midas House
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Devon
    EnglandAustralian,British260360310001
    ROGERSON, Duncan Fraser
    Old Rydon Ley
    EX2 7UA Exeter
    11
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Rydon Ley
    EX2 7UA Exeter
    11
    United Kingdom
    EnglandBritish156790640001
    SMITH, Robert John
    Burton Row
    Brent Knoll
    TA9 4BW Highbridge
    Bay Tree House
    Somerset
    United Kingdom
    Amministratore
    Burton Row
    Brent Knoll
    TA9 4BW Highbridge
    Bay Tree House
    Somerset
    United Kingdom
    United KingdomBritish204446640001
    TAYLOR, Mark Gordon
    Erneston Crescent
    SN13 9DH Corsham
    10
    Wiltshire
    Amministratore
    Erneston Crescent
    SN13 9DH Corsham
    10
    Wiltshire
    United KingdomBritish135078990001
    WRIGHT, Beverley Ann
    Evenshade Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    Surrey
    Amministratore
    Evenshade Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    Surrey
    United KingdomBritish48360170001
    BONDLAW DIRECTORS LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Amministratore delegato nominato
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005050001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Midas Group Limited
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Midas House
    Devon
    England
    06 apr 2016
    Pynes Hill
    EX2 5WS Exeter
    Midas House
    Devon
    England
    No
    Forma giuridicaIncorporated
    Autorità legaleEngland And Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 07 gen 2022
    Consegnato il 12 gen 2022
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 apr 2017
    Consegnato il 06 apr 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 apr 2017
    Consegnato il 06 apr 2017
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 28 feb 2017
    Consegnato il 28 feb 2017
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 feb 2017
    Consegnato il 28 feb 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Licence fee deposit deed
    Creato il 30 apr 2001
    Consegnato il 04 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    £82,667 and all other sums due or to become due from the company to the chargee pursuant to a building and sale agreement dated 3 april 2001
    Brevi particolari
    The interest of the company in the licence fee deposit account maintained with the governor and company of the bank of scotland.
    Persone aventi diritto
    • The Members of the Merchant Place Property Syndicate Number 5
    Transazioni
    • 04 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Construction cost charge
    Creato il 30 apr 2001
    Consegnato il 04 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All sums from time to time deposited in the construction cost account maintained with the governor and company of the bank of scotland
    Brevi particolari
    The construction cost account maintained by the company with the governor and company of the bank of scotland.
    Persone aventi diritto
    • The Members of the Merchant Place Property Syndicate Number 5
    Transazioni
    • 04 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 12 gen 2000
    Consegnato il 28 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £73,600 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Property k/a units 1 and 2 brunel road industrial estate brunel road newton abbot.
    Persone aventi diritto
    • Teignbridge District Council
    Transazioni
    • 28 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 lug 1996
    Consegnato il 12 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 01 lug 1996
    Consegnato il 08 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property hereinafter described and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property and an assignment of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the property or any part or parts thereof together with the full benefit of all licences including any registrations viz: f/h-property k/a midas house fore street kingskerswell devon t/n-DN99638.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 lug 1996
    Consegnato il 08 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property hereinafter described and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property and an assignment of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the property or any part or parts thereof together with the full benefit of all licences including any registrations viz: f/h-property k/a plot 11 decoy industrial estate newton abbot devon t/n-DN123842.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage deed
    Creato il 01 lug 1996
    Consegnato il 03 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a plots 14 b,c and d decoy industrial estate silverhills road newton abbot devon and the goodwill see form 395 for full details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage deed
    Creato il 01 lug 1996
    Consegnato il 03 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining plots 14 b,c, and d decoy ind estate silverhills road newton abbot devon and the goodwill of the businesssee form 395 for full details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    MI-SPACE PROPERTY SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 feb 2022Inizio dell'amministrazione
    16 feb 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Michael Hawes
    156 Great Charles Street Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Praticante
    156 Great Charles Street Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Matthew David Smith
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Praticante
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0