PROACTIVE LENDING LIMITED

PROACTIVE LENDING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROACTIVE LENDING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03161998
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROACTIVE LENDING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PROACTIVE LENDING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lake View
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROACTIVE LENDING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NORTH WESTERN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED20 feb 199620 feb 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROACTIVE LENDING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PROACTIVE LENDING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 031619980008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 031619980007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2016

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Stephen Paul Baker come amministratore in data 27 apr 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2016

    Stato del capitale al 24 mar 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    10 pagineAA

    Cessazione della carica di Gary Antony Jennison come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 031619980008, creata il 24 apr 2015

    65 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mar 2015

    Stato del capitale al 25 mar 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    11 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed north western properties & developments LIMITED\certificate issued on 07/04/14
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name07 apr 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 27 feb 2014

    RES15

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 27 feb 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mar 2014

    Stato del capitale al 26 mar 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Mr Gary Derek Beckett come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Matthew Ridley come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di PROACTIVE LENDING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BECKETT, Gary Derek
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    183538450001
    BECKETT, Gary Derek
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish59766710004
    GOLDBERG, Marc Richard
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish93639140005
    MOSER, Henry Neville
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish48050990002
    BECKETT, Gary Derek
    27 Hollybank
    Droylsden
    M43 7SP Manchester
    Segretario
    27 Hollybank
    Droylsden
    M43 7SP Manchester
    British59766710002
    MATTHEWS, David Steven
    5 York Terrace
    Coach Lane
    NE29 0EF North Shields
    Tyne & Wear
    Segretario
    5 York Terrace
    Coach Lane
    NE29 0EF North Shields
    Tyne & Wear
    British40845530001
    RICHARDS, Martin Basil
    Barnshaw Cottage
    Pepper Street
    WA16 6JH Mobberley
    Cheshire
    Segretario
    Barnshaw Cottage
    Pepper Street
    WA16 6JH Mobberley
    Cheshire
    British19869830002
    RIDLEY, Matthew John
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    British112269420001
    BAKER, Stephen Paul
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish121763750001
    HACKING, Christopher William
    Bents Barn
    Bents
    BB8 7AB Colne
    Lancashire
    Amministratore
    Bents Barn
    Bents
    BB8 7AB Colne
    Lancashire
    United KingdomBritish80683090001
    JENNISON, Gary Antony
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish68450470001
    PUNSHON, Colin John
    Oaktree House Princess Meadow
    2 Sandringham Close
    WA14 3GY Bowden
    Cheshire
    Amministratore
    Oaktree House Princess Meadow
    2 Sandringham Close
    WA14 3GY Bowden
    Cheshire
    British39909700003
    RICHARDS, Martin Basil
    Barnshaw Cottage
    Pepper Street
    WA16 6JH Mobberley
    Cheshire
    Amministratore
    Barnshaw Cottage
    Pepper Street
    WA16 6JH Mobberley
    Cheshire
    EnglandBritish19869830002
    RIDLEY, Matthew John
    6th Floor Bracken House
    Charles Street
    M1 7BD Manchester
    Amministratore
    6th Floor Bracken House
    Charles Street
    M1 7BD Manchester
    United KingdomBritish112269420001
    SEABRIDGE, David John
    Roseleigh, 170 Huddersfield Road
    Holmfirth
    HD9 3TP Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Roseleigh, 170 Huddersfield Road
    Holmfirth
    HD9 3TP Huddersfield
    West Yorkshire
    British92528070001
    SMITH, John Edward
    72 Hatfield Gardens
    Appleton
    WA4 5QJ Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    72 Hatfield Gardens
    Appleton
    WA4 5QJ Warrington
    Cheshire
    British69523270003

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROACTIVE LENDING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Together Financial Services Limited
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    England
    06 apr 2016
    Lakeside
    SK8 3GW Cheadle
    Lake View
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Of England And Wales
    Numero di registrazione02939389
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    PROACTIVE LENDING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 27 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2013
    Consegnato il 05 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent (Security Agent)
    Transazioni
    • 05 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creato il 15 nov 2007
    Consegnato il 20 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (or any other chargor) to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 20 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Amending deed to a composite guarantee and debenture dated 6TH december 1996 (as amended on 18TH december 1998 and 8TH november 2000 and supplemented on 15TH may 1997 and 11TH march 1998)
    Creato il 06 nov 2001
    Consegnato il 13 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the syndicate or any of them and/or the chargee pursuant to the facility agreement and/or, as the case may be, the debenture (all terms as defined).
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee Forthe Syndicate
    Transazioni
    • 13 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Amending deed to a composite guarantee and debenture dated 6TH december 1996 (as amended on 18TH december 1998 and supplemented on 15TH may 1997 and 11TH march 1998)
    Creato il 08 nov 2000
    Consegnato il 09 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee or any of them under or pursuant to the facility agreement dated 6TH december 1996 (as amended) and/or as the case may be the debenture.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Agent and Trustee Forthe Banks (as Defined)
    Transazioni
    • 09 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Amending deed to a composite guarantee and debenture dated 6TH december 1996
    Creato il 18 dic 1998
    Consegnato il 22 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) or any of them under or pursuant to a facility agreement dated 6TH december 1996 (as amended) and/or as the case may be the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 22 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 23 ott 1998
    Consegnato il 29 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 29 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 06 dic 1996
    Consegnato il 18 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to clause 2.1 of the debenture (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited,as Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 18 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0