SALTER PAPER GROUP LIMITED

SALTER PAPER GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSALTER PAPER GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03165495
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SALTER PAPER GROUP LIMITED?

    • (3720) /

    Dove si trova SALTER PAPER GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SALTER PAPER GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PCO 141 LIMITED22 feb 199622 feb 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di SALTER PAPER GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SALTER PAPER GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 3180 Park Square Birmingham Business Park Birmingham West Midlands B37 7YN in data 18 ott 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2011

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mar 2011

    Stato del capitale al 02 mar 2011

    • Capitale: GBP 6,000,000
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Mr Simon Elliot Joseph come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Simon Elliot Joseph il 21 feb 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Douglas Ray il 21 feb 2010

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    13 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    13 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di SALTER PAPER GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JOSEPH, Simon Elliot
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Segretario
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    British113862500001
    JOSEPH, Simon Elliot
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Amministratore
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish113862500001
    RAY, Stephen Douglas
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Amministratore
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish65237530001
    FENSOME, Richard James
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British84096960001
    MARSDEN, Peter
    Mulroy
    Talbot Road Bowden
    WA14 3JD Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    Mulroy
    Talbot Road Bowden
    WA14 3JD Altrincham
    Cheshire
    British10980230001
    MASON, Allan Charles
    41 Beckenham Hill Road
    SE6 3NY London
    Segretario
    41 Beckenham Hill Road
    SE6 3NY London
    British47838250001
    PAILEX CORPORATE SERVICES LIMITED
    First Floor 1 Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2JD London
    Segretario
    First Floor 1 Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2JD London
    34477090004
    BUTTON, Graham Christopher
    1 Harmston Park Avenue
    LN5 9GF Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    1 Harmston Park Avenue
    LN5 9GF Lincoln
    Lincolnshire
    British77558190002
    CORNISH, Herbert Evan
    Kenilworth
    Sylvan Avenue
    LN10 6SL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Amministratore
    Kenilworth
    Sylvan Avenue
    LN10 6SL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    British3789040001
    CORNISH, Michael John
    Mistlethwaite House
    Edlington
    LN9 5RJ Horncastle
    Lincolnshire
    Amministratore
    Mistlethwaite House
    Edlington
    LN9 5RJ Horncastle
    Lincolnshire
    EnglandBritish16627750004
    HOVER, David John
    Swan Lees Cottage The Lees
    Challock
    TN25 4DE Ashford
    Kent
    Amministratore
    Swan Lees Cottage The Lees
    Challock
    TN25 4DE Ashford
    Kent
    EnglandBritish55385390002
    LANG, Robert Alexander
    6360 River Overlook Drive
    FOREIGN Atlanta Ga30328
    Georgia
    Usa
    Amministratore
    6360 River Overlook Drive
    FOREIGN Atlanta Ga30328
    Georgia
    Usa
    British102537350001
    MARSDEN, Peter
    Mulroy
    Talbot Road Bowden
    WA14 3JD Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Mulroy
    Talbot Road Bowden
    WA14 3JD Altrincham
    Cheshire
    British10980230001
    MEE, Richard Anthony John
    71 Thistly Court
    Glaisher Street
    SE8 3JW Deptford
    London
    Amministratore
    71 Thistly Court
    Glaisher Street
    SE8 3JW Deptford
    London
    British83797980001
    PAISNER, Harold Michael
    16 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Amministratore
    16 Ilchester Place
    W14 8AA London
    EnglandBritish48467610001
    ROBIN, Sydney Frank
    25 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    25 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    British1935670001
    SALTER, Roy Ernest
    Birch Cottage 2 Silver Lane
    CR8 3HG Purley
    Surrey
    Amministratore
    Birch Cottage 2 Silver Lane
    CR8 3HG Purley
    Surrey
    British26222960001
    SIMLER, Shelley Judith
    First Floor Bouverie House 154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    Amministratore
    First Floor Bouverie House 154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    British/South African14531190001
    SMITH, Andrew Tyler
    Saint Osyth
    Legbourne
    LN11 8LL Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Saint Osyth
    Legbourne
    LN11 8LL Louth
    Lincolnshire
    British726320001
    SMITH, Timothy Valentine
    Hartley Green House
    High Street
    RG27 8PD Hartley Wintney
    Hampshire
    Amministratore
    Hartley Green House
    High Street
    RG27 8PD Hartley Wintney
    Hampshire
    British61553720002
    TENTORI, Mark Ian
    Holly Hedges
    Tingrith Road Evershot
    MK17 9EF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Holly Hedges
    Tingrith Road Evershot
    MK17 9EF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish119564310001
    WILLIAMS, David Arthur
    9 The Crescent
    Hartford
    CW8 1QS Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    9 The Crescent
    Hartford
    CW8 1QS Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish16979530001

    SALTER PAPER GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 25 september 2003 and
    Creato il 01 mar 2007
    Consegnato il 07 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 25 september 2003
    Creato il 20 apr 2005
    Consegnato il 26 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any money or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee of set -off agreement dated 25 september 2003
    Creato il 07 gen 2005
    Consegnato il 13 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 20 march 2002
    Creato il 18 mag 2003
    Consegnato il 30 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 20TH march 2002 and
    Creato il 25 lug 2002
    Consegnato il 07 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 31 lug 2001
    Consegnato il 01 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £507,349.58 together with interest and charges due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    A fixed charge over 1 x foden 6X2 tractor unit chassis/serial number 901305 registration number W52 ugu 1 x daf FA45.150 Chassis/serial number XLRAE45CEOL219460 registration number W664 xat 3 x bailing press 28399 28380 24426 for further details of the charges please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Limited
    Transazioni
    • 01 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 22 apr 1996
    Consegnato il 24 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SALTER PAPER GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 ago 2012Data di scioglimento
    30 set 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0