M.T.K. CONTAINERS LIMITED

M.T.K. CONTAINERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàM.T.K. CONTAINERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03167857
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    • (2821) /

    Dove si trova M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Rsm Robson Rhodes
    St George House
    LS1 3DQ 40 Great George Street
    Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INFOMINI LIMITED05 mar 199605 mar 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine405(2)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    legacy

    1 pagine288b

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    legacy

    1 pagine288b

    Stato patrimoniale in amministrazione controllata a seguito della relazione ai creditori

    16 pagine3.3

    Stato patrimoniale in amministrazione controllata a seguito della relazione ai creditori

    10 pagine3.3

    Relazione del commissario giudiziario amministrativo

    12 pagine3.10

    Certificato di costituzione modificato del comitato dei creditori

    1 pagine3.4

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine405(1)

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    pagine363(353)

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    10 pagine395

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BELL, Ian David
    83a Gilesgate
    DH1 1HY Durham
    County Durham
    Amministratore
    83a Gilesgate
    DH1 1HY Durham
    County Durham
    British70976410001
    WITTLIN, Felix Max, Doctor
    2 Chemin Biguex
    Chailly-Montreux
    Ch 1816
    Switzerland
    Amministratore
    2 Chemin Biguex
    Chailly-Montreux
    Ch 1816
    Switzerland
    Swiss72634360001
    AITKEN, David Andrew
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    British87190800001
    COLLINS, Michael David Gibson
    15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Buckinghamshire
    Segretario
    15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Buckinghamshire
    British60886260003
    COLLINS, Michael David Gibson
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    British60886260002
    DEAN, Stephen Donald Charles
    49 Cromford Road
    SW18 1PA London
    Segretario
    49 Cromford Road
    SW18 1PA London
    British67535290002
    NOAH, Frank Edward
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Segretario
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British27829510002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AITKEN, David Andrew
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    British87190800001
    BROMLEY-MARTIN, Robin Hampden
    Leisure Cottage
    Church Road
    GU29 0EH West Lavington
    Amministratore
    Leisure Cottage
    Church Road
    GU29 0EH West Lavington
    United KingdomBritish110319440001
    COLLINS, Michael David Gibson
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    British60886260002
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglandBritish30827780001
    DAVIES, Andrew Owen Evan
    The Lawn Brent Hill
    ME13 7EF Faversham
    Kent
    Amministratore
    The Lawn Brent Hill
    ME13 7EF Faversham
    Kent
    British40795600002
    DEAKIN, Graham Ronald
    69 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    69 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British60807750001
    FISKE, Barry John
    8 Staitheway Road
    NR12 8TH Wroxham
    Norfolk
    Amministratore
    8 Staitheway Road
    NR12 8TH Wroxham
    Norfolk
    United KingdomBritish126228790001
    KUTLUOGLU, Mehmet Tayfun
    14 Parc Chateau Banquet
    1202 Geneva
    Switzerland
    Amministratore
    14 Parc Chateau Banquet
    1202 Geneva
    Switzerland
    Turkish51924640001
    KUTLUOGLU, Omer
    7 Broad Garth
    Blue Anchor Court
    NE1 3HE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    7 Broad Garth
    Blue Anchor Court
    NE1 3HE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British75656880001
    MORRIS, John
    Le Clos De La Brague
    Qtr Tamarins
    06410 Biot
    France
    Amministratore
    Le Clos De La Brague
    Qtr Tamarins
    06410 Biot
    France
    British52203280001
    NOAH, Frank Edward
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Amministratore
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British27829510002
    TASKENT, Turul
    57 Granville Court
    NE2 1TR Newcastle Upon Tyne
    North East
    Amministratore
    57 Granville Court
    NE2 1TR Newcastle Upon Tyne
    North East
    Turkish75656750001
    THOMAS, John Alan, Sir
    Highwood Park Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    Amministratore
    Highwood Park Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    United KingdomBritish10699990001
    WILKINSON, John
    7 Oakfield Close
    SR3 3RT Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    7 Oakfield Close
    SR3 3RT Sunderland
    Tyne & Wear
    British60807830001
    WINGFIELD, Andrew
    101 Broom Lane
    Whickham
    NE16 4PT Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Amministratore
    101 Broom Lane
    Whickham
    NE16 4PT Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish52203320001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    M.T.K. CONTAINERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattel mortgage
    Creato il 17 lug 2001
    Consegnato il 21 lug 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various chattels as specified in schedule to form 395 relative to the mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge over all stock
    Creato il 27 giu 2000
    Consegnato il 06 lug 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement
    Brevi particolari
    All stock owned by the borrower including raw materials and components and work in progress partly finished and finished goods for specific stock tanks.
    Persone aventi diritto
    • North East Regional Investment Fund Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 30 giu 1998
    Consegnato il 30 giu 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One tursdale engineering access platform ref no 1084..one rocom tsc imagination telephone system ref no 970387..xbs computer equipment ref no 1216..for further details see schedule to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 30 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 27 mar 1998
    Consegnato il 30 mar 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule to the 395 as one vacublast international waffle floor blastroom ref no 131,383,1022 one anopol hydro station ref 786 one xbs deskpro 2000 pc ref 834. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 30 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 23 feb 1998
    Consegnato il 23 feb 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One casanova hydraulic guillotine shear model vce-16 serial no.3942 Register no.97-p-001, one casanova hydraulic rolling machine model pcv-22/s serial no.3943 Register no:97-p-002, real time x-ray camera register no.97-p-061 for details of further chattels please see form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 23 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 07 gen 1998
    Consegnato il 08 gen 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Emi x ray cell and manipulators d/n SB373397 3 x dalby commercial vehicle spay booth/ovens s/n SB3733A97 for further details of equipment charged reger to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 08 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 ago 1997
    Consegnato il 28 ago 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2002Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 25 gen 2005Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
      • Numero di pratica 1

    M.T.K. CONTAINERS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 ago 1997Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Charles William Anthony Escott
    Grant Thornton Uk Llp
    St George House
    LS1 3DQ 40 Great George Street
    Leeds West Yorkshire,
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    St George House
    LS1 3DQ 40 Great George Street
    Leeds West Yorkshire,
    Michael John Hore
    Robson Rhodes
    186 City Road
    EC1V 2NU London
    Praticante
    Robson Rhodes
    186 City Road
    EC1V 2NU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0