SRG REALISATIONS (2017) PLC

SRG REALISATIONS (2017) PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSRG REALISATIONS (2017) PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03170812
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SRG REALISATIONS (2017) PLC?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SRG REALISATIONS (2017) PLC?

    Indirizzo della sede legale
    40 31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SRG REALISATIONS (2017) PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SECURITY RESEARCH GROUP PLC22 ago 201222 ago 2012
    PSG SOLUTIONS PLC14 feb 200614 feb 2006
    LONDON & BOSTON INVESTMENTS PLC 28 set 200128 set 2001
    CYBERTEC HOLDINGS PLC06 giu 199606 giu 1996
    MONEYADVANCE PUBLIC LIMITED COMPANY12 mar 199612 mar 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di SRG REALISATIONS (2017) PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per SRG REALISATIONS (2017) PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    18 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 lug 2019

    20 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 lug 2018

    22 pagineLIQ03

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Distribution in specie/distribution to b shareholders 06/04/2018
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    55 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed security research group PLC\certificate issued on 15/08/17
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name15 ago 2017

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2017 al 17 lug 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 17 lug 2017

    LRESSP

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2017

    33 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Vicarage House 58-60 Kensington Church Street London W8 4DB England a 40 31st Floor Bank Street London E14 5NR in data 13 lug 2017

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2017 con aggiornamenti

    44 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2016

    33 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 mar 2016

    • Capitale: GBP 3,961,812
    3 pagineSH01

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2016 con elenco di azionisti in blocco

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 apr 2016

    Stato del capitale al 04 apr 2016

    • Capitale: GBP 3,929,589.6
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato The Registry Beckenham Road Beckenham Kent BR3 4TU

    1 pagineAD03

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 25 gen 2016

    • Capitale: GBP 3,929,589.6
    3 pagineSH01

    Nomina di Mr John Arthur Warwick come amministratore in data 23 dic 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2015

    31 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 133 Ebury Street London SW1W 9QU a Vicarage House 58-60 Kensington Church Street London W8 4DB in data 29 giu 2015

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di SRG REALISATIONS (2017) PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARWICK, John Arthur
    Flat 308 Peninsula Apartments
    4 Praed Street Paddington
    W2 1JE London
    Segretario
    Flat 308 Peninsula Apartments
    4 Praed Street Paddington
    W2 1JE London
    BritishDirector16010920003
    CONNOR, Bernard Cavan
    Willoughbridge
    TF9 4JJ Market Drayton
    Long Shoots
    Shropshire
    England
    Amministratore
    Willoughbridge
    TF9 4JJ Market Drayton
    Long Shoots
    Shropshire
    England
    United KingdomBritishDirector120653840002
    MERVIS, Jonathan Philip
    31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    40
    England
    Amministratore
    31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    40
    England
    EnglandBritishDirector6534190005
    WARWICK, John Arthur
    31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    40
    England
    Amministratore
    31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    40
    England
    EnglandBritishChartered Accountant16010920003
    MAY, John Joseph
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    Segretario
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant211557370001
    PHILLIPS, Anne Elizabeth
    Jasmine Dean
    Tunworth Road Mapledurwell
    RG25 2LU Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    Jasmine Dean
    Tunworth Road Mapledurwell
    RG25 2LU Basingstoke
    Hampshire
    British44735140001
    SELBY, David Frederick Mclaren
    Hayward Green Farm
    West Woodhay
    RG20 0BJ Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Hayward Green Farm
    West Woodhay
    RG20 0BJ Newbury
    Berkshire
    BritishFca Cd14775130001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Segretario
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Edward
    1st Floor 100 Belsize Lane
    Belsize Village
    NW3 5BB London
    Amministratore
    1st Floor 100 Belsize Lane
    Belsize Village
    NW3 5BB London
    BritishDirector74931040003
    BARTON, Christopher Synge
    Carpenters Cottage
    Compton Pauncefoot
    BA22 7EN Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    Carpenters Cottage
    Compton Pauncefoot
    BA22 7EN Yeovil
    Somerset
    United KingdomBritishChairman107260300001
    BROWN, Tweedie Mcgarth
    133 Ebury Street
    London
    SW1W 9QU
    Amministratore
    133 Ebury Street
    London
    SW1W 9QU
    EnglandBritishDirector154541620001
    BURLEY, John Martin
    Two The Dale
    DE4 4EJ Wirksworth
    Derbyshire
    Amministratore
    Two The Dale
    DE4 4EJ Wirksworth
    Derbyshire
    BritishCompany Director107621350001
    BURTON, Christopher John
    9 Gables Avenue
    WD6 4SP Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Gables Avenue
    WD6 4SP Borehamwood
    Hertfordshire
    BritishAccountant2382240001
    COTGROVE, Peter Leonard George
    21 Cages Way Melton Park
    Woodbridge
    IP12 1TE Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    21 Cages Way Melton Park
    Woodbridge
    IP12 1TE Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishConsultant80666880001
    DART, Geoffrey Gilbert
    133 Ebury Street
    SW1W 9QU London
    Amministratore
    133 Ebury Street
    SW1W 9QU London
    AustralianDirector76453360006
    ELSTEIN, Jonathan Michael
    15a Fitzjohns Avenue
    NW3 5JY London
    Amministratore
    15a Fitzjohns Avenue
    NW3 5JY London
    EnglandBritishSolicitor70057160003
    HESTER, Julie Amanda
    1137 North Lakeshore Drive
    Sarasota
    34231 Usa Florida
    Usa
    Amministratore
    1137 North Lakeshore Drive
    Sarasota
    34231 Usa Florida
    Usa
    UsaBritishCompany Director99548840001
    HOLME, John David Gawain
    Hodders Wood
    40 Littleheath Lane
    KT11 2QN Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Hodders Wood
    40 Littleheath Lane
    KT11 2QN Cobham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant110178190001
    KOMLOSY, Stephen Anton
    1 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector65257060002
    LISTER, Alan John
    Le Mont Saint
    Rue Du Hamel
    GY7 9XX St Saviour
    Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Le Mont Saint
    Rue Du Hamel
    GY7 9XX St Saviour
    Guernsey
    Channel Islands
    BritishCompany Director41671790001
    MAY, John Joseph
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    Amministratore
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant211557370001
    MITCHELL, Ian Robert
    Connybear Wood St Marychurch Road
    Coffinswell
    TQ12 4SE Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Connybear Wood St Marychurch Road
    Coffinswell
    TQ12 4SE Newton Abbot
    Devon
    United KingdomBritishDirector60444540001
    RAE, James William
    33 William Road
    BH7 7BB Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    33 William Road
    BH7 7BB Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritishDirector68378600001
    SELBY, David Frederick Mclaren
    Hayward Green Farm
    West Woodhay
    RG20 0BJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Hayward Green Farm
    West Woodhay
    RG20 0BJ Newbury
    Berkshire
    BritishFca14775130001
    SMALLWOOD, Malcolm Terry
    34 Long Barton
    Kingsteignton
    TQ12 3QP Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    34 Long Barton
    Kingsteignton
    TQ12 3QP Newton Abbot
    Devon
    BritishBusiness Manager56309470001
    WARWICK, John Arthur
    Flat 308 Peninsula Apartments
    4 Praed Street Paddington
    W2 1JE London
    Amministratore
    Flat 308 Peninsula Apartments
    4 Praed Street Paddington
    W2 1JE London
    EnglandBritishDirector16010920003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Amministratore
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    44503290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Amministratore delegato nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SRG REALISATIONS (2017) PLC?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    12 mar 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    SRG REALISATIONS (2017) PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 gen 2006
    Consegnato il 17 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Memorandum of deposit and charge
    Creato il 01 ott 2004
    Consegnato il 15 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The stocks, shares, bonds, debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank being all marketable securities whilst in the possession of the bank which are now or may hereafter be deposited with the bank by the company or on behalf of the company.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 giu 2004
    Consegnato il 10 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 15 apr 2004
    Consegnato il 28 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 feb 2004
    Consegnato il 28 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 19 ago 2003
    Consegnato il 28 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Details of charged account(s) barclays bank PLC re london & boston investments PLC business tracker account account number 10635413. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SRG REALISATIONS (2017) PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 lug 2017Inizio della liquidazione
    07 mag 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gary Paul Shankland
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Kirstie Jane Provan
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0