SRG REALISATIONS (2017) PLC
Panoramica
Nome della società | SRG REALISATIONS (2017) PLC |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società per azioni |
Numero di società | 03170812 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SRG REALISATIONS (2017) PLC?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SRG REALISATIONS (2017) PLC?
Indirizzo della sede legale | 40 31st Floor Bank Street E14 5NR London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SRG REALISATIONS (2017) PLC?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SECURITY RESEARCH GROUP PLC | 22 ago 2012 | 22 ago 2012 |
PSG SOLUTIONS PLC | 14 feb 2006 | 14 feb 2006 |
LONDON & BOSTON INVESTMENTS PLC | 28 set 2001 | 28 set 2001 |
CYBERTEC HOLDINGS PLC | 06 giu 1996 | 06 giu 1996 |
MONEYADVANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | 12 mar 1996 | 12 mar 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SRG REALISATIONS (2017) PLC?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per SRG REALISATIONS (2017) PLC?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 18 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 lug 2019 | 20 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 lug 2018 | 22 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 55 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed security research group PLC\certificate issued on 15/08/17 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2017 al 17 lug 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2017 | 33 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Vicarage House 58-60 Kensington Church Street London W8 4DB England a 40 31st Floor Bank Street London E14 5NR in data 13 lug 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2017 con aggiornamenti | 44 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2016 | 33 pagine | AA | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 mar 2016
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 mar 2016 con elenco di azionisti in blocco | 15 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato The Registry Beckenham Road Beckenham Kent BR3 4TU | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 25 gen 2016
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr John Arthur Warwick come amministratore in data 23 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2015 | 31 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 133 Ebury Street London SW1W 9QU a Vicarage House 58-60 Kensington Church Street London W8 4DB in data 29 giu 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SRG REALISATIONS (2017) PLC?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARWICK, John Arthur | Segretario | Flat 308 Peninsula Apartments 4 Praed Street Paddington W2 1JE London | British | Director | 16010920003 | |||||
CONNOR, Bernard Cavan | Amministratore | Willoughbridge TF9 4JJ Market Drayton Long Shoots Shropshire England | United Kingdom | British | Director | 120653840002 | ||||
MERVIS, Jonathan Philip | Amministratore | 31st Floor Bank Street E14 5NR London 40 England | England | British | Director | 6534190005 | ||||
WARWICK, John Arthur | Amministratore | 31st Floor Bank Street E14 5NR London 40 England | England | British | Chartered Accountant | 16010920003 | ||||
MAY, John Joseph | Segretario | 2 Belmont Way GU15 2BH Camberley Surrey | British | Chartered Accountant | 211557370001 | |||||
PHILLIPS, Anne Elizabeth | Segretario | Jasmine Dean Tunworth Road Mapledurwell RG25 2LU Basingstoke Hampshire | British | 44735140001 | ||||||
SELBY, David Frederick Mclaren | Segretario | Hayward Green Farm West Woodhay RG20 0BJ Newbury Berkshire | British | Fca Cd | 14775130001 | |||||
EPS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ADAMS, Edward | Amministratore | 1st Floor 100 Belsize Lane Belsize Village NW3 5BB London | British | Director | 74931040003 | |||||
BARTON, Christopher Synge | Amministratore | Carpenters Cottage Compton Pauncefoot BA22 7EN Yeovil Somerset | United Kingdom | British | Chairman | 107260300001 | ||||
BROWN, Tweedie Mcgarth | Amministratore | 133 Ebury Street London SW1W 9QU | England | British | Director | 154541620001 | ||||
BURLEY, John Martin | Amministratore | Two The Dale DE4 4EJ Wirksworth Derbyshire | British | Company Director | 107621350001 | |||||
BURTON, Christopher John | Amministratore | 9 Gables Avenue WD6 4SP Borehamwood Hertfordshire | British | Accountant | 2382240001 | |||||
COTGROVE, Peter Leonard George | Amministratore | 21 Cages Way Melton Park Woodbridge IP12 1TE Ipswich Suffolk | England | British | Consultant | 80666880001 | ||||
DART, Geoffrey Gilbert | Amministratore | 133 Ebury Street SW1W 9QU London | Australian | Director | 76453360006 | |||||
ELSTEIN, Jonathan Michael | Amministratore | 15a Fitzjohns Avenue NW3 5JY London | England | British | Solicitor | 70057160003 | ||||
HESTER, Julie Amanda | Amministratore | 1137 North Lakeshore Drive Sarasota 34231 Usa Florida Usa | Usa | British | Company Director | 99548840001 | ||||
HOLME, John David Gawain | Amministratore | Hodders Wood 40 Littleheath Lane KT11 2QN Cobham Surrey | England | British | Chartered Accountant | 110178190001 | ||||
KOMLOSY, Stephen Anton | Amministratore | 1 Woodbank Avenue SL9 7PY Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 65257060002 | ||||
LISTER, Alan John | Amministratore | Le Mont Saint Rue Du Hamel GY7 9XX St Saviour Guernsey Channel Islands | British | Company Director | 41671790001 | |||||
MAY, John Joseph | Amministratore | 2 Belmont Way GU15 2BH Camberley Surrey | England | British | Chartered Accountant | 211557370001 | ||||
MITCHELL, Ian Robert | Amministratore | Connybear Wood St Marychurch Road Coffinswell TQ12 4SE Newton Abbot Devon | United Kingdom | British | Director | 60444540001 | ||||
RAE, James William | Amministratore | 33 William Road BH7 7BB Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | Director | 68378600001 | ||||
SELBY, David Frederick Mclaren | Amministratore | Hayward Green Farm West Woodhay RG20 0BJ Newbury Berkshire | British | Fca | 14775130001 | |||||
SMALLWOOD, Malcolm Terry | Amministratore | 34 Long Barton Kingsteignton TQ12 3QP Newton Abbot Devon | British | Business Manager | 56309470001 | |||||
WARWICK, John Arthur | Amministratore | Flat 308 Peninsula Apartments 4 Praed Street Paddington W2 1JE London | England | British | Director | 16010920003 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
MIKJON LIMITED | Amministratore | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 44503290001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SRG REALISATIONS (2017) PLC?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
12 mar 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
SRG REALISATIONS (2017) PLC ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 12 gen 2006 Consegnato il 17 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of deposit and charge | Creato il 01 ott 2004 Consegnato il 15 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The stocks, shares, bonds, debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank being all marketable securities whilst in the possession of the bank which are now or may hereafter be deposited with the bank by the company or on behalf of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 25 giu 2004 Consegnato il 10 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 15 apr 2004 Consegnato il 28 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 17 feb 2004 Consegnato il 28 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge over credit balances | Creato il 19 ago 2003 Consegnato il 28 ago 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Details of charged account(s) barclays bank PLC re london & boston investments PLC business tracker account account number 10635413. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
SRG REALISATIONS (2017) PLC ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0