EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03170995 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Sevendale House 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Greater Manchester United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FLAGSHIP CARE (SURREY) LIMITED | 09 mag 1997 | 09 mag 1997 |
| BROOMCO (1051) LIMITED | 12 mar 1996 | 12 mar 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ England a Sevendale House 3rd Floor, Suite 6C 5-7 Dale Street Manchester Greater Manchester M1 1JB in data 06 nov 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Emma Margaret Clarke come segretario in data 16 ott 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Thomas Adams come segretario in data 16 ott 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10-11 Welken House Charterhouse Square London EC1M 6EH England a 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ in data 05 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Thomas Adams come segretario in data 12 ott 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gordon Neil Springett come segretario in data 12 ott 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Alistair Martin Gillespie come amministratore in data 05 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jennifer Louise Crouch come amministratore in data 05 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Daniel Knight come amministratore in data 01 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sion Laurence Jones come amministratore in data 01 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Jennifer Louise Crouch come amministratore in data 01 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Philip Arthur Would come amministratore in data 01 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Emma Margaret | Segretario | 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Sevendale House Greater Manchester United Kingdom | 251514980001 | |||||||
| GILLESPIE, Robert Alistair Martin | Amministratore | 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Sevendale House Greater Manchester United Kingdom | England | British | 230652780001 | |||||
| WOULD, Philip Arthur | Amministratore | 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Sevendale House Greater Manchester United Kingdom | England | British | 157945610001 | |||||
| ADAMS, David Thomas | Segretario | 120 Aldersgate Street EC1A 4JQ London 5th Floor England | 238967880001 | |||||||
| CROSSLEY, Hugh Barnabas | Segretario | Stonebridge House Wiveton NR25 7TP Holt Norfolk | British | 107284040001 | ||||||
| HANDLEY, David Michael | Segretario | 13 Shillingstone Close Harwood BL2 3PD Bolton Lancashire | British | 52899270001 | ||||||
| PINNINGTON, Ian Harry | Segretario | Shillingford Bucklow View Bowdon WA14 3JP Altrincham Cheshire | British | 11801040001 | ||||||
| SMITH, Jonathan Charles | Segretario | c/o King Sturge Finance Warwick Street W1B 5NH London 30 United Kingdom | British | 127121960001 | ||||||
| SPRINGETT, Gordon Neil | Segretario | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | 169292500001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
| CHRITSTIE, Rory William | Amministratore | c/o King Sturge Finance Warwick Street W1B 5NH London 30 United Kingdom | United Kingdom | British | 152827480001 | |||||
| CROUCH, Jennifer Louise | Amministratore | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | England | British | 199682550001 | |||||
| HANDLEY, David Michael | Amministratore | 13 Shillingstone Close Harwood BL2 3PD Bolton Lancashire | United Kingdom | British | 52899270001 | |||||
| HARRIS, John David | Amministratore | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London | England | British | 174333200001 | |||||
| JACKSON, Geoffrey Allan | Amministratore | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London | United Kingdom | British | 79174450001 | |||||
| JONES, Sion Laurence | Amministratore | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | United Kingdom | English | 137554960001 | |||||
| KNIGHT, Richard Daniel | Amministratore | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | United Kingdom | British | 162323970001 | |||||
| MADDIN, Keith John | Amministratore | 27 Wayneflete Tower Avenue KT10 8QQ Esher Surrey | United Kingdom | British | 141926560001 | |||||
| NUTTALL, Lennard Joseph | Amministratore | 90 Moss Lane BL1 6LY Bolton | England | British | 51238440001 | |||||
| OLDHAM, James William | Amministratore | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London | Uk | British | 127121570001 | |||||
| PAYNE, Richard William Norris | Amministratore | Harland House Harland Way, Southborough TW4 0TQ Tunbridge Wells Kent | British | 77845170001 | ||||||
| RICHARDSON, Philip | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 81186940003 | ||||||
| SALISBURY, Nicholas William | Amministratore | Barclays Bank Plc 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 4380320005 | |||||
| SEDDON, Christopher John | Amministratore | 88 Roe Green Worsley M28 2RN Manchester | United Kingdom | British | 3813770002 | |||||
| TINDALL, Terence William | Amministratore | 19 Oak Tree Close GU25 4JF Virginia Water Surrey | England | British | 4380330001 | |||||
| WHITAKER, Jack Leeming | Amministratore | Highcroft Foxholes Road Horwich BL6 6AL Bolton Greater Manchester | British | 24399020001 | ||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitix Healthcare Limited | 01 mar 2017 | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 18 dic 2007 Consegnato il 22 dic 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road coulsden t/no SY47077 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 11 dic 1998 Consegnato il 29 dic 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari In retentions account number 40652857. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 11 dic 1998 Consegnato il 29 dic 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Account number 30440701. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 mar 1996 Consegnato il 12 apr 1996 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road, coulsdon t/no. SY47077 and all buildings and fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0