EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED

EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03170995
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sevendale House 3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FLAGSHIP CARE (SURREY) LIMITED09 mag 199709 mag 1997
    BROOMCO (1051) LIMITED12 mar 199612 mar 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ England a Sevendale House 3rd Floor, Suite 6C 5-7 Dale Street Manchester Greater Manchester M1 1JB in data 06 nov 2018

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Emma Margaret Clarke come segretario in data 16 ott 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Thomas Adams come segretario in data 16 ott 2018

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 10-11 Welken House Charterhouse Square London EC1M 6EH England a 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ in data 05 ott 2018

    1 pagineAD01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr David Thomas Adams come segretario in data 12 ott 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Gordon Neil Springett come segretario in data 12 ott 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Robert Alistair Martin Gillespie come amministratore in data 05 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jennifer Louise Crouch come amministratore in data 05 lug 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    26 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2016

    Stato del capitale al 14 mar 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Richard Daniel Knight come amministratore in data 01 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sion Laurence Jones come amministratore in data 01 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Jennifer Louise Crouch come amministratore in data 01 apr 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Philip Arthur Would come amministratore in data 01 apr 2015

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARKE, Emma Margaret
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Segretario
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    251514980001
    GILLESPIE, Robert Alistair Martin
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Amministratore
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish230652780001
    WOULD, Philip Arthur
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Amministratore
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish157945610001
    ADAMS, David Thomas
    120 Aldersgate Street
    EC1A 4JQ London
    5th Floor
    England
    Segretario
    120 Aldersgate Street
    EC1A 4JQ London
    5th Floor
    England
    238967880001
    CROSSLEY, Hugh Barnabas
    Stonebridge House
    Wiveton
    NR25 7TP Holt
    Norfolk
    Segretario
    Stonebridge House
    Wiveton
    NR25 7TP Holt
    Norfolk
    British107284040001
    HANDLEY, David Michael
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    Segretario
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    British52899270001
    PINNINGTON, Ian Harry
    Shillingford Bucklow View
    Bowdon
    WA14 3JP Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    Shillingford Bucklow View
    Bowdon
    WA14 3JP Altrincham
    Cheshire
    British11801040001
    SMITH, Jonathan Charles
    c/o King Sturge Finance
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    United Kingdom
    Segretario
    c/o King Sturge Finance
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    United Kingdom
    British127121960001
    SPRINGETT, Gordon Neil
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    Segretario
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    169292500001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    CHRITSTIE, Rory William
    c/o King Sturge Finance
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o King Sturge Finance
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    United Kingdom
    United KingdomBritish152827480001
    CROUCH, Jennifer Louise
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    Amministratore
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    EnglandBritish199682550001
    HANDLEY, David Michael
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritish52899270001
    HARRIS, John David
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Amministratore
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    EnglandBritish174333200001
    JACKSON, Geoffrey Allan
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Amministratore
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    United KingdomBritish79174450001
    JONES, Sion Laurence
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    Amministratore
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    United KingdomEnglish137554960001
    KNIGHT, Richard Daniel
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    Amministratore
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    United KingdomBritish162323970001
    MADDIN, Keith John
    27 Wayneflete Tower Avenue
    KT10 8QQ Esher
    Surrey
    Amministratore
    27 Wayneflete Tower Avenue
    KT10 8QQ Esher
    Surrey
    United KingdomBritish141926560001
    NUTTALL, Lennard Joseph
    90 Moss Lane
    BL1 6LY Bolton
    Amministratore
    90 Moss Lane
    BL1 6LY Bolton
    EnglandBritish51238440001
    OLDHAM, James William
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Amministratore
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    UkBritish127121570001
    PAYNE, Richard William Norris
    Harland House
    Harland Way, Southborough
    TW4 0TQ Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Harland House
    Harland Way, Southborough
    TW4 0TQ Tunbridge Wells
    Kent
    British77845170001
    RICHARDSON, Philip
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British81186940003
    SALISBURY, Nicholas William
    Barclays Bank Plc
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    Barclays Bank Plc
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish4380320005
    SEDDON, Christopher John
    88 Roe Green
    Worsley
    M28 2RN Manchester
    Amministratore
    88 Roe Green
    Worsley
    M28 2RN Manchester
    United KingdomBritish3813770002
    TINDALL, Terence William
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    EnglandBritish4380330001
    WHITAKER, Jack Leeming
    Highcroft Foxholes Road
    Horwich
    BL6 6AL Bolton
    Greater Manchester
    Amministratore
    Highcroft Foxholes Road
    Horwich
    BL6 6AL Bolton
    Greater Manchester
    British24399020001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Equitix Healthcare Limited
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11
    England
    01 mar 2017
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleLimited Liability Partnership Act 2000
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione06371955
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 18 dic 2007
    Consegnato il 22 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road coulsden t/no SY47077 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 11 dic 1998
    Consegnato il 29 dic 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    In retentions account number 40652857. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 11 dic 1998
    Consegnato il 29 dic 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Account number 30440701. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 12 apr 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road, coulsdon t/no. SY47077 and all buildings and fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0