SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03171644
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    257b Croydon Road
    Beckenham
    BR3 3PS Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STARMODEX LIMITED12 mar 199612 mar 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagine4.71
    A5GUCZEW

    Indirizzo della sede legale modificato da 257B Croydon Road Beckenham Kent BR3 3PS a 257B Croydon Road Beckenham Kent BR3 3PS in data 09 mar 2016

    2 pagineAD01
    A51L7V8Z

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600
    A51L7V8F

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70
    A51L7V8R

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 feb 2016

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2014

    8 pagineAA
    A4CSTH4A

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    2 pagineMR04
    X4A8EJJL

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mar 2015

    Stato del capitale al 03 mar 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01
    X42ETZQW

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD
    A3HLTY5F

    Bilancio redatto al 31 ott 2013

    11 pagineAA
    A37DBRC3

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 feb 2014

    Stato del capitale al 28 feb 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01
    X32NMEB4

    Memorandum e Statuto

    7 pagineMEM/ARTS
    A2ZOWBZL

    Nomina di Mr Federico Vecchioli come amministratore

    2 pagineAP01
    X2G7QMP6

    Cessazione della carica di Peter Gowers come amministratore

    1 pagineTM01
    X2G7QLRL

    Bilancio redatto al 31 ott 2012

    10 pagineAA
    L2DR2HA9

    Cessazione della carica di Richard Hodsden come amministratore

    1 pagineTM01
    X28QU009

    Nomina di Mr Andrew Brian Jones come amministratore

    2 pagineAP01
    X27VUHLT

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X250CZ8H

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Darren Gowers il 31 ago 2012

    2 pagineCH01
    X1GYOD9N

    legacy

    3 pagineMG02
    A1A5MS6Q

    legacy

    42 pagineMG01
    A18STEJ5

    Bilancio redatto al 31 ott 2011

    10 pagineAA
    A183755C

    Bilancio annuale redatto al 29 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X15I8QDV

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    X8KULT0X

    Chi sono gli amministratori di SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AHMED, Sam
    Croydon Road
    Beckenham
    BR3 3PS Kent
    257b
    Segretario
    Croydon Road
    Beckenham
    BR3 3PS Kent
    257b
    BritishChartered Accountant130116980001
    JONES, Andrew Brian
    Croydon Road
    Beckenham
    BR3 3PS Kent
    257b
    Amministratore
    Croydon Road
    Beckenham
    BR3 3PS Kent
    257b
    EnglandEnglishChartered Accountant178066050001
    PENNISTON, David Roy
    Croydon Road
    Beckenham
    BR3 3PS Kent
    257b
    Amministratore
    Croydon Road
    Beckenham
    BR3 3PS Kent
    257b
    EnglandEnglishCompany Director128621170001
    VECCHIOLI, Federico
    Croydon Road
    Beckenham
    BR3 3PS Kent
    257b
    Amministratore
    Croydon Road
    Beckenham
    BR3 3PS Kent
    257b
    EnglandFrenchCompany Director158800170002
    DAVIS, Paul Malcolm
    70 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    70 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    BritishChartered Accountant30526830001
    HODSDEN, Richard David
    Oransay
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    Oransay
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director183337930001
    O'DRISCOLL, Joseph Francis
    93 Oatlands Drive
    KT13 9LH Weybridge
    Surrey
    Segretario
    93 Oatlands Drive
    KT13 9LH Weybridge
    Surrey
    BritishFinancial Controller12686190001
    WILLIAMS, Stephen Wilfred
    High Veld
    Newlands Drive
    SL6 4LL Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    High Veld
    Newlands Drive
    SL6 4LL Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector69845900002
    WISEMAN, David Charles
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    Segretario
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    BritishFinancial Director50807620002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    COLLINS, Paul Anthony
    27 Prices Court
    Cotton Row
    SW11 3YR London
    Amministratore
    27 Prices Court
    Cotton Row
    SW11 3YR London
    BritishCompany Director81395790001
    GOWERS, Peter Darren
    C/O Safestore Holdings Plc
    Brittanic House
    WD6 2BT Stirling Way, Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    C/O Safestore Holdings Plc
    Brittanic House
    WD6 2BT Stirling Way, Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director157443090002
    HODSDEN, Richard David
    C/O Safestore Holdings Plc
    Brittanic House
    WD6 2BT Stirling Way, Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    C/O Safestore Holdings Plc
    Brittanic House
    WD6 2BT Stirling Way, Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director183337930001
    LEWIS, Philip Geoffrey
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    Amministratore
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    EnglandBritishCompany Director6639590001
    LIPMAN, Larry Glenn
    144 Great North Way
    NW4 1EG London
    Amministratore
    144 Great North Way
    NW4 1EG London
    BritishDirector62622410001
    MCEWAN, Catherine
    41 The Drive
    EN6 2AR Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    41 The Drive
    EN6 2AR Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishManaging Director59194080001
    TROWER, Clive James
    35 The Ridgeway
    KT22 9BE Fetcham
    Surrey
    Amministratore
    35 The Ridgeway
    KT22 9BE Fetcham
    Surrey
    BritishCompany Director49858770001
    TROWER, Peter Leonard James
    Greenmount 11 Leigh Hill Road
    KT11 2HS Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Greenmount 11 Leigh Hill Road
    KT11 2HS Cobham
    Surrey
    BritishCompany Director46411260001
    WILLIAMS, Stephen Wilfred
    C/O Safestore Holdings Plc
    Brittanic House
    WD6 2BT Stirling Way, Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    C/O Safestore Holdings Plc
    Brittanic House
    WD6 2BT Stirling Way, Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector177426370001
    WISEMAN, David Charles
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    EnglandBritishFinancial Director50807620002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 mag 2012
    Consegnato il 12 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H acton 5-10 eastman road acton london t/no NGL339040, f/h alexandra palace 118 priory road alexandra palace london t/no EGL175049 and l/h barking & dagenham land and buildings at maybell's commercial estate ripple road barking t/no EGL558470 (for full list of properties charged please see form MG01) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 mar 2010
    Consegnato il 09 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 13 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the each obligor and each grantor of a security to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts uncalled capital buildings and fixtures,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 2004
    Consegnato il 05 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a underground car park at camelford walk, lancaster west estate, london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries) (the Security
    Transazioni
    • 05 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2004
    Consegnato il 01 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Security Beneficiaries) (Securitytrustee)
    Transazioni
    • 01 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 nov 2003
    Consegnato il 02 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited in Its Capacity as Security Trustee for Itself and Theinvestors
    Transazioni
    • 02 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 nov 2003
    Consegnato il 22 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold property known as underground car park at camelford walk lancaster west estate london W1O. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 set 2003
    Consegnato il 02 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 giu 1999
    Consegnato il 14 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as underground car park at camelford walk lancaster gate london W.10. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 apr 1999
    Consegnato il 05 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SAFESTORE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 feb 2016Inizio della liquidazione
    11 gen 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Tommaso Ahmad
    Bailey Ahmad Limited 257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent
    Praticante
    Bailey Ahmad Limited 257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent
    Paul Bailey
    Bailey Ahmad Limited 257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent
    Praticante
    Bailey Ahmad Limited 257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0