SPORTING LIFE UK LIMITED

SPORTING LIFE UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPORTING LIFE UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03177760
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPORTING LIFE UK LIMITED?

    • (9251) /
    • (9262) /

    Dove si trova SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PA SPORTING LIFE LIMITED29 nov 199629 nov 1996
    PA WEATHERBYS RACING COMMUNICATIONS LIMITED17 giu 199617 giu 1996
    DIPLEMA 324 LIMITED26 mar 199626 mar 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 mar 2012

    4 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Grant Way Isleworth Middlesex TW7 5QD in data 13 apr 2011

    1 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 25 mar 2011

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di Christopher Jon Taylor come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di David Joseph Gormley come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Flint come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Steele come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Piers Croton come amministratore

    2 pagineTM01

    Stato del capitale al 18 feb 2011

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 feb 2011

    • Capitale: GBP 18,266,902
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    20 pagineAA

    Nomina di Simon Naunton Steele come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Vincent Russell come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    25 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GORMLEY, David Joseph
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    Segretario
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    British150780210001
    GORMLEY, David Joseph
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Amministratore
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Secretary150780210001
    TAYLOR, Christopher Jon
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Amministratore
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Secretary135143490001
    BROWN, Steven John
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    Segretario
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    BritishManaging Director Chartered Ac3379480001
    GALVIN, Andrew Michael
    North Longlands Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8JN Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    North Longlands Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8JN Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector49667690003
    KENNEDY, Christina Lillian
    Walnut House
    Walnut Gardens Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    Segretario
    Walnut House
    Walnut Gardens Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    BritishSecretary7909160003
    MARJORIBANKS, Richard John Bradley
    8 Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    8 Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    North Yorkshire
    British56196620001
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Segretario nominato
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    ADSHEAD, Vivienne
    The Old Chapel
    Tong Park, Baildon
    BD17 7QH Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Chapel
    Tong Park, Baildon
    BD17 7QH Shipley
    West Yorkshire
    BritishCommercial Director68166530001
    ALLWOOD, Charles John
    Park Farm The Twist
    Wigginton
    HP23 6DU Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    Park Farm The Twist
    Wigginton
    HP23 6DU Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director35681240003
    ANNAT, David Christie
    Watergap
    Dig Street
    SK17 0AQ Hartington
    Derbyshire
    Amministratore
    Watergap
    Dig Street
    SK17 0AQ Hartington
    Derbyshire
    BritishCompany Director2145940001
    ANNAT, David Christie
    Watergap
    Dig Street
    SK17 0AQ Hartington
    Derbyshire
    Amministratore
    Watergap
    Dig Street
    SK17 0AQ Hartington
    Derbyshire
    BritishManaging Director2145940001
    BROWN, Steven John
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director3379480001
    CROTON, Piers Maitland Adrian
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Amministratore
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    BritishDirector36253150002
    DUBENS, Peter Adam Daiches
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    Amministratore
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    SwitzerlandBritishDirector153016810001
    EWING, Margaret
    Maraval
    Hamm Court
    KT13 8YG Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Maraval
    Hamm Court
    KT13 8YG Weybridge
    Surrey
    BritishFinancial Director68009020001
    FLINT, Richard
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Amministratore
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    BritishCompany Director103872130004
    GALVIN, Andrew Michael
    North Longlands Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8JN Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    North Longlands Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8JN Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector49667690003
    GRIFFITH, Andrew John
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    Amministratore
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    United KingdomBritishChief Financial Officer129926510001
    NORRIS, John Lionel
    Roseland 42 Debdale Road
    NN8 5AJ Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    Roseland 42 Debdale Road
    NN8 5AJ Wellingborough
    Northamptonshire
    United KingdomBritishBusiness Executive15693810004
    PEREIRA, Alan Dennis
    30 Kingscliffe Gardens
    SW19 6NR London
    Amministratore
    30 Kingscliffe Gardens
    SW19 6NR London
    BritishDirector61856670002
    POTTS, Paul John
    Western Gardens
    Ealing
    W5 3RU London
    26
    Amministratore
    Western Gardens
    Ealing
    W5 3RU London
    26
    United KingdomBritishChief Executive43329700002
    REARDON, Jonathan Andrew
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    British900005030001
    REED, Jeremy Peter
    Palletts Farmhouse
    High Street
    CB11 3PE Newport
    Essex
    Amministratore
    Palletts Farmhouse
    High Street
    CB11 3PE Newport
    Essex
    BritishManaging Director94644540001
    RIKLIN, Cornel Carl
    11 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    11 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    BritishCompany Director50935910001
    RUSSELL, Vincent Harvey
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Amministratore
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    United KingdomBritishAccountant168038230001
    RUST, Nicholas John
    2 Manor Court
    Little Ouseburn
    YO26 9TB York
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Manor Court
    Little Ouseburn
    YO26 9TB York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director112088680001
    SEMEL, Eric
    33 Chesham Street Flat 8
    SW1X 8NQ London
    Amministratore
    33 Chesham Street Flat 8
    SW1X 8NQ London
    AmericanDirector102427690001
    SHERWOOD, Barrie John
    1 Lodge Road
    Sharnbrook
    MK44 1JB Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    1 Lodge Road
    Sharnbrook
    MK44 1JB Bedford
    Bedfordshire
    BritishAccountant13479190001
    SIMPSON, Robert Brian
    1 Combe Royal Crescent
    BA2 6EZ Bath
    Avon
    Amministratore
    1 Combe Royal Crescent
    BA2 6EZ Bath
    Avon
    BritishChief Executive100368690001
    STEELE, Simon Naunton
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Plc
    Middlesex
    Amministratore
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Plc
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant220122710001
    WEATHERBY, Jonathan Roger, Sir
    Preston Lodge
    Withcote
    LE15 8DP Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    Preston Lodge
    Withcote
    LE15 8DP Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritishBusiness Executive10579020003
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Amministratore delegato nominato
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001

    SPORTING LIFE UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 ott 2004
    Consegnato il 21 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of variation
    Creato il 03 mar 2000
    Consegnato il 22 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    To the chargee the amount secured by a secured loan note dated 28 june 1996 and granted by the company in favour of weatherbys group limited as varied by a memorandum of variation dated 28 november 1996 and as further varied by this memorandum of variation is £1,085,000 and such additional sums (up to a further £415,000) as may be advanced under the terms of the secured loan note
    Brevi particolari
    The property charge is that charged by the secured loan note as described in the form 395 for such loan note as registered on the 8/7/96.
    Persone aventi diritto
    • Mgn Limited(Pursuant to an Assignment from Weatherbys Group Limited Dated 28 November 1996)
    Transazioni
    • 22 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of variation
    Creato il 03 mar 2000
    Consegnato il 22 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    To the chargee the amount secured by a secured loan note dated 28 june 1996 and granted by the company in favour of ananova limited (formerly pa news limited) as varied by a memorandum of variation and as further varied by this memorandum of variation is £1,085,000 and such additional sums (up to a further £415,000) as may be advanced under the terms of the secured loan note
    Brevi particolari
    The property charged is that charged by the secured loan note as described in the form 395 for such loan note as registered on the 15/7/96.
    Persone aventi diritto
    • The Press Association Limited(Pursuant to an Assignment from Ananova Limiteddated 3 March 2000)
    Transazioni
    • 22 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of variation
    Creato il 28 nov 1996
    Consegnato il 18 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £350,000 due or to become from the company to the chargee
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pa News Limited
    Transazioni
    • 18 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secured loan note
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 15 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pa News Limited
    Transazioni
    • 15 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secured loan note
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 08 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the secured loan note
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Weatherbys Group Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SPORTING LIFE UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 gen 2013Data di scioglimento
    25 mar 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0