IMAGELINX UK LIMITED

IMAGELINX UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIMAGELINX UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03182772
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IMAGELINX UK LIMITED?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova IMAGELINX UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Bridge Street House
    30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IMAGELINX UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IMAGE LINX INTERNATIONAL LIMITED04 apr 199604 apr 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di IMAGELINX UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per IMAGELINX UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    18 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2017

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2016

    10 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2015

    14 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 45 Lilyville Road London SW6 5DP a New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street London EC4V 6BJ in data 17 set 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 set 2014

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 04 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 giu 2014

    Stato del capitale al 13 giu 2014

    • Capitale: GBP 92,987
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park, Lowmoor Road Kirkby in Ashfield Nottinghamshire NG17 7RB Uk* in data 19 set 2013

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 9 in parte

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in parte

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di Louise Palmer come segretario

    1 pagineTM02

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 04 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Canavan come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    11 pagineMG01

    Cessazione della carica di Louise Palmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 apr 2011

    16 pagineAR01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 dic 2004

    • Capitale: GBP 99,987
    2 pagineSH01

    Chi sono gli amministratori di IMAGELINX UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RAE, Alistair Kynoch
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    Amministratore
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    EnglandBritishDirector53806830002
    KENDALL, Jonathan Mark
    438 Kedleston Road
    Allestree
    DE22 2TG Derby
    Segretario
    438 Kedleston Road
    Allestree
    DE22 2TG Derby
    BritishAccountant67193040002
    PALMER, Louise
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    British119011320002
    WILLIAMS, Paul
    28 Granby Avenue
    NG19 7BT Mansfield
    Nottinghamshire
    Segretario
    28 Granby Avenue
    NG19 7BT Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishPrint Marketing Manager47104490002
    WILLIAMSON, Michael
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    Segretario
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    BritishFinance Director90174630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    THROGMORTON SECRETARIES LIMITED
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    Segretario
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    80839850001
    BALE, Lisa
    39 Forryans Close
    LE18 3LL Wigston
    Leicester
    Amministratore
    39 Forryans Close
    LE18 3LL Wigston
    Leicester
    BritishCustomer Services85214660001
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Amministratore
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    GermanDirector69193840001
    BENISON, Roy
    1 Rooley Avenue
    NG17 2GJ Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    1 Rooley Avenue
    NG17 2GJ Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director10427370001
    BLANEY, Eamonn Mark Anthony
    62 Tanfield Lane
    Rushmere
    NN1 5RN Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    62 Tanfield Lane
    Rushmere
    NN1 5RN Northampton
    Northamptonshire
    BritishBusiness Development Director95634760001
    CANAVAN, Mark
    Orchard Road
    SG4 0BP Hitchin
    45
    Herts
    Amministratore
    Orchard Road
    SG4 0BP Hitchin
    45
    Herts
    United KingdomBritishOperations140755990001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Amministratore
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    EnglandBritishFinancial Director94273950001
    KENDALL, Jonathan Mark
    438 Kedleston Road
    Allestree
    DE22 2TG Derby
    Amministratore
    438 Kedleston Road
    Allestree
    DE22 2TG Derby
    United KingdomBritishAccountant67193040002
    KLEIN, Albert Kenngott
    Ham Common
    Richmond
    TW10 7JB London
    11
    United Kingdom
    Amministratore
    Ham Common
    Richmond
    TW10 7JB London
    11
    United Kingdom
    GermanDirector69826640002
    KROTZ, Reinhard
    Rehmstrasse 14a108 A
    D22299 Hamburg
    Germany
    Amministratore
    Rehmstrasse 14a108 A
    D22299 Hamburg
    Germany
    GermanCompany Director75369160002
    MCHUGH, Andrew James Patric
    116 Chatsworth Drive
    NG18 4QX Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    116 Chatsworth Drive
    NG18 4QX Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director41889610002
    PALMER, Louise
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritishFinance Director119011320002
    PARRY WILLIAMS, Arthur Malcolm
    43 Griceson Close
    Ollerton
    NG22 9BD Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    43 Griceson Close
    Ollerton
    NG22 9BD Newark
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director70561950001
    SMITH, David
    63 Alexandra Avenue
    NG18 5AD Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    63 Alexandra Avenue
    NG18 5AD Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director10427360002
    TOKELOVE, Simon Conway
    2a The Bank
    School Road
    OX12 0LB West Hanney
    Oxfordshire
    Amministratore
    2a The Bank
    School Road
    OX12 0LB West Hanney
    Oxfordshire
    BritishDirector85214540001
    WILLIAMS, Paul
    28 Granby Avenue
    NG19 7BT Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    28 Granby Avenue
    NG19 7BT Mansfield
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector47104490002
    WILLIAMSON, Michael
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    Amministratore
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    BritishFinance Director90174630001
    ZIEGENBEIN, Kristian Axel
    11 Runnymede Road
    Darras Hall
    NE20 9HE Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    11 Runnymede Road
    Darras Hall
    NE20 9HE Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    GermanDirector67297990002

    IMAGELINX UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 13 feb 2012
    Consegnato il 15 feb 2012
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 ago 2013Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 30 lug 2009
    Consegnato il 04 ago 2009
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 04 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 2013Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 lug 2007
    Consegnato il 09 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 09 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 giu 2005
    Consegnato il 27 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 2002
    Consegnato il 08 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as former imagelinx premises at nunnbrook rise huthwaite sutton in ashfield nottinghamshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 07 giu 2001
    Consegnato il 16 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £169,500 due or to become due from the company to the chargee together with a sum equivalent to any value added tax that will be chargeable
    Brevi particolari
    The balance for the time being of the deposit account referred to in the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Sladen Earth Property Ventures (Lowmoor) Limited
    Transazioni
    • 16 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture between the company,drp studios limited and landesbank baden-wurttenberg
    Creato il 07 set 2000
    Consegnato il 25 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to various documents as defined and under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Baden-Wurttenberg
    Transazioni
    • 25 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 ago 1996
    Consegnato il 14 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    IMAGELINX UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 set 2014Inizio della liquidazione
    27 feb 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul M Davis
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Praticante
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Frederick Charles Satow
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Praticante
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0