IMAGELINX UK LIMITED
Panoramica
Nome della società | IMAGELINX UK LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03182772 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IMAGELINX UK LIMITED?
- altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
Dove si trova IMAGELINX UK LIMITED?
Indirizzo della sede legale | New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street EC4V 6BJ London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IMAGELINX UK LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
IMAGE LINX INTERNATIONAL LIMITED | 04 apr 1996 | 04 apr 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IMAGELINX UK LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per IMAGELINX UK LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 18 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2017 | 15 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2016 | 10 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2015 | 14 pagine | 4.68 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 45 Lilyville Road London SW6 5DP a New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street London EC4V 6BJ in data 17 set 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park, Lowmoor Road Kirkby in Ashfield Nottinghamshire NG17 7RB Uk* in data 19 set 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in parte | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 10 in parte | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Louise Palmer come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Canavan come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 11 pagine | MG01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Louise Palmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 apr 2011 | 16 pagine | AR01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 dic 2004
| 2 pagine | SH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IMAGELINX UK LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAE, Alistair Kynoch | Amministratore | 45 Lilyville Road SW6 5DP London | England | British | Director | 53806830002 | ||||
KENDALL, Jonathan Mark | Segretario | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | British | Accountant | 67193040002 | |||||
PALMER, Louise | Segretario | 12 The Pinfold Glapwell S44 5PU Chesterfield Derbyshire | British | 119011320002 | ||||||
WILLIAMS, Paul | Segretario | 28 Granby Avenue NG19 7BT Mansfield Nottinghamshire | British | Print Marketing Manager | 47104490002 | |||||
WILLIAMSON, Michael | Segretario | 222 Sheen Lane East Sheen SW14 8LB London | British | Finance Director | 90174630001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
THROGMORTON SECRETARIES LIMITED | Segretario | 42 Portman Road RG30 1EA Reading Berkshire | 80839850001 | |||||||
BALE, Lisa | Amministratore | 39 Forryans Close LE18 3LL Wigston Leicester | British | Customer Services | 85214660001 | |||||
BANGE, Udo Karl | Amministratore | 28 Linden Gardens W2 4ES London | German | Director | 69193840001 | |||||
BENISON, Roy | Amministratore | 1 Rooley Avenue NG17 2GJ Sutton In Ashfield Nottinghamshire | British | Company Director | 10427370001 | |||||
BLANEY, Eamonn Mark Anthony | Amministratore | 62 Tanfield Lane Rushmere NN1 5RN Northampton Northamptonshire | British | Business Development Director | 95634760001 | |||||
CANAVAN, Mark | Amministratore | Orchard Road SG4 0BP Hitchin 45 Herts | United Kingdom | British | Operations | 140755990001 | ||||
HUNTER, Nicholas James | Amministratore | 1031 Oxford Road RG31 6TL Reading Berkshire | England | British | Financial Director | 94273950001 | ||||
KENDALL, Jonathan Mark | Amministratore | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | United Kingdom | British | Accountant | 67193040002 | ||||
KLEIN, Albert Kenngott | Amministratore | Ham Common Richmond TW10 7JB London 11 United Kingdom | German | Director | 69826640002 | |||||
KROTZ, Reinhard | Amministratore | Rehmstrasse 14a108 A D22299 Hamburg Germany | German | Company Director | 75369160002 | |||||
MCHUGH, Andrew James Patric | Amministratore | 116 Chatsworth Drive NG18 4QX Mansfield Nottinghamshire | British | Company Director | 41889610002 | |||||
PALMER, Louise | Amministratore | 12 The Pinfold Glapwell S44 5PU Chesterfield Derbyshire | United Kingdom | British | Finance Director | 119011320002 | ||||
PARRY WILLIAMS, Arthur Malcolm | Amministratore | 43 Griceson Close Ollerton NG22 9BD Newark Nottinghamshire | British | Company Director | 70561950001 | |||||
SMITH, David | Amministratore | 63 Alexandra Avenue NG18 5AD Mansfield Nottinghamshire | British | Company Director | 10427360002 | |||||
TOKELOVE, Simon Conway | Amministratore | 2a The Bank School Road OX12 0LB West Hanney Oxfordshire | British | Director | 85214540001 | |||||
WILLIAMS, Paul | Amministratore | 28 Granby Avenue NG19 7BT Mansfield Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 47104490002 | ||||
WILLIAMSON, Michael | Amministratore | 222 Sheen Lane East Sheen SW14 8LB London | British | Finance Director | 90174630001 | |||||
ZIEGENBEIN, Kristian Axel | Amministratore | 11 Runnymede Road Darras Hall NE20 9HE Ponteland Newcastle Upon Tyne | German | Director | 67297990002 |
IMAGELINX UK LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 13 feb 2012 Consegnato il 15 feb 2012 | Parzialmente soddisfatta | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
All assets debenture | Creato il 30 lug 2009 Consegnato il 04 ago 2009 | Parzialmente soddisfatta | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 25 lug 2007 Consegnato il 09 ago 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 06 giu 2005 Consegnato il 27 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 17 giu 2004 Consegnato il 22 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 05 nov 2002 Consegnato il 08 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The freehold property known as former imagelinx premises at nunnbrook rise huthwaite sutton in ashfield nottinghamshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 mag 2002 Consegnato il 18 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 07 giu 2001 Consegnato il 16 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £169,500 due or to become due from the company to the chargee together with a sum equivalent to any value added tax that will be chargeable | |
Brevi particolari The balance for the time being of the deposit account referred to in the rent deposit deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture between the company,drp studios limited and landesbank baden-wurttenberg | Creato il 07 set 2000 Consegnato il 25 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to various documents as defined and under this debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 09 ago 1996 Consegnato il 14 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
IMAGELINX UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0