THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED

THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03183931
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Wells Street
    W1A 3AE London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLASSTYPIST LIMITED10 apr 199610 apr 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA England a 55 Wells Street London W1A 3AE in data 09 apr 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione di Richard Stanley Coward come persona con controllo significativo il 15 mar 2018

    1 paginePSC07

    Notifica di Stephen James Faulkner come persona con controllo significativo il 15 mar 2018

    2 paginePSC01

    Cessazione della carica di Richard Stanley Coward come amministratore in data 15 mar 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen James Faulkner come amministratore in data 15 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Dudley Trood come amministratore in data 30 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jane Li come segretario in data 30 nov 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione di Stuart Dudley Trood come persona con controllo significativo il 30 nov 2017

    1 paginePSC07

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 02 giu 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel £15132160 from share prem a/c 11/05/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Andrea Lattimore come amministratore in data 22 ago 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeremy Hamilton Hook come amministratore in data 22 ago 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew James Gunton come amministratore in data 22 ago 2016

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 29 st John's Lane London EC1M 4NA a Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA in data 01 giu 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 apr 2016

    Stato del capitale al 22 apr 2016

    • Capitale: GBP 1,555,840
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Stuart Dudley Trood il 01 lug 2012

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FAULKNER, Stephen James
    Wells Street
    W1A 3AE London
    55
    England
    Amministratore
    Wells Street
    W1A 3AE London
    55
    England
    EnglandIrishCompany Director190049190002
    DELL, Richard Frederick
    12 Corton Road
    NR32 4PL Lowestoft
    Suffolk
    Segretario
    12 Corton Road
    NR32 4PL Lowestoft
    Suffolk
    BritishAccountant74124260001
    DUNCAN, William Grant
    St John's Lane
    EC1M 4NA London
    29
    England
    Segretario
    St John's Lane
    EC1M 4NA London
    29
    England
    BritishLegal Director75956440002
    JEAKINGS, Adrian Dion
    466a Unthank Road
    NR4 7QJ Norwich
    Norfolk
    Segretario
    466a Unthank Road
    NR4 7QJ Norwich
    Norfolk
    BritishDirector63331450001
    LI, Jane
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Company Secretary
    Berkshire
    England
    Segretario
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Company Secretary
    Berkshire
    England
    202676540001
    MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald
    Weavers Mark The Green
    Palgrave
    IP22 1AN Diss
    Norfolk
    Segretario
    Weavers Mark The Green
    Palgrave
    IP22 1AN Diss
    Norfolk
    BritishFinance Director50277810002
    THIAN, Robert Peter
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    Segretario
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    BritishCompany Director41949700001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione817717
    32524900007
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BONNAR, John Niven
    The Red House
    Wyre Lane, Long Marston
    CV37 8RQ Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    The Red House
    Wyre Lane, Long Marston
    CV37 8RQ Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    BritishCompany Director113933000001
    COWARD, Richard Stanley
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Amministratore
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    United KingdomBritishCfo199946190001
    DELL, Richard Frederick
    12 Corton Road
    NR32 4PL Lowestoft
    Suffolk
    Amministratore
    12 Corton Road
    NR32 4PL Lowestoft
    Suffolk
    United KingdomBritishAccountant74124260001
    FIELD, Malcolm, Sir
    15 Eaton Terrace
    SW1W 9DD London
    Amministratore
    15 Eaton Terrace
    SW1W 9DD London
    BritishChairman Caa74857040001
    GUNTON, Andrew James
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Amministratore
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    EnglandBritishDirector201996600001
    HAILSTONE, Timothy Martin
    The White Cottage Ivy Bank
    Swannaton Road
    TQ6 9RL Dartmouth
    Devon
    Amministratore
    The White Cottage Ivy Bank
    Swannaton Road
    TQ6 9RL Dartmouth
    Devon
    United KingdomBritishCompany Director62539790001
    HOOK, Jeremy Hamilton
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Amministratore
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    EnglandBritishDirector80045690001
    JEAKINGS, Adrian Dion
    466a Unthank Road
    NR4 7QJ Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    466a Unthank Road
    NR4 7QJ Norwich
    Norfolk
    UkBritishDirector63331450001
    LATTIMORE, Andrea
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Amministratore
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    EnglandBritishRisk Director190074140001
    MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald
    Weavers Mark The Green
    Palgrave
    IP22 1AN Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Weavers Mark The Green
    Palgrave
    IP22 1AN Diss
    Norfolk
    BritishFinance Director50277810002
    MIDDLETON, Rupert John
    80 Mortimer Road
    N1 5AP London
    Amministratore
    80 Mortimer Road
    N1 5AP London
    United KingdomBritishDirector27908530001
    PARTRIDGE, Michael John Anthony
    27 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    27 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishDirector28205070001
    PENNANT-REA, Rupert Lascelles
    59 Cranmer Court
    Whiteheads Grove
    SW3 3HW London
    Amministratore
    59 Cranmer Court
    Whiteheads Grove
    SW3 3HW London
    UkBritishBusinessman44312900002
    PERKINS, Frederick James
    25 Ham Farm Road
    TW10 5NA Richmond
    Surrey
    Amministratore
    25 Ham Farm Road
    TW10 5NA Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChief Executive27861770001
    PIERLEONI, Marco Alessandro
    St John's Lane
    EC1M 4NA London
    29
    England
    Amministratore
    St John's Lane
    EC1M 4NA London
    29
    England
    EnglandBritishCeo Williams Lea Public Sector133649430001
    PIPER, Paul James
    4 Brindle Gate
    DA15 8BU Sidcup
    Kent
    Amministratore
    4 Brindle Gate
    DA15 8BU Sidcup
    Kent
    BritishDirector63643370001
    SYDER, Timothy Dominic James
    21 Baskerville Road
    SW18 3RW London
    Amministratore
    21 Baskerville Road
    SW18 3RW London
    BritishChartered Accountant2059980002
    THIAN, Robert Peter
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    Amministratore
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    BritishCompany Director41949700001
    TOULSON CLARKE, Christopher Timothy Miles
    Tree Tops
    Great Elm
    BA11 3NZ Frome
    Somerset
    Amministratore
    Tree Tops
    Great Elm
    BA11 3NZ Frome
    Somerset
    United KingdomBritishDirector45455220003
    TROOD, Stuart Dudley
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Amministratore
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer138486040005
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Stephen James Faulkner
    Wells Street
    W1A 3AE London
    55
    England
    15 mar 2018
    Wells Street
    W1A 3AE London
    55
    England
    No
    Nazionalità: Irish
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Richard Stanley Coward
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    10 apr 2017
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Stuart Dudley Trood
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    10 apr 2017
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 lug 2000
    Consegnato il 02 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee by the stationery office holdings limited under the deep discount bond instrument
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Apax Partners & Co. Ventures Limitedas Security Trustee for the Security Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 02 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 lug 2000
    Consegnato il 02 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company and/or any group company to the security benficiaries which is for the time being a party to any security document whether pursuant to the guarantee or otherwise (all as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 set 1999
    Consegnato il 29 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the security beneficiaries (as defined) by any charging company and/or any group company (both as defined) in any manner whatsoever whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transazioni
    • 29 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 16 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness,liabilities and obligations which are as at 1ST april 1999 or may at any time thereafter be due,owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries) and to the security beneficiaries (as defined) by any charging company whether actually or contingently whether pursuant to the guarantee or otherwise,whether solely or jointly with any other person and whether or not the security beneficiaries shall have been an original party to the relevant transaction and in whatever currency denominated including all liabilities in connection with foreign exchange transactions,acceptances,discounting or otherwise or under guarantees,bonds,idemnities,documentary or amy instruments whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 04 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company (as defined) to the chargee whether actually or contingently (but excluding any such indebtedness, liabilities and obligations which would constitute financial assistance, as defined in and prohibited by sections 151, 152 and 154 of the companies act 1985, which has not been given in accordance with sections 155-158 of the companies act 1985 or is not prohibited by section 153 of the companies act 1985), whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Brevi particolari
    1. each charging company charged to the security trustee (for the benefit of the security beneficiaries) by way of first legal mortgage:- 1.1 all its f/h and l/h interest in the properties being, (a) 51 nine elms lane, battersea t/n-sgl 253405. (b) land at willow walk, mandela way, southwark SE1 t/n-sgl 393821. (c) garage at coed-yr-ynn rhiwbina cardiff t/n-wa 651192.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 04 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0