THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03183931 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 55 Wells Street W1A 3AE London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CLASSTYPIST LIMITED | 10 apr 1996 | 10 apr 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA England a 55 Wells Street London W1A 3AE in data 09 apr 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione di Richard Stanley Coward come persona con controllo significativo il 15 mar 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Notifica di Stephen James Faulkner come persona con controllo significativo il 15 mar 2018 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Stanley Coward come amministratore in data 15 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen James Faulkner come amministratore in data 15 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Dudley Trood come amministratore in data 30 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jane Li come segretario in data 30 nov 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione di Stuart Dudley Trood come persona con controllo significativo il 30 nov 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 02 giu 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrea Lattimore come amministratore in data 22 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jeremy Hamilton Hook come amministratore in data 22 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew James Gunton come amministratore in data 22 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 29 st John's Lane London EC1M 4NA a Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA in data 01 giu 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Stuart Dudley Trood il 01 lug 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAULKNER, Stephen James | Amministratore | Wells Street W1A 3AE London 55 England | England | Irish | Company Director | 190049190002 | ||||||||
DELL, Richard Frederick | Segretario | 12 Corton Road NR32 4PL Lowestoft Suffolk | British | Accountant | 74124260001 | |||||||||
DUNCAN, William Grant | Segretario | St John's Lane EC1M 4NA London 29 England | British | Legal Director | 75956440002 | |||||||||
JEAKINGS, Adrian Dion | Segretario | 466a Unthank Road NR4 7QJ Norwich Norfolk | British | Director | 63331450001 | |||||||||
LI, Jane | Segretario | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Company Secretary Berkshire England | 202676540001 | |||||||||||
MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald | Segretario | Weavers Mark The Green Palgrave IP22 1AN Diss Norfolk | British | Finance Director | 50277810002 | |||||||||
THIAN, Robert Peter | Segretario | 15a Princes Gate Mews SW7 2PS London | British | Company Director | 41949700001 | |||||||||
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
BONNAR, John Niven | Amministratore | The Red House Wyre Lane, Long Marston CV37 8RQ Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | Company Director | 113933000001 | |||||||||
COWARD, Richard Stanley | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | United Kingdom | British | Cfo | 199946190001 | ||||||||
DELL, Richard Frederick | Amministratore | 12 Corton Road NR32 4PL Lowestoft Suffolk | United Kingdom | British | Accountant | 74124260001 | ||||||||
FIELD, Malcolm, Sir | Amministratore | 15 Eaton Terrace SW1W 9DD London | British | Chairman Caa | 74857040001 | |||||||||
GUNTON, Andrew James | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | England | British | Director | 201996600001 | ||||||||
HAILSTONE, Timothy Martin | Amministratore | The White Cottage Ivy Bank Swannaton Road TQ6 9RL Dartmouth Devon | United Kingdom | British | Company Director | 62539790001 | ||||||||
HOOK, Jeremy Hamilton | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | England | British | Director | 80045690001 | ||||||||
JEAKINGS, Adrian Dion | Amministratore | 466a Unthank Road NR4 7QJ Norwich Norfolk | Uk | British | Director | 63331450001 | ||||||||
LATTIMORE, Andrea | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | England | British | Risk Director | 190074140001 | ||||||||
MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald | Amministratore | Weavers Mark The Green Palgrave IP22 1AN Diss Norfolk | British | Finance Director | 50277810002 | |||||||||
MIDDLETON, Rupert John | Amministratore | 80 Mortimer Road N1 5AP London | United Kingdom | British | Director | 27908530001 | ||||||||
PARTRIDGE, Michael John Anthony | Amministratore | 27 High View HA5 3NZ Pinner Middlesex | England | British | Director | 28205070001 | ||||||||
PENNANT-REA, Rupert Lascelles | Amministratore | 59 Cranmer Court Whiteheads Grove SW3 3HW London | Uk | British | Businessman | 44312900002 | ||||||||
PERKINS, Frederick James | Amministratore | 25 Ham Farm Road TW10 5NA Richmond Surrey | United Kingdom | British | Chief Executive | 27861770001 | ||||||||
PIERLEONI, Marco Alessandro | Amministratore | St John's Lane EC1M 4NA London 29 England | England | British | Ceo Williams Lea Public Sector | 133649430001 | ||||||||
PIPER, Paul James | Amministratore | 4 Brindle Gate DA15 8BU Sidcup Kent | British | Director | 63643370001 | |||||||||
SYDER, Timothy Dominic James | Amministratore | 21 Baskerville Road SW18 3RW London | British | Chartered Accountant | 2059980002 | |||||||||
THIAN, Robert Peter | Amministratore | 15a Princes Gate Mews SW7 2PS London | British | Company Director | 41949700001 | |||||||||
TOULSON CLARKE, Christopher Timothy Miles | Amministratore | Tree Tops Great Elm BA11 3NZ Frome Somerset | United Kingdom | British | Director | 45455220003 | ||||||||
TROOD, Stuart Dudley | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | England | British | Chief Financial Officer | 138486040005 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Stephen James Faulkner | 15 mar 2018 | Wells Street W1A 3AE London 55 England | No |
Nazionalità: Irish Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
Mr Richard Stanley Coward | 10 apr 2017 | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
Mr Stuart Dudley Trood | 10 apr 2017 | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
|
THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 20 lug 2000 Consegnato il 02 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee by the stationery office holdings limited under the deep discount bond instrument | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 20 lug 2000 Consegnato il 02 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company and/or any group company to the security benficiaries which is for the time being a party to any security document whether pursuant to the guarantee or otherwise (all as defined therein) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 22 set 1999 Consegnato il 29 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due to the security beneficiaries (as defined) by any charging company and/or any group company (both as defined) in any manner whatsoever whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 01 apr 1999 Consegnato il 16 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness,liabilities and obligations which are as at 1ST april 1999 or may at any time thereafter be due,owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries) and to the security beneficiaries (as defined) by any charging company whether actually or contingently whether pursuant to the guarantee or otherwise,whether solely or jointly with any other person and whether or not the security beneficiaries shall have been an original party to the relevant transaction and in whatever currency denominated including all liabilities in connection with foreign exchange transactions,acceptances,discounting or otherwise or under guarantees,bonds,idemnities,documentary or amy instruments whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 04 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company (as defined) to the chargee whether actually or contingently (but excluding any such indebtedness, liabilities and obligations which would constitute financial assistance, as defined in and prohibited by sections 151, 152 and 154 of the companies act 1985, which has not been given in accordance with sections 155-158 of the companies act 1985 or is not prohibited by section 153 of the companies act 1985), whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Brevi particolari 1. each charging company charged to the security trustee (for the benefit of the security beneficiaries) by way of first legal mortgage:- 1.1 all its f/h and l/h interest in the properties being, (a) 51 nine elms lane, battersea t/n-sgl 253405. (b) land at willow walk, mandela way, southwark SE1 t/n-sgl 393821. (c) garage at coed-yr-ynn rhiwbina cardiff t/n-wa 651192.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0