TRINITY CARE HOMES LIMITED

TRINITY CARE HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRINITY CARE HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03184056
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STONEYFORD CHRISTIAN NURSING HOME LIMITED06 set 199606 set 1996
    AYCEECO (140) LIMITED10 apr 199610 apr 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 31 ago 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Charles Lovett come amministratore in data 31 ago 2012

    2 pagineAP01

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 apr 2012

    Stato del capitale al 10 apr 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Nomina di Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Explanatory statment to sole member 14/05/2010
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    17 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di un amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Amministratore
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British84003280001
    LONG, Anne Marguerite Dorothy
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    Segretario
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    British43180700001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158661940001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Amministratore
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    British51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish124228290001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Amministratore
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritish93592160001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish84003280001
    HENDERSON, David Greig
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    Amministratore
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    EnglandBritish6112570002
    HILL, Randolph Paul
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15223790003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    LONG, Anne Marguerite Dorothy
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    Amministratore
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    British43180700001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Amministratore
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    PRESTON, Mary
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    Amministratore
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    United KingdomBritish124068010001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SUFFIELD, Mervyn John, Dr
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    British34214100001
    THORNE, Anthony David
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritish80445640001
    WEARING, John Howard
    56 Rosemary Hill Road
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    56 Rosemary Hill Road
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish46626990001

    TRINITY CARE HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A supplemental debenture
    Creato il 29 ott 1999
    Consegnato il 03 nov 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. 1 Limited
    Transazioni
    • 03 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 apr 1997
    Consegnato il 23 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums payable by the company to the chargee in the event of default (as defined) under the terms of a lease dated 4TH february 1997
    Brevi particolari
    The initial deposit means the sum equivalent to twice the basic rent (as defined) and interest which means all interest credited to the deposit account. Deposit account means an interest bearing deposit account at such bank or institution as the landlord shall from time to time decide.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transazioni
    • 23 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 apr 1997
    Consegnato il 22 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of a default
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee charges the initial deposit,all interest,the deposit account being an interest bearing account specifically designated "deposit account" at such bank or institution as the chargee (landlord) shall from time to time decide in it's absolute discretion and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 feb 1997
    Consegnato il 06 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a chandlers ford christian nursing home winchester road chandlers ford eastleigh hampshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. I PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 nov 1996
    Consegnato il 14 dic 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on l/hold premises at stoneyford nursing home,stoneyford rd,sutton in ashfield,nottinghamshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.I PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 28 nov 1996
    Consegnato il 10 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default
    Brevi particolari
    The deposit as defined on the reverse of the form 395.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. 1 PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TRINITY CARE HOMES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Praticante
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0