CONNAUGHT PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONNAUGHT PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03184319
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CONNAUGHT PLC?

    • (4525) /
    • (7415) /

    Dove si trova CONNAUGHT PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CONNAUGHT PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CONNAUGHT HOLDINGS LIMITED29 mag 199629 mag 1996
    BONDCO 611 LIMITED11 apr 199611 apr 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONNAUGHT PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CONNAUGHT PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    21 pagineWU15

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    20 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    19 pagineWU07

    Avviso di rimozione del liquidatore da parte del tribunale

    10 pagineWU14

    Nomina di un liquidatore

    3 pagineWU04

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:liquidators annual progress report to 24/02/2017
    17 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2016
    14 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2016
    14 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2015
    15 pagineLIQ MISC

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL in data 08 apr 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 feb 2014

    25 pagine2.24B

    Avviso di ordinanza del tribunale che termina l'amministrazione

    1 pagine2.33B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 feb 2014

    25 pagine2.24B

    Avviso di ordinanza del tribunale che termina l'amministrazione

    25 pagine2.33B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 dic 2013

    24 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 dic 2013

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 giu 2013

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 giu 2013

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 giu 2013

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 dic 2012

    22 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 dic 2012

    22 pagine2.24B

    Chi sono gli amministratori di CONNAUGHT PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Segretario
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British140133020001
    HILL, Stephen Ronald
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Amministratore
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish115233060001
    ROSS, Timothy Stuart
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Amministratore
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    EnglandBritish33564830003
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    Segretario
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    British47908530001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Segretario
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    British64426280002
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Segretario
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    British99914770001
    WELLS, David Francis
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    Segretario
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    British104366980002
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Segretario nominato
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005060001
    ALCOCK, Robert Harding
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Amministratore
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish9764400003
    BRANDON, John Robert
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    Amministratore
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    United KingdomBritish99584240001
    DARKIN, Andrew
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    Amministratore
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    United KingdomBritish137575700001
    DAVIES, Mark Dingad
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Amministratore
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    EnglandBritish203044250004
    EVANS, Terence Mervin
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    Amministratore
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    British47913740001
    HENRY, Robert Michael
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    Amministratore
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    United KingdomBritish36661900001
    HENRY, Robert Michael
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    Amministratore
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    United KingdomBritish36661900001
    MCLAUGHLIN, James, Mr.
    Snow Meadow Barn
    Middle Stoughton
    BS28 4PT Wedmore
    Somerset
    Amministratore
    Snow Meadow Barn
    Middle Stoughton
    BS28 4PT Wedmore
    Somerset
    UkBritish107447050001
    MCNAUGHTON, Andrew Robert Paul
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    Amministratore
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    British53282280004
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Amministratore
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    EnglandBritish64426280002
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritish99914770001
    PRICE, Caroline Fiona
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Amministratore
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritish38883480011
    SMITH, Richard David
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    Amministratore
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    British17374050001
    STANDING, Roger
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    Amministratore
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    British47913670001
    TINCKNELL, Mark William
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Amministratore
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    EnglandBritish4088810003
    WELLS, David Francis
    Rosewood House
    Bakers Corner
    SN13 9SY Neston
    Wiltshire
    Amministratore
    Rosewood House
    Bakers Corner
    SN13 9SY Neston
    Wiltshire
    British104366980001
    WILLIAMS, Anthony John
    Foresters Lodge School Lane
    Bawdsey
    IP12 3AR Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Foresters Lodge School Lane
    Bawdsey
    IP12 3AR Woodbridge
    Suffolk
    British81797450001
    BONDLAW DIRECTORS LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Amministratore delegato nominato
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005050001

    CONNAUGHT PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A mortgage of shares agreement
    Creato il 26 nov 2009
    Consegnato il 01 dic 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First equitable mortgage all the shares.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Mortgage of shares agreement
    Creato il 14 nov 2009
    Consegnato il 25 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares including all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Mortgage of shares
    Creato il 14 nov 2009
    Consegnato il 24 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first equitable mortgage all shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 24 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 set 2009
    Consegnato il 21 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    £1,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Bank deposit of £1,000.00.
    Persone aventi diritto
    • Peter Colby Commercials Limited
    Transazioni
    • 21 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage of shares
    Creato il 06 ago 2009
    Consegnato il 25 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Security agreement
    Creato il 06 ago 2009
    Consegnato il 25 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 11 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Shares pledge
    Creato il 06 ago 2009
    Consegnato il 26 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    Each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pledges and assigns to the security trustee its whole right title interest and benefit in and to the charged assets the shares being 100 shares of £1 each in the share capital of the company the dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes
    Transazioni
    • 26 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 10 lug 2009
    Consegnato il 23 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 11 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Share pledge
    Creato il 10 lug 2009
    Consegnato il 28 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its whole right, title interest and benefit in to the charged assets:the charged assets means the shares and all stocks being 100 ordinary shares of £1.00 each see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage of shares
    Creato il 10 lug 2009
    Consegnato il 23 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Scottish shares pledge
    Creato il 10 lug 2009
    Consegnato il 25 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Whole right title and interest in and to the charged assets being the 100 ordinary shares of £1 each in connaught property services (glasgow) limited and the related rights. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage of shares agreement
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 31 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the shares and all interest in the shares including all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Share plegde agreement
    Creato il 21 ago 2007
    Consegnato il 05 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and all stocks,shares,warrants,securitites,rights,money or property,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 05 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    A security agreement
    Creato il 17 ago 2007
    Consegnato il 31 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 11 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    A mortgage of shares agreement
    Creato il 17 ago 2007
    Consegnato il 31 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the shares owned by it (including all related rights). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 dic 2006
    Consegnato il 16 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 set 2006
    Consegnato il 07 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    Charge of £1,000.00 deposit account and other monies due under a lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter Colby Commercials Limited
    Transazioni
    • 07 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 mag 2004
    Consegnato il 20 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Creato il 21 ago 2002
    Consegnato il 24 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such sums together with interest and other amounts accruing on such sums for the time being standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00899263 of the company with the chargee.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Creato il 09 mag 2002
    Consegnato il 10 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such sums together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00245061 of the company together with all the present and future right title and benefit of the company whatsoever in the deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Creato il 28 mar 2002
    Consegnato il 13 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Sums for the time being and from time to time standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00245061. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 dic 2000
    Consegnato il 22 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 10 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 01 lug 1999
    Consegnato il 08 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account desingation 21213201 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 26 giu 1996
    Consegnato il 01 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CONNAUGHT PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 set 2010Inizio dell'amministrazione
    07 mar 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    17 set 2019Conclusione della liquidazione
    05 feb 2014Data della petizione
    25 feb 2014Inizio della liquidazione
    04 mar 2020Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Paul Nicholas Dumbell
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praticante
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0