MAM SERVICES LIMITED

MAM SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMAM SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03188547
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MAM SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MAM SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MAM SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FORAY 921 LIMITED19 apr 199619 apr 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di MAM SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per MAM SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Steven John Holmes come amministratore in data 22 set 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stewart Frank Bradley Baker come amministratore in data 21 set 2017

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 apr 2016

    Stato del capitale al 27 apr 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 set 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    AR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 apr 2015

    Stato del capitale al 22 apr 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di James William O'halleran come amministratore in data 02 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Steven John Holmes come amministratore in data 24 mar 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Carys Damon come segretario in data 23 mar 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Steven John Holmes come segretario in data 23 mar 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 27 set 2014

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2014

    Stato del capitale al 13 mag 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 28 set 2013

    13 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 29 set 2012

    13 pagineAA

    Bilancio redatto al 24 set 2011

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MAM SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAMON, Carys
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    196167280001
    BAKER, Stewart Frank Bradley
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish230753770001
    ALBION, Susan
    7 Brownsfield Road
    WS13 6BT Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    7 Brownsfield Road
    WS13 6BT Lichfield
    Staffordshire
    British80142740001
    HOLMES, Steven John
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    British80455940002
    HYLAND, Matthew William Edward
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    British43019310004
    OLDHAM, Annette
    Edwards Farm Road
    Fradley
    WS13 8NR Lichfield
    29
    Staffordshire
    Segretario
    Edwards Farm Road
    Fradley
    WS13 8NR Lichfield
    29
    Staffordshire
    British135120610001
    PAGE, David
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    British31059170002
    BEER, Brian Leslie
    52 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    52 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    British61154670001
    BOARDLEY, Richard Owen
    13 Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    13 Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish48134520001
    CHILDS, Mervyn Peter
    Riverdale
    Lower High Street
    DE13 9LU Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Riverdale
    Lower High Street
    DE13 9LU Burton On Trent
    Staffordshire
    British4619870002
    CHINN, Neil
    12 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    12 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish61154190002
    DAY, John Michael
    27 Newfield Lane
    S17 3DB Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    27 Newfield Lane
    S17 3DB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish69255730001
    FISHER, Jacqueline
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    British44103090001
    HARRISON, Gerald Edward
    57 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    57 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish47602430001
    HOLMES, Steven John
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish195545010001
    HOYLE, Russell Blackburn
    5 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Amministratore
    5 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    EnglandBritish52822380002
    HYLAND, Matthew William Edward
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    British43019310004
    LANGLEY, Paul
    9 Besbury Close
    Dorridge
    B93 8NT Solihull
    Amministratore
    9 Besbury Close
    Dorridge
    B93 8NT Solihull
    EnglandBritish99802010001
    MASSEY, Timothy John
    Chestnut Cottage Silver Lane
    Marchington
    ST14 8LL Uttoxeter
    Staffordshire
    Amministratore
    Chestnut Cottage Silver Lane
    Marchington
    ST14 8LL Uttoxeter
    Staffordshire
    United KingdomBritish100259370001
    O'HALLERAN, James William
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish103876820003
    PAGE, David
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish31059170002
    SIMON, Christopher Neil
    89 Ella Road
    West Bridgford
    NG2 5GZ Nottingham
    Amministratore
    89 Ella Road
    West Bridgford
    NG2 5GZ Nottingham
    EnglandBritish95528490001
    SMITH, Keith Ian
    Wythtree
    Manor Park
    DE13 7JA Kings Bromley
    Staffordshire
    Amministratore
    Wythtree
    Manor Park
    DE13 7JA Kings Bromley
    Staffordshire
    United KingdomBritish40284060002
    WITHERS, Roger Dean
    Ivy Cottage The Green
    Dinton
    HP17 8UP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ivy Cottage The Green
    Dinton
    HP17 8UP Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish29586130001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MAM SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Inspired Gaming (Uk) Limited
    The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton-On-Trent
    3
    Staffordshire
    England
    06 apr 2016
    The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton-On-Trent
    3
    Staffordshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleThe Companies Act 1985 To 1989
    Luogo di registrazioneUk Register Of Private Limited Companies
    Numero di registrazione03565640
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MAM SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession and charge
    Creato il 08 lug 2010
    Consegnato il 20 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its rights title and interest from time to time in respect of any sums payable to it pursuant to the insurance policies, the hedging agreements and any structural intra-group loans see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An accession deed
    Creato il 02 giu 2006
    Consegnato il 12 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Corporate Finance Bank Sas, London Branch (The Security Agent)
    Transazioni
    • 12 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 feb 2005
    Consegnato il 11 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Structured Finance Group Limited 'Security Agent'
    Transazioni
    • 11 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 gen 2005
    Consegnato il 11 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Duke Street Capital Iii Limited (The Security Trustee)on Trust for Itself and the Other Vendors
    Transazioni
    • 11 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture between the company and leisure link group limited and others (as defined) (together known as the "security parties" and individually known as "security party") and duke street capital iii limited (the "security trustee")
    Creato il 21 set 2001
    Consegnato il 05 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company to the security trustee in accordance with the vendor loan notes and all obligations and liabilities owing or incurred by the company and each other guaranteed obligor (as defined) to the vendors or any of them under or pursuant to the vendor loan notes and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Maygay house showell road wolverhampton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Duke Street Capital Iii Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture between dmwsl 345 limited (the "parent") and leisure link group and certain other subsidiaries of the parent (as defined), including the company as a security party and nib capital bank N.V. ("nib") as security trustee on behalf of itself and the banks and financial institutions from time to time parties to the finance documents
    Creato il 21 set 2001
    Consegnato il 03 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company under or pursuant to various documents, letters and agreements (as defined) and all other provisions under this debenture
    Brevi particolari
    Including the leasehold property known as maygay house,showell rd,wolverhampton; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 03 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed")
    Creato il 26 mar 1999
    Consegnato il 10 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Brevi particolari
    L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)(the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 10 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 ago 1998
    Consegnato il 20 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0