THE RECRUITMENT GROUP LIMITED

THE RECRUITMENT GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE RECRUITMENT GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03189412
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE RECRUITMENT GROUP LIMITED?

    • Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova THE RECRUITMENT GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE RECRUITMENT GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WORKFORCE SOLUTIONS LIMITED21 set 200321 set 2003
    QUALITY NURSING CARE LIMITED23 apr 199623 apr 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE RECRUITMENT GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THE RECRUITMENT GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per THE RECRUITMENT GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 29 set 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Nomina di Mr Darren Mee come amministratore in data 20 apr 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 apr 2015

    Stato del capitale al 16 apr 2015

    • Capitale: GBP 250,431
    SH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 04 dic 2014

    • Capitale: GBP 250,431
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    That the sum of £250421 being the amount standing to the credit of the profit and loss account of the company be capitalised 04/12/2014
    RES13

    Cessazione della carica di Andrew Jeremy Burchall come amministratore in data 31 lug 2014

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Julia Robertson il 30 giu 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Julia Robertson come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 27 dic 2013

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 apr 2014

    Stato del capitale al 02 apr 2014

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Philip Marsh il 23 mag 2013

    2 pagineCH01

    Iscrizione dell'ipoteca 031894120010

    85 pagineMR01

    Bilancio redatto al 28 dic 2012

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    legacy

    24 pagineMG01

    legacy

    15 pagineMG01

    legacy

    15 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di THE RECRUITMENT GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    British70686070002
    MARSH, Nigel Philip
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    EnglandBritish122764170004
    MEE, Darren
    The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    800
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    800
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish197107770001
    ROBERTSON, Julia
    The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    800
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    800
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish177421710002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish70686070002
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Segretario
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    British26433460001
    CORNISH, Diana Frederica
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    British6048720001
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Segretario
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    British64640450003
    CORPORATE ADMINISTRATION SECRETARIES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    38561470001
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Amministratore
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    British26433460001
    BRAILEY, Geoffrey Ian
    Oakfields Theobalds Road
    RH15 0SS Burgess Hill
    East Sussex
    Amministratore
    Oakfields Theobalds Road
    RH15 0SS Burgess Hill
    East Sussex
    British10317690002
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish69904570002
    CORNISH, Diana Frederica
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6048720001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Amministratore
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritish266121440001
    EDEN, Roger Charles
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish41649520001
    LAKE, David Anthony
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Amministratore
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    EnglandBritish59820940001
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Amministratore
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    United KingdomBritish64640450003
    ROWLEY, John
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    Amministratore
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    EnglandBritish11900790002
    SARSON, Michael Robert
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish27419330001
    THOMPSON, Diana Lesley
    17 Tuffnells Way
    AL5 3HJ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Tuffnells Way
    AL5 3HJ Harpenden
    Hertfordshire
    British48791190001
    CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    78572090001

    THE RECRUITMENT GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 06 mar 2014
    Consegnato il 11 mar 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 26 feb 2013
    Consegnato il 28 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 23 ago 2012
    Consegnato il 28 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 08 ago 2012
    Consegnato il 14 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 mag 2008
    Consegnato il 17 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 apr 2007
    Consegnato il 12 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (jointly and severally with each security obligor) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 apr 2004
    Consegnato il 12 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee (whether for its own account or as agent or trustee for the finance parties) or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor charges all the mortgaged property all real property the mortgaged property being the freehold property 39 ardwick green north manchester t/n GM654955, l/h property brierley hill shaw house wychbury court two woods lane dudley & l/h property being newcastle suite 2 gunner house by way of fixed charge its insurances its intellectual property rights any beneficial interest claim or entitlement it may have in any pension fund its uncalled capital by way of floating charge all present and future assets property business undertaking and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 12 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 ago 2000
    Consegnato il 20 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities owing by any obligor to the chargee under any of the finance documents whether a). Present or future b). Actual or contingent or c). Owed solely, jointly or severally
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Llc the ("Security Trustee" and "Security Bene Ficiary") and Gmac Commercial Credit Development Limited ("Gmac UK") ("Security Beneficiary")
    Transazioni
    • 20 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 mag 1999
    Consegnato il 20 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 giu 1996
    Consegnato il 28 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0