LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED

LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03190147
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Quadrant House Floor 6
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACRE 105 LIMITED29 mar 199629 mar 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2022

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Alan Pearlman il 18 lug 2022

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2021

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2020

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Gulam Mohamed Patel come amministratore in data 30 giu 2021

    1 pagineTM01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2019

    16 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2018

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Howard Alan Pearlman come amministratore in data 08 ago 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOLDBERGER, Michael Robert
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    Segretario
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    British77295560002
    GOLDBERGER, Michael Robert
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    Amministratore
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director77295560002
    PEARLMAN, David Alan
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House Floor 6
    Amministratore
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House Floor 6
    United KingdomBritishCompany Director35550120033
    PEARLMAN, Howard Alan
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House Floor 6
    Amministratore
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House Floor 6
    United KingdomBritishProperty Management93460740002
    COLVIN, Patrick
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    Segretario
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    British5954030001
    CRICKMORE, Nicola Jane
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    Segretario
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    BritishChartered Accountant115328860001
    HARRIS, Jason Mark
    3 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    3 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    British42831090001
    MONJACK, Philip
    Whytes Cottage 14 The Warren
    WD7 7DX Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    Whytes Cottage 14 The Warren
    WD7 7DX Radlett
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant48844070001
    MONJACK, Richard Wayne
    14 Richards Close
    Bushey
    WD2 3JB Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    14 Richards Close
    Bushey
    WD2 3JB Watford
    Hertfordshire
    BritishEstate Agent27762620001
    LAWSON (LONDON) LIMITED
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER
    London
    Segretario nominato
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER
    London
    900000960001
    CARLTON PORTER, Robert William
    4 Laggan House
    College Road
    BA1 5RY Bath
    Avon
    Amministratore
    4 Laggan House
    College Road
    BA1 5RY Bath
    Avon
    United KingdomBritishDirector67566540006
    CLAYDON, Katherine Maria
    74 Hecham Close
    E17 5QT Walthamstow
    London
    Amministratore delegato nominato
    74 Hecham Close
    E17 5QT Walthamstow
    London
    British900012160001
    COLVIN, Patrick
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    Amministratore
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    EnglandBritishCompany Director5954030001
    CRICKMORE, Nicola Jane
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    Amministratore
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant115328860001
    GADSDEN, Eric John Spencer
    Hawridge Place
    Hawridge
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hawridge Place
    Hawridge
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishBuilder & Property Developer13515270003
    GOLDBERG, Jonathan David
    Queenwood
    29 Adelaide Close
    HA7 3EN Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    Queenwood
    29 Adelaide Close
    HA7 3EN Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director33727110001
    HARRIS, Howard
    1 Oaklands Road
    Totteridge
    N20 8BD London
    Amministratore
    1 Oaklands Road
    Totteridge
    N20 8BD London
    BritishCompany Director8500550001
    HARRIS, Jason Mark
    3 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    3 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director42831090001
    LEWIN, Peter Harry
    1 Wolsey Road
    Moor Park
    HA6 2HN Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    1 Wolsey Road
    Moor Park
    HA6 2HN Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Surveyor2652710001
    MONJACK, Philip
    Whytes Cottage 14 The Warren
    WD7 7DX Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Whytes Cottage 14 The Warren
    WD7 7DX Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant48844070001
    MONJACK, Richard Wayne
    14 Richards Close
    Bushey
    WD2 3JB Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 Richards Close
    Bushey
    WD2 3JB Watford
    Hertfordshire
    BritishEstate Agent27762620001
    PATEL, Gulam Mohamed
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House Floor 6
    Amministratore
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House Floor 6
    BritishChartered Accountant85027050001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    06 apr 2016
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3281738
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 giu 2012
    Consegnato il 19 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    14 and 16 station road letchworth t/no HD330233 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 31 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of rectification to debenture dated 9 may 2007 and
    Creato il 03 apr 2008
    Consegnato il 22 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Agency Services Number One Limited
    Transazioni
    • 22 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 mag 2007
    Consegnato il 19 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    14 and 16 station road letchworth hertfordshire t/no: HD330233. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Agency Services Number One Limited
    Transazioni
    • 19 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 09 mag 2007
    Consegnato il 19 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Agency Services Number One Limited
    Transazioni
    • 19 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 apr 2000
    Consegnato il 20 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 14 and 16 station road,letchworth,hertfordshire.t/no.HD330233.all fixtures and fittings whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached thereto and together with the goodwill of any trade or business carried on now or hereafter at the property by the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Britannia Building Society
    Transazioni
    • 20 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 ago 1997
    Consegnato il 04 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H land and premises k/a 14 and 16 station road letchworth t/n HD330233 and all fixtures fittings plant machinery apparatus goods and materials, all right title and interest in all rental income in respect of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 04 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 ago 1997
    Consegnato il 04 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First floating charge undertaking and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 04 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0