RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED

RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 03192673
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RUSKIN MILL EDUCATIONAL TRUST LIMITED30 apr 199630 apr 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ago 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mag 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al30 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al30 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dettagli del direttore cambiati per Professor Alison Margaret Braithwaite Brown il 03 apr 2025

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Angus Wilson Taylor il 03 apr 2025

    2 pagineCH01

    legacy

    pagineANNOTATION

    Iscrizione dell'ipoteca 031926730071, creata il 26 nov 2024

    49 pagineMR01

    Nomina di Mr Mattias Emous come amministratore in data 01 set 2024

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 031926730070, creata il 04 lug 2024

    13 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 031926730069, creata il 04 lug 2024

    13 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 031926730068, creata il 05 lug 2024

    13 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2023

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 apr 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 031926730067, creata il 28 nov 2023

    50 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 031926730066, creata il 25 lug 2023

    33 pagineMR01

    Cessazione della carica di Matthew Hayes come amministratore in data 06 lug 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 031926730065, creata il 11 nov 2022

    50 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2022

    2 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2022 al 31 ago 2022

    1 pagineAA01

    Iscrizione dell'ipoteca 031926730064, creata il 15 set 2022

    50 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Lloyd-Davies il 18 nov 2021

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2020

    2 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 031926730057 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 031926730063, creata il 18 nov 2020

    51 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITBREAD, Antonia
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Segretario
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    249068490001
    BROWN, Alison Margaret Braithwaite, Professor
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    EnglandBritishConsultant Town Planner94340270002
    EMOUS, Mattias
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    EnglandDutchLand Manager326949100001
    GEIDER, Stefan, Dr
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    ScotlandBritishMedical Doctor246094330001
    GORDON, Aonghus Coinn Huntly
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    United KingdomBritishSocial Entrepreneur138224340001
    LLOYD-DAVIES, Robert Justin
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    EnglandBritishConsultant1480870001
    TAYLOR, Angus Wilson
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Surveyor167304520002
    CHRISTLEY, Janine
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Segretario
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    BritishPa79053170004
    CLEMENTS, Ian Keith
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Segretario
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    223645270001
    GORDON, Aonghus Coinn Huntly
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Ruskin Mill
    Gloucestershire
    Segretario
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Ruskin Mill
    Gloucestershire
    BritishCourse Director138224340001
    HARRINGTON, Katherine
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Segretario
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    189749500001
    HOBBS, Rhiannon
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Segretario
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    193875600001
    TROY, Colin Michael
    Old Coach House Hood Manor
    Dartington
    TQ9 6AB Totnes
    Devon
    Segretario
    Old Coach House Hood Manor
    Dartington
    TQ9 6AB Totnes
    Devon
    BritishTeacher48975450001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    AGULNIK, Elisabeth Jean
    Hill House
    Burgage Lane
    NG25 0GR Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Hill House
    Burgage Lane
    NG25 0GR Southwell
    Nottinghamshire
    BritishRetired126081990001
    BALL, Sedhar Chozam, Lady
    Beech Croft Road
    OX2 7AY Oxford
    11
    United Kingdom
    Amministratore
    Beech Croft Road
    OX2 7AY Oxford
    11
    United Kingdom
    United KingdomBritishActress149169940001
    BOOTH, Sheila
    45 Bisley Old Road
    GL5 1LU Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    45 Bisley Old Road
    GL5 1LU Stroud
    Gloucestershire
    BritishRetired48975490001
    CHENEY, Oliver
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    EnglandBritishCollege Principal189749660001
    HAYES, Matthew
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    HungaryBritishMarket Gardner252672690001
    HOCKING, Raymond
    Old Bath Road
    Sonning
    RG4 6TQ Reading
    Birchley
    England
    Amministratore
    Old Bath Road
    Sonning
    RG4 6TQ Reading
    Birchley
    England
    United KingdomBritishAccountant111558500001
    KING, Aubrey Peter
    43 Hamilton Road
    Summer Town
    OX2 7PY Oxford
    Amministratore
    43 Hamilton Road
    Summer Town
    OX2 7PY Oxford
    EnglandBritishArchitect74799080001
    MILNE, Reginald Edward
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector4579080011
    MILNE, Reginald Edward
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director4579080011
    MILNE, Reginald Edward
    5-7 Stert Street
    OX14 3JL Abingdon On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    5-7 Stert Street
    OX14 3JL Abingdon On Thames
    Oxfordshire
    EnglandEnglishCompany Director4579080007
    PAULI, Roger Hamer
    Stourton Farm House
    Greensforge Lane
    DY7 5BD Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Greensforge Lane
    DY7 5BD Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director3264700001
    PLACE, Brian
    Dian Point
    St Johns
    P O 1235 Antigua
    West Indies
    Amministratore
    Dian Point
    St Johns
    P O 1235 Antigua
    West Indies
    BritishAccountant48975670001
    TROY, Colin Michael
    Old Coach House Hood Manor
    Dartington
    TQ9 6AB Totnes
    Devon
    Amministratore
    Old Coach House Hood Manor
    Dartington
    TQ9 6AB Totnes
    Devon
    BritishTeacher48975450001
    VAN DE VOORT, Tyll Hans Wybo
    Milton Street
    DL2 4ET Darlington
    48
    Country Durham
    Amministratore
    Milton Street
    DL2 4ET Darlington
    48
    Country Durham
    United KingdomDutchManager119145630002
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Professor Alison Margaret Braithwaite Brown
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    06 apr 2016
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Aonghus Coinn Huntly Gordon
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    06 apr 2016
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Oliver Cheney
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    06 apr 2016
    Ruskin Mill
    Old Bristol Road
    GL6 0LA Nailsworth
    Gloucestershire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    18 gen 2018La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    RUSKIN MILL LAND TRUST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 nov 2024
    Consegnato il 27 nov 2024
    In corso
    Breve descrizione
    All that freehold property known as kingdom hall, llannon road, pontyberem, llanelli SA15 5LY registered at the hm land registry under WA698030.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 lug 2024
    Consegnato il 05 lug 2024
    In corso
    Breve descrizione
    All and whole subjects 4 baxtersyke, gifford, haddington, EH41 4PL registered in the land register. Of scotland under title number ELN18906.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 lug 2024
    Consegnato il 16 lug 2024
    In corso
    Breve descrizione
    All and whole the subjects 4 baxtersyke, gifford, haddington, EH41 4PL registered in the land register of scotland under title number ELN18906.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 lug 2024
    Consegnato il 10 lug 2024
    In corso
    Breve descrizione
    All and whole subjects at 4 baxtersyke, gifford, haddington, EH41 4PL registered in the land register of scotland under title number ELN18906.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 28 nov 2023
    Consegnato il 04 dic 2023
    In corso
    Breve descrizione
    All that freehold property known as 253 canford lane, westbury-on-try, BS9 3PF and land lying to the north of canford lane, westbury-on-try registered at hm land registry under title numbers AV120625 and AV63566.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 2023Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 25 lug 2023
    Consegnato il 26 lug 2023
    In corso
    Breve descrizione
    Part of the property made up of the main school and car park at sunfield children's home, clent grove, stourbridge shown on the attached plan as the land coloured yellow and the easement represented by the green stripped line.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Tridos Bank Nv
    Transazioni
    • 26 lug 2023Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 11 nov 2022
    Consegnato il 14 nov 2022
    In corso
    Breve descrizione
    All that freehold property known as 7 wollaston road, wollaston, stourbridge registered at hm land registry under title number WM298203.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 nov 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 set 2022
    Consegnato il 20 set 2022
    In corso
    Breve descrizione
    7 brook street wordsley stourbridge DY8 5YW.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 18 nov 2020
    Consegnato il 23 nov 2020
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold land known as 43-49 (odd) vittoria street and 1-7 (odd) regent place B1 3PE and registered at the land registry under title number WM176191 and the freehold land known as highbury, the headlands, selsley road, woodchester, stroud GL5 5PS and registered at the land registry under title number GR239274.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 nov 2020
    Consegnato il 10 nov 2020
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold property known as cherry orchards, canford lane, bristol BS9 3PE (the. Property) under the land registry title numbers AV47O32 and AV1 87049.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Triodos Bank UK Limited
    Transazioni
    • 10 nov 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 19 set 2019
    Consegnato il 20 set 2019
    In corso
    Breve descrizione
    127 high street. Amblecote. Stourbridge. DY8 4DA.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 lug 2018
    Consegnato il 18 lug 2018
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold property at 2A meadow bank road sheffield S11 9AH registered at hm land registry with title number SYK34276.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Tintagel House (Sheffield) Limited
    Transazioni
    • 18 lug 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 29 mag 2018
    Consegnato il 31 mag 2018
    In corso
    Breve descrizione
    The property known as 9 regent place, birmingham, B1 3NJ registered at hm land registry with title numbers WM466719 and WM841826.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 gen 2018
    Consegnato il 15 gen 2018
    In corso
    Breve descrizione
    F/H k/a the new standard works 43-49 (odd) vittoria street and 1-7 (odd) regent place birmingham WM176191.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the National Heritage Memorial Fund
    Transazioni
    • 15 gen 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 29 set 2016
    Consegnato il 30 set 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All that freehold property known as the old refectory, middle street, stroud, glos GL5 1TH registered at the land registry under title number GR322294; all that freehold property known as highbury, the headlands, selsey road, woodchester, stroud, glos GL5 5PS registered at the land registry under title number GR239274 and all that freehold property known as 43-49 (odd) vittoria street & 1-7 (odd) regent place registered at the land registry under title number WM176191.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2015
    Consegnato il 30 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H 2 durban villas bath road nailsworth gloucestershire t/no GR234484.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deep River Ventures, Llc
    Transazioni
    • 30 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2015
    Consegnato il 30 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H highbury the headlands woodchester gloucestershire t/no GR239274.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deep River Ventures, Llc
    Transazioni
    • 30 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2015
    Consegnato il 30 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H pool cottage tiltups end nailsworth gloucestershire t/no GR174395.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deep River Ventures, Llc
    Transazioni
    • 30 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2015
    Consegnato il 30 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H 43-49 (odd) vittoria street and 1-7 (odd) regent place (new standard works, birmingham) t/no WM176191.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deep River Ventures, Llc
    Transazioni
    • 30 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2015
    Consegnato il 30 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    By way of first legal mortgage the property known as standard works, 43-47 vittoria street, birmingham B1 3PE registered at the land registry under title number WM176191.. For more details please refer to the charging instrument.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Triodos Bank Nv
    Transazioni
    • 30 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 nov 2015
    Consegnato il 12 dic 2015
    In corso
    Breve descrizione
    Land lying to the north west of monk road farm monk end croft on tees title no NYK34676, NYK378542 & DU331640. 38 goniscliffe road darlington title no DU68277. Land at monk end farm title no NYK368732.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Triodos Bank Nv
    Transazioni
    • 12 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 23 ott 2015
    Consegnato il 30 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Standard works vittoria street bimingham title no WM176191.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 gen 2014
    Consegnato il 05 feb 2014
    In corso
    Breve descrizione
    T/No: SF259802. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • The Borough Council of Dudley
    Transazioni
    • 05 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 set 2013
    Consegnato il 06 set 2013
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold property known as the land and buildings at the junction of wollaston road and high street, amblecote, stourbridge, west midlands, DY8 4HF including the glasshouse registered with title number WM596654.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the National Heritage Memorial Fund
    Transazioni
    • 06 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Mortgage deed to secure liabilities of charity trustees
    Creato il 31 dic 2012
    Consegnato il 19 gen 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 2 millbottom nailsworth stroud gloucestershire t/no GR268903 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0