JAMJAR CARS LIMITED
Panoramica
Nome della società | JAMJAR CARS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03202757 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di JAMJAR CARS LIMITED?
- (5010) /
Dove si trova JAMJAR CARS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 3 Princess Way Redhill RH1 1NP Surrey |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di JAMJAR CARS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
JAMJAR.COM LIMITED | 07 lug 2000 | 07 lug 2000 |
DIRECT LINE E-COMMERCE LIMITED | 23 feb 2000 | 23 feb 2000 |
DIRECT LINE MONITORING SERVICES LIMITED | 23 mag 1996 | 23 mag 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di JAMJAR CARS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per JAMJAR CARS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Dominic Recaldin il 01 ago 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Stato del capitale al 13 lug 2011
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Yvonne Wood come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Angela Cunningham come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Houlston come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 29 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 29 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2006 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Chi sono gli amministratori di JAMJAR CARS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD, Yvonne | Segretario | EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 160495060001 | |||||||
BALDOCK, Alexander David | Amministratore | Westbourne Park Road W11 1EP London 218 United Kingdom | United Kingdom | British | Bank Official | 132330380001 | ||||
CLIBBENS, Nigel Timothy John | Amministratore | 40a Pennington Road Southborough TN4 0SL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 49141230004 | ||||
RECALDIN, Simon Dominic | Amministratore | Princess Way RH1 1NP Redhill 3 Surrey England | England | British | Senior Manager | 90574780001 | ||||
ATKINSON, Peter Jeremy | Segretario | 52 Kingswood Road KT20 5EQ Tadworth Surrey | British | 7448640002 | ||||||
ATKINSON, Peter Jeremy | Segretario | 52 Kingswood Road KT20 5EQ Tadworth Surrey | British | 7448640002 | ||||||
CUNNINGHAM, Angela Mary | Segretario | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||
LEWIS, Derek John | Segretario | 48 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | British | 34423910002 | ||||||
TATE, Lisa Helen | Segretario | 54a Meadow Walk KT17 2ED Epsom Surrey | British | 68744700001 | ||||||
ATKINSON, Peter Jeremy | Amministratore | 52 Kingswood Road KT20 5EQ Tadworth Surrey | British | Chartered Secretary | 7448640002 | |||||
BAILEY, Robert Andrew | Amministratore | Bechers Withybed Lane WR7 4JJ Inkberrow Worcestershire | United Kingdom | British | Banker | 104106520002 | ||||
BOOTH, Thomas John | Amministratore | Rose Farmhouse Seaton Ross YO42 4LZ York | British | Managing Director | 104299390001 | |||||
CASTLE, Stephen Victor | Amministratore | Lunghurst Place Lunghurst Road, CR3 7EJ Woldingham Surrey | United Kingdom | United Kingdom | Chartered Accountant | 50415920003 | ||||
CHIPPENDALE, Ian Hugh | Amministratore | Flat 8, St Nicholas House 4 Park Hill Road CR0 5NA Croydon Surrey | British | Chief Executive | 10033650004 | |||||
CLARKE, Stephen Andrew | Amministratore | 6 Esmond Road Chiswick W4 1JQ London | England | British | Chartered Accountant | 42862450003 | ||||
COURT, Annette Elizabeth | Amministratore | 33 Sherwood Court Chatfield Road SW11 3UY London | British | Managing Director | 125730500001 | |||||
DICKSON, Jane | Amministratore | Winscombe Cottage Old Farleigh Road CR6 9PE Warlingham Surrey | British | Solicitor | 1307630001 | |||||
DIXON, Simon Timothy | Amministratore | Main Street Hotham YO43 4UF York St Oswaleds House North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 101291990002 | ||||
FLAHERTY, Michael Patrick | Amministratore | 6 Mitchells Place Dulwich SE21 7JZ London | British | Company Director | 60933840002 | |||||
FLINT, Eoin Arthur Mcmorran | Amministratore | Manor Farm Main Street Levisham YO18 7NL Pickering North Yorkshire | British | Company Director | 87299340002 | |||||
HAISMAN, Keith | Amministratore | The Brick House Hermitage Meadow CO10 8QQ Clare Suffolk | England | British | Banker | 150598270001 | ||||
HOULSTON, Stuart | Amministratore | Hastings Pool Poolbrook Road WR14 3QL Barnards Green Quantock Grange Worcestershire | British | Bank Official | 137490170001 | |||||
LYNAM, Paul Anthony | Amministratore | 24 Warwick Road RG2 7AX Reading Berkshire | United Kingdom | Irish | Managing Director | 100755360001 | ||||
PARKINSON, Alan Donald | Amministratore | 8 Pinchwell View Wickersley S66 1FP Rotherham South Yorkshire | England | British | Banker | 104435050001 | ||||
PRILL, Oliver Rainer Andreas | Amministratore | Flat 4 4 Draycott Place SW3 2SB London | German And Dutch | Managing Director | 68744540002 | |||||
RAMANATHAN, Shankar | Amministratore | Mowson Hollow Worrall S35 0AD Sheffield 3 South Yorkshire | England | British | Banker | 125663610001 | ||||
SPICKNELL, Mark Andrew | Amministratore | 88 Oakland Road DA6 7AL Bexleyheath Kent | England | British | Banker | 104107710001 | ||||
STANWORTH, Mark | Amministratore | 45 Park Avenue Shelley HD8 8JY Huddersfield | England | British | Chartered Accountant | 67885350001 | ||||
STUART, John David | Amministratore | 69 Howards Thicket SL9 7NU Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Director | 76974710001 | |||||
WALLACE, James William | Amministratore | Laund Head Farm Noggarth Road Roughlee BB12 9PR Burnley Lancashire | United Kingdom | British | Marketing Director | 40471730001 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0