TRANSOFT SOFTWARE LIMITED

TRANSOFT SOFTWARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRANSOFT SOFTWARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03203472
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRANSOFT SOFTWARE LIMITED?

    • (7260) /

    Dove si trova TRANSOFT SOFTWARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRANSOFT SOFTWARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLACK BOX IT LIMITED09 ott 200009 ott 2000
    PATHFINDER TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED12 lug 200012 lug 2000
    RE-ENGINEERING MAINTENANCE CONVERSIONS LIMITED24 giu 199624 giu 1996
    EXCALIBUR RE-ENGINEERING LIMITED24 mag 199624 mag 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRANSOFT SOFTWARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per TRANSOFT SOFTWARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Cornwall Street Birmingham West Midlands B3 2DL in data 22 dic 2009

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Barbara Firth come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2009

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom in data 18 ott 2009

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 set 2009

    LRESSP

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    9 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    14 pagine395

    Risoluzioni

    Resolutions
    30 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    11 pagine155(6)a

    legacy

    11 pagine155(6)a

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreements 25/09/07
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07

    Chi sono gli amministratori di TRANSOFT SOFTWARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBERTS, Neal Anthony
    Little Aston Park Road
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    Rivendell
    West Midlands
    Segretario
    Little Aston Park Road
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    Rivendell
    West Midlands
    British140194900001
    LEUW, Martin Philip
    29 Deansway
    N2 0NF London
    Amministratore
    29 Deansway
    N2 0NF London
    United KingdomBritishCompany Director4229530001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector12470210003
    BAKER, Geoffrey St George
    6 Sheridan Place
    TW12 2SB Hampton
    Middlesex
    Segretario
    6 Sheridan Place
    TW12 2SB Hampton
    Middlesex
    BritishDevelopment Director12812660001
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    BritishCompany Secretary123713140001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Segretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    BritishAccountant73934790001
    GRIX, Jonathan Philip
    Woodside
    Wood Lane, Beech Hill
    RG7 2BE Reading
    Berkshire
    Segretario
    Woodside
    Wood Lane, Beech Hill
    RG7 2BE Reading
    Berkshire
    BritishCh Accountant65382720001
    KEENE, Charles John
    16 Alyth Road
    BH3 7DF Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    16 Alyth Road
    BH3 7DF Bournemouth
    Dorset
    BritishAccountant60207820004
    RADCLIFFE, Richard Marcus Callister
    Park View
    Melbourne Road, Staunton Harold
    LE65 1RU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Segretario
    Park View
    Melbourne Road, Staunton Harold
    LE65 1RU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishAccountant64587890001
    SCF SECRETARIES LIMITED LIABILITY COMPANY
    American National Bank Building
    1912 Capital Avenue
    82001 Cheyenne
    Wyoming
    Usa
    Segretario nominato
    American National Bank Building
    1912 Capital Avenue
    82001 Cheyenne
    Wyoming
    Usa
    900010880001
    BAKER, Geoffrey St George
    6 Sheridan Place
    TW12 2SB Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    6 Sheridan Place
    TW12 2SB Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritishDevelopment Director12812660001
    BARCHAM, David Edward
    81 Linden Park
    SP7 8RN Shaftesbury
    Dorset
    Amministratore
    81 Linden Park
    SP7 8RN Shaftesbury
    Dorset
    BritishCompany Director42363880002
    CRABB, Neil David
    Flat 5/9 Gullivers Wharf
    105 Wapping Lane
    E1W 2RR London
    Amministratore
    Flat 5/9 Gullivers Wharf
    105 Wapping Lane
    E1W 2RR London
    United KingdomBritishCompany Director51051120002
    EDWARDS, Michael Geoffrey
    Samovar West End Lane
    Stoke Poges
    SL2 4NA Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Samovar West End Lane
    Stoke Poges
    SL2 4NA Slough
    Berkshire
    BritishManaging Director12812680001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritishAccountant73934790001
    GOODE, David Ian
    St. Saviours Lodge
    Holdenhurst Avenue
    BH7 6RB Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    St. Saviours Lodge
    Holdenhurst Avenue
    BH7 6RB Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director69096450002
    GRIX, Jonathan Philip
    Woodside
    Wood Lane, Beech Hill
    RG7 2BE Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Woodside
    Wood Lane, Beech Hill
    RG7 2BE Reading
    Berkshire
    BritishCh Accountant65382720001
    KEENE, Charles John
    16 Alyth Road
    BH3 7DF Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    16 Alyth Road
    BH3 7DF Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritishAccountant60207820004
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishPartner57998050002
    O'CONNOR, Andrew Desmond
    18 Maultway Crescent
    GU15 1PN Camberley
    Surrey
    Amministratore
    18 Maultway Crescent
    GU15 1PN Camberley
    Surrey
    BritishCommercial Manager42363960001
    RADCLIFFE, Richard Marcus Callister
    Park View
    Melbourne Road, Staunton Harold
    LE65 1RU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    Park View
    Melbourne Road, Staunton Harold
    LE65 1RU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishAccountant64587890001
    REDFERN, Allan
    31 Park Lane
    CW12 3DG Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    31 Park Lane
    CW12 3DG Congleton
    Cheshire
    BritishBusiness Manager48489040001
    RICHARDS, Jonathan Mark
    Wyck Barn
    Wyck
    GU34 3AL Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Wyck Barn
    Wyck
    GU34 3AL Alton
    Hampshire
    EnglandBritishDirector72462640001
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Amministratore
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalianDirector113413330002
    S C F (UK) LIMITED
    90-100 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    Amministratore delegato nominato
    90-100 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    900010870001

    TRANSOFT SOFTWARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 ott 2007
    Consegnato il 15 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 feb 2002
    Consegnato il 01 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael Roy Underwood
    Transazioni
    • 01 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mar 2001
    Consegnato il 05 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents
    Brevi particolari
    Fixed charge on all f/h and l/h property, goodwill, uncalled capital, patents, patent applications, trade marks, trade mark applications, trading names, brand names, service marks, copyrights, rights in the nature of copyright, moral rights, inventions, design rights, registered designs, all trade secrets and know-how, computer rights, programmes, systems, tapes, disks, software, all applications for registration of any of them and other intellectual property rights held or to be held by the company, floating charge over the whole of the property, assets and rights (including uncalled capital) comprised in the property and undertaking of the company.
    Persone aventi diritto
    • Sigma Technology Investments Limited
    Transazioni
    • 05 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental deposit agreement
    Creato il 19 gen 2001
    Consegnato il 25 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date (as defined)
    Brevi particolari
    £10,965.72 deposited in a deposit account with all other sums payable in accordance with clause 1 and 5 of this agreement.
    Persone aventi diritto
    • Insinger Trust (Jersey) Limited
    Transazioni
    • 25 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 gen 1999
    Consegnato il 15 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sigma Technology Management Limited
    • Canada Trust
    • Charles Keene
    • Michael Underwood
    Transazioni
    • 15 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental deposit agreement
    Creato il 16 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brevi particolari
    The sum of £5,000 deposited in a deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel (Channel Islands) Trust Company
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TRANSOFT SOFTWARE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 giu 2010Data di scioglimento
    29 set 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praticante
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Jeremy Simon Spratt
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praticante
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0