RIBBON HOTELS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RIBBON HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03203484 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RIBBON HOTELS LIMITED?
- Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova RIBBON HOTELS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RIBBON HOTELS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LRG HOTELS LIMITED | 26 mag 2005 | 26 mag 2005 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS LIMITED | 16 apr 2003 | 16 apr 2003 |
| SIX CONTINENTS HOTELS LIMITED | 16 lug 2002 | 16 lug 2002 |
| POSTHOUSE HOTELS LIMITED | 06 nov 1996 | 06 nov 1996 |
| POST HOUSES LIMITED | 19 lug 1996 | 19 lug 1996 |
| 865TH SHELF TRADING COMPANY LIMITED | 24 mag 1996 | 24 mag 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RIBBON HOTELS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per RIBBON HOTELS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 17 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 nov 2018 | 16 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Justin Bruce Robinson come amministratore in data 14 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 032034840018 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 22 dic 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Haysmacintyre Company Secretaries Limited il 18 dic 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Thomas Mabry il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Michael Teasdale il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG in data 18 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 032034840016 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 032034840018 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 03 ott 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 30 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 set 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 032034840017 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di RIBBON HOTELS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Segretario | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Segretario | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Segretario | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203652080001 | |||||||||||
| MASON, Timothy Charles | Segretario | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Segretario | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Segretario | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Segretario | Ten Bishops Square E1 6EG London Eighth Floor United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| SISEC LIMITED | Segretario nominato | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||||||
| ALIBONE, Lee Russell | Amministratore | Darnley Lodge 68 Marsh Road HA5 5NQ Pinner Middlesex | British | 53633890001 | ||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Stacey Lee | Amministratore | 46 Chiddingstone Road SW6 3TG London | British | 37682070002 | ||||||||||
| CAU, Antoine Edmond Andre | Amministratore | 10a Durward House 31 Kensington Court S8 5BH London | French | 59395250002 | ||||||||||
| COPELAND, Patrick Joseph | Amministratore | 120 Hamilton Terrace NW8 9UT London | United Kingdom | British | 40574670003 | |||||||||
| CROSTON, Francis John | Amministratore | 5 The Laurels Queenborough Lane CM77 7QD Braintree Essex | United Kingdom | British | 65219360003 | |||||||||
| DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Amministratore | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | 100598030001 | |||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Amministratore | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Amministratore | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| GRATTON, David Martin | Amministratore | Rosemead 9 Chiltern Hills Road HP9 1PJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 71901350002 | ||||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MACKENZIE, Lisa Marie | Amministratore | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | 78059700001 | ||||||||||
| MARTIN, Andrew David | Amministratore | 5 Dalkeith Road AL5 5PP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 52743800001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Amministratore | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Amministratore | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| MITCHELL, Paul Raymond | Amministratore | Waltons Farm Hollygreen Lane HP27 9PL Bledlow Bucks England | England | British | 148147140001 | |||||||||
| MORLEY, Ronald Martin | Amministratore | 8 Pinewood Close SL0 0QT Iver Heath Buckinghamshire | Uk | British | 517180003 | |||||||||
| MORTIMER, David Grant | Amministratore | 8 Manor Park Avenue SP27 9AU Princes Risborough Buckinghamshire | British | 47770480001 | ||||||||||
| NEWMAN, Mark | Amministratore | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PARROTT, Graham Joseph | Amministratore | Flat 1 27 Redington Road Hampstead NW3 7QY London | British | 6741720003 | ||||||||||
| POSTER, Stephen Michael | Amministratore | 46 Boileau Road W5 3AH London | British | 67532380001 | ||||||||||
| PRINCE, Ryan David | Amministratore | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RIBBON HOTELS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nas Cobalt No.2 Limited | 06 apr 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
RIBBON HOTELS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 08 dic 2015 Consegnato il 11 dic 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Holiday inn glasgow airport, caledonian way west, abbotsinch, paisley t/no REN71989. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 03 dic 2015 Consegnato il 09 dic 2015 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 01 dic 2015 Consegnato il 02 dic 2015 | In corso | ||
Breve descrizione L/H holiday inn basildon cranes farm road basildon t/no.EX303185 and EX437596 for more details please refer to the instrument. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 31 mag 2013 Consegnato il 11 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole subjects k/a holiday inn glasgow airport caledonia way west abbotsinch paisley t/n REN71980. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 22 mag 2013 Consegnato il 04 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 22 mag 2013 Consegnato il 03 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione F/H the bybrook tavern (public house) canterbury road ashford t/no K278847, l/h holiday inn cranes farm road basildon t/no’s EX303185 and EX437596, l/h basingstoke crest hotel grove road basingstoke t/no HP409820 (ig lease), for details of further properties charged please refer to the form MR01. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and | Creato il 27 giu 2005 Consegnato il 11 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the tenant's interest in the lease between corporation of the city of glasgow and royal hibernian hotel limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and | Creato il 20 giu 2005 Consegnato il 11 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by an obligor to the senior finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the tenant's interest in the lease between the corporation of the city of glasgow and airport services limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 20 giu 2005 Consegnato il 28 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 giu 2005 Consegnato il 22 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second supplemantal trust deed | Creato il 02 ago 1996 Acquisito il 05 set 1996 Consegnato il 19 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing £200,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of granada group PLC, all further first mortgage debenture stock (together the "stock") and all other amounts payable by granada group PLC | |
Brevi particolari The various properties as listed on the form 400 inclusive of the kensington close, hotal, london and the excelsior, heathrow.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second supplemental trust deed dated 2 august 1996 but having effect on 5 september 1996 | Creato il 02 ago 1996 Consegnato il 19 set 1996 Data dello strumento di garanzia 02 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | ||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 31 gen 1992 Acquisito il 05 set 1996 Consegnato il 13 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,800,000 | |
Brevi particolari All that property at st. Margarets roundabout, southampton road, titchfield, fareham, hampshire together with all hotel buildings thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 ott 1989 Acquisito il 05 set 1996 Consegnato il 13 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,400,000 | |
Brevi particolari All that piece of land at aylesbury in the couity of buckingham having frontage to the london to birmingham trunk road (A41) (including southern boundary hedge) together with hotel buildings thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 mar 1989 Acquisito il 05 set 1996 Consegnato il 13 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,700,000 | |
Brevi particolari All that land situate on the south side od castle street east of commercial road and to the north of railway dock in the city of kingston upon hull together with buildings thereon and k/a the post house hotel t/n HS148908. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 31 ott 1988 Acquisito il 05 set 1996 Consegnato il 13 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,580,000 | |
Brevi particolari All that land and buldings on the west side of the guildford and godalming by-pass guildford in the county of surrey together with all buildings thereon k/a the post house hotel guildford t/n SY546878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 ott 1988 Acquisito il 05 set 1996 Consegnato il 13 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,700,000 | |
Brevi particolari All land and buildings fronting lonon road, maidstone,kenttogether with all buildings k/a the post house hotel maidstone t/n K99811. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 giu 1985 Acquisito il 05 set 1996 Consegnato il 13 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £838,800 | |
Brevi particolari The L.h parcels of land situate at impington in the county of cambridge together with hotel buildings thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
RIBBON HOTELS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0