RIBBON HOTELS LIMITED

RIBBON HOTELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRIBBON HOTELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03203484
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RIBBON HOTELS LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova RIBBON HOTELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RIBBON HOTELS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LRG HOTELS LIMITED26 mag 200526 mag 2005
    INTERCONTINENTAL HOTELS LIMITED 16 apr 200316 apr 2003
    SIX CONTINENTS HOTELS LIMITED16 lug 200216 lug 2002
    POSTHOUSE HOTELS LIMITED06 nov 199606 nov 1996
    POST HOUSES LIMITED19 lug 199619 lug 1996
    865TH SHELF TRADING COMPANY LIMITED24 mag 199624 mag 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di RIBBON HOTELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per RIBBON HOTELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    17 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 nov 2018

    16 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Justin Bruce Robinson come amministratore in data 14 set 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 032034840018 in pieno

    4 pagineMR04

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 22 dic 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 nov 2017

    LRESSP

    Dettagli del segretario cambiati per Haysmacintyre Company Secretaries Limited il 18 dic 2017

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Thomas Mabry il 18 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Michael Teasdale il 18 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 18 dic 2017

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG in data 18 dic 2017

    1 pagineAD01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 032034840016

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 032034840018

    5 pagineMR05

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 03 ott 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 27/09/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 032034840017

    5 pagineMR05

    Chi sono gli amministratori di RIBBON HOTELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Segretario
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4682161
    89121630002
    MABRY, Patrick Thomas
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    LuxembourgGerman204005420001
    TEASDALE, Simon Michael
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish204008350001
    COMBEER, Jean Brenda
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    British50345500001
    ENGMANN, Catherine
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    Segretario
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    British92722710002
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    203652080001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Segretario
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Segretario
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    WILLIAMS, Alison
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    Segretario
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    British78744290002
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Segretario
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4682161
    89121630002
    PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
    Ten Bishops Square
    E1 6EG London
    Eighth Floor
    United Kingdom
    Segretario
    Ten Bishops Square
    E1 6EG London
    Eighth Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04131463
    125623230001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Segretario nominato
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ALIBONE, Lee Russell
    Darnley Lodge 68 Marsh Road
    HA5 5NQ Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Darnley Lodge 68 Marsh Road
    HA5 5NQ Pinner
    Middlesex
    British53633890001
    BAKER, Skardon Francis
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Amministratore
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United KingdomAmerican196342720001
    CARTWRIGHT, Stacey Lee
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    Amministratore
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    British37682070002
    CAU, Antoine Edmond Andre
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    Amministratore
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    French59395250002
    COPELAND, Patrick Joseph
    120 Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    Amministratore
    120 Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    United KingdomBritish40574670003
    CROSTON, Francis John
    5 The Laurels
    Queenborough Lane
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    Amministratore
    5 The Laurels
    Queenborough Lane
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    United KingdomBritish65219360003
    DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish100598030001
    EKAS, Petra Cecilia Maria
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    United KingdomDutch169731050002
    FISH, Andrew John
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish77133450001
    GRATTON, David Martin
    Rosemead
    9 Chiltern Hills Road
    HP9 1PJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Rosemead
    9 Chiltern Hills Road
    HP9 1PJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British71901350002
    KOLEV, Ivaylo
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Amministratore
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    UkBulgarian193389430001
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Amministratore
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish241370450001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Amministratore
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    British78059700001
    MARTIN, Andrew David
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish52743800001
    MCCARTHY, John Patrick
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    Amministratore
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    United States112396050001
    MCEWAN, Allan Scott
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish75569660002
    MITCHELL, Paul Raymond
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    Amministratore
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    EnglandBritish148147140001
    MORLEY, Ronald Martin
    8 Pinewood Close
    SL0 0QT Iver Heath
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Pinewood Close
    SL0 0QT Iver Heath
    Buckinghamshire
    UkBritish517180003
    MORTIMER, David Grant
    8 Manor Park Avenue
    SP27 9AU Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Manor Park Avenue
    SP27 9AU Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British47770480001
    NEWMAN, Mark
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    Amministratore
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    United KingdomCanadian62529820001
    PARROTT, Graham Joseph
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    Amministratore
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    British6741720003
    POSTER, Stephen Michael
    46 Boileau Road
    W5 3AH London
    Amministratore
    46 Boileau Road
    W5 3AH London
    British67532380001
    PRINCE, Ryan David
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomCanadian85682450077

    Chi sono le persone con controllo significativo di RIBBON HOTELS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04160938
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RIBBON HOTELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 dic 2015
    Consegnato il 11 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Holiday inn glasgow airport, caledonian way west, abbotsinch, paisley t/no REN71989.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent)
    Transazioni
    • 11 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 dic 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 05 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 dic 2015
    Consegnato il 09 dic 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent))
    Transazioni
    • 09 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 set 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 01 dic 2015
    Consegnato il 02 dic 2015
    In corso
    Breve descrizione
    L/H holiday inn basildon cranes farm road basildon t/no.EX303185 and EX437596 for more details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent))
    Transazioni
    • 02 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 set 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 18 dic 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 11 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole subjects k/a holiday inn glasgow airport caledonia way west abbotsinch paisley t/n REN71980. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch for Itself and as Security Trustee for the Common Secured Parties
    Transazioni
    • 11 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 04 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch for Itself and as Security Trustee for the Common Secured Parties
    Transazioni
    • 04 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 03 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H the bybrook tavern (public house) canterbury road ashford t/no K278847, l/h holiday inn cranes farm road basildon t/no’s EX303185 and EX437596, l/h basingstoke crest hotel grove road basingstoke t/no HP409820 (ig lease), for details of further properties charged please refer to the form MR01. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutshce Bank Ag, London Branch (The Common Security Agent)
    Transazioni
    • 03 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 set 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 04 nov 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 02 dic 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 07 apr 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 11 giu 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 03 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and
    Creato il 27 giu 2005
    Consegnato il 11 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the tenant's interest in the lease between corporation of the city of glasgow and royal hibernian hotel limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited Acting as Security Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transazioni
    • 11 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 11 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by an obligor to the senior finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the tenant's interest in the lease between the corporation of the city of glasgow and airport services limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited Acting as Security Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transazioni
    • 11 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 28 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 22 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 set 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second supplemantal trust deed
    Creato il 02 ago 1996
    Acquisito il 05 set 1996
    Consegnato il 19 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £200,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of granada group PLC, all further first mortgage debenture stock (together the "stock") and all other amounts payable by granada group PLC
    Brevi particolari
    The various properties as listed on the form 400 inclusive of the kensington close, hotal, london and the excelsior, heathrow.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 19 set 1996Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental trust deed dated 2 august 1996 but having effect on 5 september 1996
    Creato il 02 ago 1996
    Consegnato il 19 set 1996
    Data dello strumento di garanzia 02 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 19 set 1996Registrazione di un onere per garantire una serie di obbligazioni (397)
    • 18 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1992
    Acquisito il 05 set 1996
    Consegnato il 13 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,800,000
    Brevi particolari
    All that property at st. Margarets roundabout, southampton road, titchfield, fareham, hampshire together with all hotel buildings thereon.
    Persone aventi diritto
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Hotel Fund Limited)
    Transazioni
    • 13 set 1996Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 ott 1989
    Acquisito il 05 set 1996
    Consegnato il 13 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,400,000
    Brevi particolari
    All that piece of land at aylesbury in the couity of buckingham having frontage to the london to birmingham trunk road (A41) (including southern boundary hedge) together with hotel buildings thereon.
    Persone aventi diritto
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transazioni
    • 13 set 1996Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1989
    Acquisito il 05 set 1996
    Consegnato il 13 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,700,000
    Brevi particolari
    All that land situate on the south side od castle street east of commercial road and to the north of railway dock in the city of kingston upon hull together with buildings thereon and k/a the post house hotel t/n HS148908.
    Persone aventi diritto
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transazioni
    • 13 set 1996Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1988
    Acquisito il 05 set 1996
    Consegnato il 13 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,580,000
    Brevi particolari
    All that land and buldings on the west side of the guildford and godalming by-pass guildford in the county of surrey together with all buildings thereon k/a the post house hotel guildford t/n SY546878.
    Persone aventi diritto
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transazioni
    • 13 set 1996Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 ott 1988
    Acquisito il 05 set 1996
    Consegnato il 13 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,700,000
    Brevi particolari
    All land and buildings fronting lonon road, maidstone,kenttogether with all buildings k/a the post house hotel maidstone t/n K99811.
    Persone aventi diritto
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transazioni
    • 13 set 1996Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 giu 1985
    Acquisito il 05 set 1996
    Consegnato il 13 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £838,800
    Brevi particolari
    The L.h parcels of land situate at impington in the county of cambridge together with hotel buildings thereon.
    Persone aventi diritto
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transazioni
    • 13 set 1996Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RIBBON HOTELS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 nov 2017Inizio della liquidazione
    17 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Harvey Dean
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0