POWERMARQUE LIMITED

POWERMARQUE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPOWERMARQUE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03204406
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di POWERMARQUE LIMITED?

    • (5010) /
    • (5020) /

    Dove si trova POWERMARQUE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di POWERMARQUE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NEVRUS (680) LIMITED28 mag 199628 mag 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di POWERMARQUE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2004

    Quali sono le ultime deposizioni per POWERMARQUE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagine652a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 giu 2004

    19 pagineAA

    legacy

    3 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363s

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di POWERMARQUE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAMES, Graham Philip
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    Segretario
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    English94987030001
    LAWSON SMITH, Clive
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    Segretario
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    British72186210005
    JAMES, Graham Philip
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    Amministratore
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    United KingdomEnglish94987030001
    VENSON GROUP PLC
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    Amministratore
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    119183190001
    VENSON HOLDINGS LIMITED
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    Amministratore
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    116764790001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    LAW, Stuart Peter
    3 Oakwood Court
    Gordon Road
    E4 6BX Chingford
    London
    Segretario nominato
    3 Oakwood Court
    Gordon Road
    E4 6BX Chingford
    London
    British900005090001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Amministratore
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Amministratore
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    DALY, James
    22 Derwent Close
    Little Chalfont
    HP7 9PG Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    22 Derwent Close
    Little Chalfont
    HP7 9PG Amersham
    Buckinghamshire
    British62710230001
    DICKINSON, Roger Martin
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    Amministratore
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    British91579530001
    DOONEY, Michael Martin
    Greenstones Hall
    IRISH Glandore
    Co Cork
    Ireland
    Amministratore
    Greenstones Hall
    IRISH Glandore
    Co Cork
    Ireland
    Irish68419160001
    DUNNE, Matthew
    14 Coulson Way
    Alconbury
    PE28 4WU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    14 Coulson Way
    Alconbury
    PE28 4WU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British80391440001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    Amministratore
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    Amministratore
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    GIBBONS, David Victor
    Briarfields
    Plough Corner
    CO16 9LU Little Clacton
    Essex
    Amministratore delegato nominato
    Briarfields
    Plough Corner
    CO16 9LU Little Clacton
    Essex
    British900005080001
    LAWSON SMITH, Clive
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    Amministratore
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    British72186210005
    MELLOR, Christopher John
    Redoaks
    Redoaks Hill
    CB10 2LY Ashdon
    Essex
    Amministratore
    Redoaks
    Redoaks Hill
    CB10 2LY Ashdon
    Essex
    United KingdomUk97680390001
    PETTIFOR, Timothy John
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish40366940001
    SCRIVEN, Grant John Paul
    Drury House Pitch Hill
    GU6 7NN Ewhurst
    Surrey
    Amministratore
    Drury House Pitch Hill
    GU6 7NN Ewhurst
    Surrey
    United KingdomIrish28260840002
    WATSON, Charles Dishington
    245 Hillmorton Road
    CV22 5BE Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    245 Hillmorton Road
    CV22 5BE Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish41054110001
    WILLIAMSON, Alister Wallace
    Brendons Church Road
    GU20 6BT Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Brendons Church Road
    GU20 6BT Windlesham
    Surrey
    British29612530001

    POWERMARQUE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Account charge
    Creato il 07 ott 2004
    Consegnato il 20 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the deposit and all the entitlements to interest the rights to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 19 dic 2003
    Consegnato il 09 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the goods, vehicles and equipment details of which are set our in the sale afgreement, together with the operating instructions, handbooks, specifications and books pertaining thereto and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same and the full benefit of all warranties and maintenance contracts in relation thereto.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Lease UK Limited
    Transazioni
    • 09 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security assignment
    Creato il 19 dic 2003
    Consegnato il 09 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right, title, benefit and interest, present and future, under or arising out of or in respect of the relevant agreements; in, to and in respect of the vehicles the subject of the relevant agreements; in, to and in respect of all and any proceeds of claims made under the insurance in respect of the vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Lease UK Limited
    Transazioni
    • 09 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0